BALDERTON BANBURY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBALDERTON BANBURY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05429527
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BALDERTON BANBURY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    BALDERTON BANBURY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    105 Wigmore Street
    W1U 1QY London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BALDERTON BANBURY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    KENMORE BANBURY LIMITED০৩ নভে, ২০০৫০৩ নভে, ২০০৫
    SOUTHLEVEL LIMITED১৯ এপ্রি, ২০০৫১৯ এপ্রি, ২০০৫

    BALDERTON BANBURY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৩

    BALDERTON BANBURY LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    BALDERTON BANBURY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩১ ডিসে, ২০১৩ তারিখে Richard Bruce Mitchell-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ সেপ, ২০১৪ তারিখে Mr Andrew John Pettit-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ সেপ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 20 Balderton Street London W1K 6TL থেকে 105 Wigmore Street London W1U 1QYপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ এপ্রি, ২০১৪

    ২২ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠাMG01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠাMG01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed kenmore banbury LIMITED\certificate issued on 21/07/10
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২১ জুল, ২০১০

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৩ জুল, ২০১০

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    পরিচালক হিসাবে William James Killick-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Lee Maytum-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে James Cairns এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Henry James Angell-James-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    BALDERTON BANBURY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MITCHELL, Richard Bruce
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    সচিব
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    British152314650001
    ANGELL-JAMES, Henry James
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    পরিচালক
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    United KingdomBritish152314900001
    KILLICK, William James
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    পরিচালক
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    UkBritish152751860001
    MAYTUM, Lee Trevor
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    পরিচালক
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    United KingdomBritish115467570001
    PETTIT, Andrew John
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    EnglandBritish62947400004
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    সচিব
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    সচিব
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    পরিচালক
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    পরিচালক
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    পরিচালক
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    CAIRNS, James Scott
    58 Davies Street
    London
    W1K 5JF
    পরিচালক
    58 Davies Street
    London
    W1K 5JF
    United KingdomBritish33041530004
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    পরিচালক
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    ROBSON, Ronald Alexander
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    পরিচালক
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish104673590001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    পরিচালক
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    BALDERTON BANBURY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Account pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০১৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its present future conditional and unconditional claims rights title and interest arising from or in relation to all of its bank accounts including any sub-account renewal resignation or replacement. Farnborough support account hsh nordbank ag 1200017427, rent account hsh nordbank ag 1200015521, sale proceeds account hsh nordbank ag 1200015537.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank Ag
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Account assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from teach obligor and he company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    With full title guarantee assigned to the agent its present and future rights and interest in the account designated farnborough support account with a/c no. 44523903 see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank London Branch
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0