OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05685937
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Prospect House
    108 High Street
    HP16 0BG Great Missenden
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    THE PRACTICE (GROUP) LIMITED২৪ নভে, ২০১৪২৪ নভে, ২০১৪
    THE PRACTICE (GROUP) PLC২৪ নভে, ২০১৪২৪ নভে, ২০১৪
    THE PRACTICE PLC১৫ নভে, ২০০৭১৫ নভে, ২০০৭
    PRACTICE NETWORKS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY০৭ সেপ, ২০০৬০৭ সেপ, ২০০৬
    PRACTICE NETWORKS HOLDINGS LIMITED২৪ জানু, ২০০৬২৪ জানু, ২০০৬

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০২৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২৪

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২৪ জানু, ২০২৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে০৭ ফেব, ২০২৬
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২৪ জানু, ২০২৫
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    legacy

    2 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,466,796
    3 পৃষ্ঠাSH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    resolution

    ক্যাপিটালাইজেশন বা শেয়ার বোনাস ইস্যুর রেজুলেশন

    Re: capitalise a sum not exceeding £2,000,000 standing to the credit of the company's capital contribution reserve, and to apply such sum in paying up in full 2,000,000 ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company ("bonus shares"); 26/03/2025
    RES14
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    59 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium account reduced 26/03/2025
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    চার্জ নিবন্ধন 056859370010, ০৭ ফেব, ২০২৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    26 পৃষ্ঠাMR01

    ২৪ জানু, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০২৩ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০৬ মে, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Rose House Bell Lane Office Village Bell Lane Little Chalfont Amersham Buckinghamshire HP6 6FA England থেকে Prospect House 108 High Street Great Missenden HP16 0BGপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elizabeth Mary Louise Perry এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    9 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    চার্জ নিবন্ধন 056859370008, ০৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    25 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ নিবন্ধন 056859370009, ০৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    19 পৃষ্ঠাMR01

    ২৪ জানু, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Exemption from preparing consolidated financial statements 23/11/2023
    RES13

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    53 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    2 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HARDING, Nicholas John
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Medical Officer69757370002
    MCKENZIE-BOYLE, Edward Charles Albert
    Bell Lane
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    England
    পরিচালক
    Bell Lane
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    England
    EnglandBritishChief Finance Officer279595260001
    GODRICH, Francine
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    সচিব
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    169033180001
    GODRICH, Toby Alexander Arthur
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    সচিব
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    193062090001
    HAMILL, William John
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    সচিব
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    165107730001
    HENDRIE, Neal Malcolm
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane, Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Anglo House
    Bucks
    United Kingdom
    সচিব
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane, Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Anglo House
    Bucks
    United Kingdom
    154289210001
    HUMPHREY, Shelley
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane, Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Anglo House
    Bucks
    United Kingdom
    সচিব
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane, Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Anglo House
    Bucks
    United Kingdom
    162334750001
    MILLEN, Karen Kai-Ling
    The Lagger
    HP8 4DG Chalfont St. Giles
    14
    Buckinghamshire
    সচিব
    The Lagger
    HP8 4DG Chalfont St. Giles
    14
    Buckinghamshire
    British129024530001
    QUIBELL, John Boyd
    16 Balaclava Road
    KT6 5PN Surbiton
    Surrey
    সচিব
    16 Balaclava Road
    KT6 5PN Surbiton
    Surrey
    British61281750001
    BAILES, Caroline Michelle
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer265426770001
    BERKOVSKY, Wesley Paul
    c/o Wesley Berkovsky
    Plaza De Colon No 2
    Torre 1 Floor 11
    28046 Madrid
    Primerosalud
    Spain
    পরিচালক
    c/o Wesley Berkovsky
    Plaza De Colon No 2
    Torre 1 Floor 11
    28046 Madrid
    Primerosalud
    Spain
    SpainUnited States Of AmericaBusiness Executive196904020001
    BLACK, Alexander Dickson
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant Icas1249610002
    BRINKLEY, Cynthia Jane
    Forsyth Blvd
    St Louis
    7700
    Mo, 63108
    Usa
    পরিচালক
    Forsyth Blvd
    St Louis
    7700
    Mo, 63108
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Executive229337300001
    CHAN, Arvan See Wing
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    United StatesAmericanBusiness Executive204520890001
    CHAN, Arvan See Wing
    Forsyth Blvd
    St Louis
    7700
    Mo, 63105
    Usa
    পরিচালক
    Forsyth Blvd
    St Louis
    7700
    Mo, 63105
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Executive204520890001
    CLOTHIER, Christopher Gurth
    Flat X 12-18 Bloomsbury Street
    WC1B 3QA London
    পরিচালক
    Flat X 12-18 Bloomsbury Street
    WC1B 3QA London
    BritishVenture Capitalist124798730001
    DAVIES, Stephen John
    Netherby, 79 Green End Road
    Boxmoor
    HP1 1QW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Netherby, 79 Green End Road
    Boxmoor
    HP1 1QW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector122432320001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant129305300001
    FORDYCE, Stuart Alistair
    Hilltop Fox Road
    Wigginton
    HP23 6EE Tring
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Hilltop Fox Road
    Wigginton
    HP23 6EE Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant41000600001
    FULLAGAR, Paul George
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector97684870002
    HASTINGS, Roy
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer130098430001
    HENDRIE, Neal Malcolm
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane, Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Anglo House
    Bucks
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane, Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Anglo House
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director40848270002
    HOPKINS, Thomas William
    Coningham Road
    W12 8BU London
    119
    পরিচালক
    Coningham Road
    W12 8BU London
    119
    EnglandBritishVenture Capitalist131203930001
    JOHNSON, Allan
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector159246050001
    JONES, Samantha Geraldine
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishChief Executive217161070001
    KADIRGAMAR, Ajit Gordon Vimalendran, Dr
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector97159510001
    KADIRGAMAR, Ajit Gordon Vimalendran, Dr
    Presnor, Windsor Lane
    HP16 0DZ Little Kingshill
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Presnor, Windsor Lane
    HP16 0DZ Little Kingshill
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector97159510001
    LEWIS, Jonathan Simon Oliver
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishCeo162966300002
    MACFARLANE, Bruce Ferguson
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishVenture Capitalist55760240001
    MACFARLANE, Bruce Ferguson
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishVenture Capitalist55760240001
    MACFARLANE, Bruce Ferguson
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishVenture Capitalist55760240001
    O'CONNOR, Brian Damian
    Thie Ny Strooan
    Hillberry Green
    IM2 6DE Douglas
    Isle Of Man
    পরিচালক
    Thie Ny Strooan
    Hillberry Green
    IM2 6DE Douglas
    Isle Of Man
    BritishCompany Director144823180001
    PERRY, Elizabeth Mary Louise
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Bell Lane Office Village
    Bell Lane Little Chalfont
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector281527690001
    RAVEN, Deborah Jane
    Lewins Road
    Chalfont St. Peter
    SL9 8SA Gerrards Cross
    Old Stocks
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Lewins Road
    Chalfont St. Peter
    SL9 8SA Gerrards Cross
    Old Stocks
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director Nurse192809810001
    RHODES, Shaun Andrew
    29 Lakes Lane
    HP9 2LA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    29 Lakes Lane
    HP9 2LA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishAccountant148621070001

    OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Operose Health Ltd
    New Cavendish Street
    W1W 6XB London
    77
    England
    ১৭ ডিসে, ২০২১
    New Cavendish Street
    W1W 6XB London
    77
    England
    না
    আইনি ফর্মCompany Limited By Shares
    আইনি কর্তৃপক্ষEnglish Law
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Mh Services International (Uk) Limited
    Cavendish Square
    W1G 0AN London
    11-13
    England
    ১৬ মার্চ, ২০১৮
    Cavendish Square
    W1G 0AN London
    11-13
    England
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland And Wales
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Centene Uk Limited
    Bell Lane
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    England
    ২৭ এপ্রি, ২০১৬
    Bell Lane
    HP6 6FA Amersham
    Rose House
    England
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2015 United Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House, United Kingdome
    নিবন্ধন নম্বর10014577
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0