EVOLVE ENERGY LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEVOLVE ENERGY LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05831752
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EVOLVE ENERGY LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন (43210) / নির্মাণ

    EVOLVE ENERGY LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Cheshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EVOLVE ENERGY LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৮

    EVOLVE ENERGY LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ০৩ মে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nathan Sanders-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১২ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Peter Bradley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১২ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Aled Robert Humphreys এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০১ ফেব, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ সেপ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Brian Dominic Sharma-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ১৮ সেপ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Archie Stuart Waddell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০১ ফেব, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ জুল, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Brian Dominic Sharma এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৫ জুল, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Archie Stuart Waddell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০১ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Mcphillimy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১১ মে, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Brian Dominic Sharma-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ১১ মে, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Veronica Mary Niven এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ মার্চ, ২০১৬

    ০৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 29,999,964.76
    SH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Richard Brinsley Sheridan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১২ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Aled Robert Humphreys-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জুল, ২০১৫

    ০২ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 29,999,964.76
    SH01

    দ্বিতীয় দায়ের AR01 এর যা পূর্বে কোম্পানিজ হাউসে জমা দেওয়া হয়েছিল ২১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে

    16 পৃষ্ঠাRP04

    EVOLVE ENERGY LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHARMA, Brian Dominic
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    সচিব
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    250773850001
    BRADLEY, Peter
    Ocean Court
    Caspian Road, Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Sse Enterprise Energy Solutions
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ocean Court
    Caspian Road, Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Sse Enterprise Energy Solutions
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75211210001
    GREENHORN, Kevin David Andrew
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    ScotlandBritish145709970001
    SANDERS, Nathan
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    পরিচালক
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    EnglandBritish150936520002
    BUDD, Gerald Lance
    Manston Road
    GU4 7YE Guildford
    4
    Surrey
    সচিব
    Manston Road
    GU4 7YE Guildford
    4
    Surrey
    British20717760001
    LOCHERY, Anthony Francis
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    170751860001
    NIVEN, Veronica Mary
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    সচিব
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    190141550001
    PARKE, Gary
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    সচিব
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British118299620001
    SCHNEIDER, Tim
    Citra Barn Frizers Farm
    Sonning Eye
    RG4 6TN Reading
    Berkshire
    সচিব
    Citra Barn Frizers Farm
    Sonning Eye
    RG4 6TN Reading
    Berkshire
    Canadian117731640001
    SHARMA, Brian Dominic
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    208039170001
    TOPP, Janice Susan
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    সচিব
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    Other139112080001
    WADDELL, Archie Stuart
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    সচিব
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    234996520001
    DUPORT SECRETARY LIMITED
    2 Southfield Road
    BS9 3BH Westbury On Trym
    The Bristol Office
    Bristol
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    2 Southfield Road
    BS9 3BH Westbury On Trym
    The Bristol Office
    Bristol
    900020060001
    BAETZ, Michael
    161 Bay Street, Suite 4540
    PO BOX 709
    M5J2S1 Toronto
    Canada Trust Tower
    Ontario
    Canada
    পরিচালক
    161 Bay Street, Suite 4540
    PO BOX 709
    M5J2S1 Toronto
    Canada Trust Tower
    Ontario
    Canada
    CanadaCanadian166562600001
    FRIGHT, Neil Grant
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish165864840002
    HIGGINS, Vanessa Claire
    Denchworth
    OX12 0DX Wantage
    Denchworth Manor
    Oxfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Denchworth
    OX12 0DX Wantage
    Denchworth Manor
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish139427570001
    HILLMAN, Christopher Michael
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish17572470002
    HUMPHREYS, Aled Robert
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    পরিচালক
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish200150330001
    LOCHERY, Anthony Francis
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish18996670003
    MCPHILLIMY, James
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish94397700001
    NIVEN, Veronica Mary
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish173743440001
    PARKE, Gary
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British118299620001
    ROTHERHAM, David Scott
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish146140260002
    SCHNEIDER, Timothy John
    Wyatt Close
    Wargrave
    RG10 8EB Reading
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wyatt Close
    Wargrave
    RG10 8EB Reading
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadian150003200001
    SHERIDAN, Richard Brinsley
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    পরিচালক
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish192888360001
    SHERIDAN, Richard Brinsley
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish192888360001
    SHLESINGER, Joseph Charles
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    পরিচালক
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    CanadaCanadian139607450001
    SOPER, Daniel
    20 Grey Road
    Toronto
    Ontario M5m 4ez
    Canada
    পরিচালক
    20 Grey Road
    Toronto
    Ontario M5m 4ez
    Canada
    Canadian117597800001
    STEVENSON, Lawrence Napier
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    পরিচালক
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    CanadaCanadian131305220002
    TENNENT, Colin Robert
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    পরিচালক
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    EnglandBritish23661940005
    DUPORT DIRECTOR LIMITED
    2 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BH Bristol
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    2 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BH Bristol
    900020050001

    EVOLVE ENERGY LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর07187066
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    EVOLVE ENERGY LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC (T/a Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১০ ফেব, ২০১৫সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bbtps L.P
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ নভে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Centric Spv 1 Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৮ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Pledge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £850,000.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Share capital in ashdown control services limited. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Peter Brian Lovering, Nigel John Burnett, Sue Lovering and John Quinn
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0