CHURCHILLS HOMES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCHURCHILLS HOMES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05896043
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য নির্মাণ ইনস্টলেশন (43290) / নির্মাণ

    CHURCHILLS HOMES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    93 Tabernacle Street
    EC2A 4BA London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MAYFLY HOMES LIMITED০৩ আগ, ২০০৬০৩ আগ, ২০০৬

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ আগ, ২০১৬
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মে, ২০১৭
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০১৫

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৩ আগ, ২০১৮
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৭ আগ, ২০১৮
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৩ আগ, ২০১৭
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ০১ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে Michael George Phare-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ সেপ, ২০১৯ তারিখে Michael George Phare-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ সেপ, ২০১৯ তারিখে Mr Michael George Phare-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৩ অক্টো, ২০১৯ তারিখে Mr Alan Geoffrey Saville-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে Mr Michael George Phare-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৯ জানু, ২০২১ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Eagle House C/O Ramon Lee & Partners 167 City Road London EC1V 1AW England থেকে 93 Tabernacle Street London EC2A 4BAপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    ০৩ আগ, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৩ আগ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2DW থেকে Eagle House C/O Ramon Lee & Partners 167 City Road London EC1V 1AWপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০৩ আগ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ নিবন্ধন 058960430012, ০৪ ডিসে, ২০১৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    23 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ নিবন্ধন 058960430011, ০৪ ডিসে, ২০১৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    7 পৃষ্ঠাMR01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ সেপ, ২০১৫

    ১৮ সেপ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ আগ, ২০১৪

    ১৩ আগ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    চার্জ নিবন্ধন 058960430010, ১৮ জুল, ২০১৪ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    7 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ নিবন্ধন 058960430009

    26 পৃষ্ঠাMR01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০২ জুল, ২০১৪This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PHARE, Michael George
    6 Madeira Villas
    Whitchurch Road
    PL20 7TZ Horrabridge
    Meadow Sweet
    Elverton
    United Kingdom
    সচিব
    6 Madeira Villas
    Whitchurch Road
    PL20 7TZ Horrabridge
    Meadow Sweet
    Elverton
    United Kingdom
    BritishDirector103982400001
    PHARE, Michael George
    Crabtree Close
    PL3 6EL Plymouth
    11a
    Devon
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crabtree Close
    PL3 6EL Plymouth
    11a
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector103982400003
    SAVILLE, Alan Geoffrey
    Vickers Close
    Upper Longcross
    KT16 0BZ Chertsey
    6
    Surrey
    United Kingdom
    পরিচালক
    Vickers Close
    Upper Longcross
    KT16 0BZ Chertsey
    6
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector18241320010
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BRETT PHARE, Jennifer Anne
    Mayfield Lower Sandhurst Road
    Finchampstead
    RG40 3TH Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    Mayfield Lower Sandhurst Road
    Finchampstead
    RG40 3TH Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishDirector41130910002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Mr Alan Geoffrey Saville
    Tabernacle Street
    EC2A 4BA London
    93
    ৩০ জুন, ২০১৬
    Tabernacle Street
    EC2A 4BA London
    93
    না
    জাতীয়তা: British
    বাসস্থানের দেশ: England
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ২৫% এর বেশি কিন্তু ৫০% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।
    Mr Michael George Phare
    Tabernacle Street
    EC2A 4BA London
    93
    ৩০ জুন, ২০১৬
    Tabernacle Street
    EC2A 4BA London
    93
    না
    জাতীয়তা: British
    বাসস্থানের দেশ: England
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ২৫% এর বেশি কিন্তু ৫০% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।

    CHURCHILLS HOMES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০১৫
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold land k/a 32A butts road alton title no HP437965.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Manford Securities and Investments Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০১৫
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage all legal interest in 32A butts road alton hampshire GU34 1NB land registry no. HP437965.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুল, ২০১৪
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Four marks service station 148-154 winchester road four marks GU34 5HZ land registry title number SH11198.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুল, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ২০১৪
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 148-154 winchester road four marks alton hampshire t/no SH11198.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Manford Securities & Investments Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land lying to the north of "none go by" hill lane, kingswood, tadworth t/no SY770428.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Edward Webster & Tammy Webster
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land lying to the north of none go by hill lane kingswood tadworth t/n SY770428, by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    149 fleet road cove farnborough hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Amber lodge springfield road camberley surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুল, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    23 frogmore road blackwater camberley surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    21 frogmore road blackwater cambola surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    51 purley bury close, purley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0