TIDE2 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTIDE2 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05977421
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TIDE2 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শদাতা কার্যক্রম (62020) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    TIDE2 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o CLAIRE SMITH
    The Sage Group Plc
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TIDE2 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HALLCO 1389 LIMITED২৫ অক্টো, ২০০৬২৫ অক্টো, ২০০৬

    TIDE2 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৪

    TIDE2 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    TIDE2 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ নভে, ২০১৫

    ১৯ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ১৮ নভে, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH থেকে C/O Claire Smith the Sage Group Plc North Park Newcastle upon Tyne NE13 9AAপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ৩০ জুল, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা North Park Newcastle-upon-Tyne Tyne & Wear NE13 9AA থেকে 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QHপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৩ জুল, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠা4.70

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২৪ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel capital redemption reserve 22/06/2015
    RES13

    ১৮ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Mark Parry-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alastair John Mitchell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ অক্টো, ২০১৪

    ৩০ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ৩১ জুল, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Mark Parry-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ৩১ জুল, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Louise Hall এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩১ অক্টো, ২০১৩

    ৩১ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed hallco 1389 LIMITED\certificate issued on 09/05/13
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name০৯ মে, ২০১৩

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ৩০ এপ্রি, ২০১৩

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Brendan Peter Flattery-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    TIDE2 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PARRY, Mark
    c/o Claire Smith
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    The Sage Group Plc
    England
    সচিব
    c/o Claire Smith
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    The Sage Group Plc
    England
    190491450001
    FLATTERY, Brendan Peter
    c/o Claire Smith
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    The Sage Group Plc
    England
    পরিচালক
    c/o Claire Smith
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    The Sage Group Plc
    England
    United KingdomBritishManaging Director168203410001
    PARRY, Mark
    c/o Claire Smith
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    The Sage Group Plc
    England
    পরিচালক
    c/o Claire Smith
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    The Sage Group Plc
    England
    United KingdomBritishSolicitor198658460001
    HALL, Louise
    Beechgrove
    Acklington
    NE65 9BY Morpeth
    Northumberland
    সচিব
    Beechgrove
    Acklington
    NE65 9BY Morpeth
    Northumberland
    BritishCompany Secretary77212940004
    MERCER, Jane
    2 Corner Brook
    Lostock
    BL6 4GX Bolton
    Lancashire
    সচিব
    2 Corner Brook
    Lostock
    BL6 4GX Bolton
    Lancashire
    BritishSecretary109573410001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    পরিচালক
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritishDirector97291590001
    MAY, Gavin Disney
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector85874690001
    MCFARLAND, Adrienne Ann
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishHuman Resources Director125854290002
    MERCER, Jane
    2 Corner Brook
    Lostock
    BL6 4GX Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    2 Corner Brook
    Lostock
    BL6 4GX Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishSecretary109573410001
    MITCHELL, Alastair John
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector79762180002
    STOBART, Paul Lancelot
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    NE13 9AA Newcastle-Upon-Tyne
    North Park
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector175694060001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    কর্পোরেট পরিচালক
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    113594180001

    TIDE2 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other charging company and any other present or future subsidiary of the parent or of any charging company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Inflexion Private Equity Partners LLP (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment by way of charge over deposit securing variable rate secured e loan notes
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee assigns to the security trustee the deposit subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Richard Beaton (An Individual)
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment by way of charge over deposit securing variable rate secured f loan notes
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee assigns to the security trustee the deposit subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jane Mercer (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Richard Beaton (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the charging company, each guarantor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jane Mercer (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    TIDE2 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৭ জুন, ২০১৬ভেঙে গেছে
    ১৩ জুল, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Brian Green
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    অভ্যাসকারী
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0