KBC CHISWICK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামKBC CHISWICK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05992192
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    KBC CHISWICK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব রিয়েল এস্টেট কেনাবেচা (68100) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    KBC CHISWICK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    268 Bath Road
    SL1 4DX Slough
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    KBC CHISWICK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    KBC CHISWICK LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    KBC CHISWICK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ১০ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Peter David Edward Gibson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Richard Morris-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Marie Elizabeth Edwards এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২২ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 Lyric Square London W6 0NB England থেকে 268 Bath Road Slough SL1 4DXপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১০ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael James Kingshott এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    চার্জ 6 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 22 Long Acre London WC2E 9LY থেকে 268 Bath Road Slough SL1 4DXপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ নভে, ২০১৪

    ২০ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 22 Long Acre London WC2E 9LY United Kingdom থেকে 20 Hanover Square London W1S 1JY এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ ডিসে, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Mrs Marie Elizabeth Edwards-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ১৮ ডিসে, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Paul Alexander এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ নভে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৭ অক্টো, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Alexander-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৭ অক্টো, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Alan Douglas Pepper-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৭ অক্টো, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Paul Alexander-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    ১৭ অক্টো, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elizabeth Jane Scannell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৭ অক্টো, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Elizabeth Jane Scannell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Restatement agreement 07/08/2013
    RES13

    KBC CHISWICK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    পরিচালক
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    GIBSON, Peter David Edward
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    পরিচালক
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    MORRIS, Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    পরিচালক
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish190653350001
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    পরিচালক
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    ALEXANDER, Paul
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    সচিব
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183163800001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    সচিব
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    সচিব
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    185429750001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    সচিব
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    সচিব
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    152617650002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    CORPET, Antoine
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    পরিচালক
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    French131276650001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    পরিচালক
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritish76547250001
    KINGSHOTT, Michael James
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    পরিচালক
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish83713020002
    PETRIE, Roderick Mckenzie
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    পরিচালক
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    ScotlandBritish1246700004
    ROWBOTTOM, Alex James
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    পরিচালক
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    British135706810001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    পরিচালক
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish154659960001
    TASCHLER, Jeffery
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    পরিচালক
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    United States135708370001
    WAKELIN, James David
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    পরিচালক
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    British92221010001
    WASHINGTON, Robert Francis
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    পরিচালক
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    Australian120776550001

    KBC CHISWICK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Turnham green terrace, london t/no AGL193916. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৪ মে, ২০১৩সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ১৬ ডিসে, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Turnham green terrace, london t/no AGL193916 see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৪ মে, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ১৬ ডিসে, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ নভে, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • West Register Number 2 Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ নভে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৪ মে, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ১৬ ডিসে, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of substituted security relating to legal charge dated 9 may 2007
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Upperparts gable house 18-28 turnham green terrace london t/no AGL190117 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুন, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property more fully detailed within the deed of variation of lease of premises at upper parts of gable house, 18-22 turnham green terrace, london fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a upper parts of gable house 18-28 turnham green terrace london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0