PENINA 251 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPENINA 251 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 06027492
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PENINA 251 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (41201) / নির্মাণ
    • নিজস্ব রিয়েল এস্টেট কেনাবেচা (68100) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    PENINA 251 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    CURRIE YOUNG LIMITED
    Alexander House Waers Edge Business Park Campbell Road
    ST4 4DB Stoke On Trent
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PENINA 251 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৪

    PENINA 251 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    15 পৃষ্ঠাLIQ14

    ২০ জুল, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    15 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২০ জুল, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    15 পৃষ্ঠাLIQ03

    স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটর হিসাবে কাজ বন্ধ করার নোটিশ

    17 পৃষ্ঠা4.40

    ২০ জুল, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    15 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৩ জানু, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Currie Young Ltd the Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane Stoke-on-Trent Staffordshire ST3 6HP থেকে Alexander House Waers Edge Business Park Campbell Road Stoke on Trent ST4 4DBপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ১৫ সেপ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 17 Alvaston Business Park Middlewich Road Nantwich Cheshire CW5 6PF থেকে C/O Currie Young Ltd the Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane Stoke-on-Trent Staffordshire ST3 6HPপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    5 পৃষ্ঠা4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন ২১ জুল, ২০১৬ তারিখে

    LRESEX

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০১৫ থেকে ২৯ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ জানু, ২০১৬

    ০৭ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 120
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ ডিসে, ২০১৪

    ২৩ ডিসে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 120
    SH01

    ১০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Neil John Duncan Lamont-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ জানু, ২০১৪

    ২৪ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 120
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ১৪ ফেব, ২০১১ তারিখে Mr Simon Chantler-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mrs Melanie Suzanne Chantler-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    PENINA 251 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CHANTLER, Melanie Suzanne
    Stretton
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Stretton Hall Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Stretton
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Stretton Hall Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    159985730001
    CHANTLER, Melanie Suzanne
    Stretton
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Stretton Hall Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Stretton
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Stretton Hall Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector51710220001
    CHANTLER, Simon
    Stretton
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Stretton Hall Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Stretton
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Stretton Hall Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95498410001
    LAMONT, Neil John Duncan
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8BD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8BD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector90161100006
    MCNAMEE, William Mark
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    IrishSurveyor108602480001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    LAMONT, Neil John Duncan
    Nantwich Court
    Hospital Street
    CW5 5RH Nantwich
    Cheshire
    পরিচালক
    Nantwich Court
    Hospital Street
    CW5 5RH Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritishSurveyor118030900001
    MCNAMEE, William Mark
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishSurveyor108602480001
    RODGERS, Mark
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector74868060003
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    PENINA 251 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge on deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Account number 27539613 see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings on the north west side of clywedog road soutt wrexham t/n WA797728 and f/h land and buildings k/a advance factory 54 wrexham industrial estate wrexham t/n WA625185. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    PENINA 251 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২১ জুল, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২২ ফেব, ২০২০ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    অভ্যাসকারী
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    অভ্যাসকারী
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0