VENICE ANTLER 4 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামVENICE ANTLER 4 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 06067179
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    VENICE ANTLER 4 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    VENICE ANTLER 4 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    VENICE ANTLER 4 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PRIMROSECROWN LIMITED২৫ জানু, ২০০৭২৫ জানু, ২০০৭

    VENICE ANTLER 4 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    VENICE ANTLER 4 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    VENICE ANTLER 4 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জানু, ২০১৫

    ২৯ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১০ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr James Alexander Burrell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ নিবন্ধন 060671790005, ১২ জুন, ২০১৪ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    91 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ৩১ জানু, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Geraldine Josephine Gallagher-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ জানু, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Matthew Edward Bennison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ জানু, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Matthew Edward Bennison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    11 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    18 পৃষ্ঠাMG01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    14 পৃষ্ঠাMG01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Matthew Edward Bennison-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Mr Matthew Edward Bennison-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    VENICE ANTLER 4 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandIrishFinance Director185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishHuman Resources Director89557480002
    TROY, Anthony Gerrard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    সচিব
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    161875760001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156133650001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    সচিব
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    BURRELL, James
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    পরিচালক
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    BritishInvestment Executive115775330001
    CLARKE, Martin Andrew, Dr
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    পরিচালক
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    United KingdomBritishPartner At Private Equity Hous121053560001
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    পরিচালক
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritishDirector124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    FLANAGAN, Sally Deborah
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    পরিচালক
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishInvestment Executive116577710001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    পরিচালক
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director132613500001
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    পরিচালক
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor162620820001

    VENICE ANTLER 4 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০১৪
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cbre Loan Servicing Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুন, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    English law deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৭ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৩ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0