PHOENIX2010 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPHOENIX2010 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 06173265
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PHOENIX2010 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    PHOENIX2010 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    6 Oaklands Gardens
    CR8 5DS Kenley
    Surrey
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PHOENIX2010 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PARKRIDGE CARE LIMITED২৪ সেপ, ২০০৭২৪ সেপ, ২০০৭
    PARKRIDGE SECURITIES (HOMEFIELD) LIMITED২০ মার্চ, ২০০৭২০ মার্চ, ২০০৭

    PHOENIX2010 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    PHOENIX2010 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    4 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ মার্চ, ২০১১

    ২১ মার্চ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ০৭ মার্চ, ২০১১ তারিখে Camilla Bowry-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed parkridge care LIMITED\certificate issued on 14/10/10
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৪ অক্টো, ২০১০

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    CONNOT

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    সচিব হিসাবে Corin Winfield এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে John Cutts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Corin Winfield এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Camilla Bowry-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Mr Carlo Vittorio Navato-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০৭ অক্টো, ২০১০

    RES15

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Alan Stainforth এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    PHOENIX2010 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BOWRY, Camilla
    Oaklands Gardens
    CR8 5DS Kenley
    6
    Surrey
    সচিব
    Oaklands Gardens
    CR8 5DS Kenley
    6
    Surrey
    British154815080001
    NAVATO, Carlo Vittorio
    Haxted Road
    TN8 6PT Edenbridge
    South Haxted
    Kent
    পরিচালক
    Haxted Road
    TN8 6PT Edenbridge
    South Haxted
    Kent
    EnglandBritishChartered Surveyor131279700001
    WINFIELD, Corin Robert
    15 Ashlawn Crescent
    B91 1PR Solihull
    West Midlands
    সচিব
    15 Ashlawn Crescent
    B91 1PR Solihull
    West Midlands
    EnglishDirector61906590004
    HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    কর্পোরেট সচিব
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710002
    CUTTS, John Charles
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector56651680001
    NAVATO, Carlo Vittorio
    Haxted Road
    TN8 6PT Edenbridge
    South Haxted
    Kent
    পরিচালক
    Haxted Road
    TN8 6PT Edenbridge
    South Haxted
    Kent
    EnglandBritishDirector131279700001
    STAINFORTH, Alan John
    31a Church Street
    Braunston
    LE15 8QT Rutland
    Leicestershire
    পরিচালক
    31a Church Street
    Braunston
    LE15 8QT Rutland
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector60076710001
    WINFIELD, Corin Robert
    15 Ashlawn Crescent
    B91 1PR Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    15 Ashlawn Crescent
    B91 1PR Solihull
    West Midlands
    EnglandEnglishDirector61906590004
    HBJGW INCORPORATIONS LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    কর্পোরেট পরিচালক
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    68279000005

    PHOENIX2010 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h land and buildings known as homefield school salisbury road winkton christchurch dorset t/n DT277898,all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0