ON THE BEACH GROUP PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামON THE BEACH GROUP PLC
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 09736592
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ON THE BEACH GROUP PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভ্রমণ সংস্থার কার্যক্রম (79110) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    ON THE BEACH GROUP PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5 Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ON THE BEACH GROUP PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০২৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০২৪

    ON THE BEACH GROUP PLC এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৬ আগ, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে৩০ আগ, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৬ আগ, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    ON THE BEACH GROUP PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৭ এপ্রি, ২০২৫Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRITE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS REPURCHASED

    ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,564,742.62
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৩ এপ্রি, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,569,612.77
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৪ মার্চ, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    ১২ ফেব, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,584,767.70
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৭ মার্চ, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    ০৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,593,888.97
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৭ মার্চ, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11
    capital

    নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার কেনার অনুমোদনের রেজুলেশন

    RES09
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Short notice of general meetings other than an annual general meeting 25/02/2025
    RES13
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    ২৬ ফেব, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,602,800.58
    4 পৃষ্ঠাSH06

    ১৯ ফেব, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,608,270.58
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৫ ফেব, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৫ ফেব, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    ২৯ নভে, ২০১৮ তারিখে Simon Cooper-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ ফেব, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,609,383.81
    6 পৃষ্ঠাSH06

    ০৫ ফেব, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,609,803.67
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৭ ফেব, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    ২৯ জানু, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,611,061
    6 পৃষ্ঠাSH06

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩০ সেপ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি

    184 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ ফেব, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ms Victoria Ann Self-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ৩০ জানু, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ৩০ জানু, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    ২২ জানু, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,614,332.71
    6 পৃষ্ঠাSH06

    ১৬ জানু, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,618,480.23
    6 পৃষ্ঠাSH06

    ON THE BEACH GROUP PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    VICKERSTAFF, Kirsteen
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    সচিব
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    200246930001
    COOPER, Simon
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    United KingdomBritishCompany Director200246910001
    GREENING, Justine, The Rt Hon
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritishDirector272744670001
    HARRIS, Zoe Elizabeth
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritishChief Marketing Officer301229110001
    MORTON, Shaun
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritishFinance Director272828130001
    O'DONNELL, Elaine Margaret
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandIrish,BritishNon-Executive Director248305680001
    PENNYCOOK, Richard John
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritishDirector112734470002
    SELF, Victoria Ann
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    United KingdomBritishNon-Executive Director331876750001
    SHARMA, Veronica
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritishDirector263238380002
    WORMALD, Jonathan Michael
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer201020490001
    GINSBERG, Lee Dale
    Bird Hall Lane
    SK3 0XN Cheadle Heath
    Park Square
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bird Hall Lane
    SK3 0XN Cheadle Heath
    Park Square
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector37261660001
    KELLY, David Thomas, Dr
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritish,IrishCompany Director154393340001
    MEEHAN, Paul Alan
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    পরিচালক
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    5
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer130608590001
    PARRY, Gwendoline
    Bird Hall Lane
    SK3 0XN Cheadle Heath
    Park Square
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bird Hall Lane
    SK3 0XN Cheadle Heath
    Park Square
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director127080460001
    SEGAL, Richard Lawrence
    Bird Hall Lane
    SK3 0XN Cheadle Heath
    Park Square
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bird Hall Lane
    SK3 0XN Cheadle Heath
    Park Square
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director138744060001

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0