JTI REALISATIONS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামJTI REALISATIONS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC009831
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    JTI REALISATIONS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (1730) /
    • (1740) /

    JTI REALISATIONS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    37 Albyn Place
    AB10 1JB Aberdeen
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    JTI REALISATIONS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    J.T. INGLIS & SONS LIMITED০৫ এপ্রি, ১৯১৭০৫ এপ্রি, ১৯১৭

    JTI REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০০৫

    JTI REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    JTI REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    স্বেচ্ছাসেবী উইন্ড আপের চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.26(Scot)

    চূড়ান্ত সভার নোটিশ ক্রেডিটরদের

    3 পৃষ্ঠা4.17(Scot)

    প্রশাসন থেকে ঋণদাতাদের স্বেচ্ছায় সমাধানে স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

    16 পৃষ্ঠা2.25B(Scot)

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    8 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসকের পদত্যাগের বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠা2.29B(Scot)

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    7 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসনের সময়কাল বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠা2.22B(Scot)

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    8 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    7 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসনের সময়কাল বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠা2.22B(Scot)

    প্রশাসনের সময়কাল বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠা2.22B(Scot)

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    7 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    8 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসনের সময়কাল বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠা2.22B(Scot)

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    6 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    6 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    প্রশাসনের সময়কাল বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠা2.22B(Scot)

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed J.T. inglis & sons LIMITED\certificate issued on 27/07/07
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    প্রশাসকের অগ্রগতি প্রতিবেদন

    5 পৃষ্ঠা2.20B(Scot)

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Purchase agreement 20/07/07
    RES13

    legacy

    25 পৃষ্ঠা2.18B(Scot)

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবরণ

    25 পৃষ্ঠা2.16B(Scot)

    সম্পদ বিবরণী

    31 পৃষ্ঠা2.15B(Scot)

    JTI REALISATIONS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BEAL, David John Anthony
    Moreland House
    Cleish
    KY13 0LP Kinross-Shire
    Fife
    পরিচালক
    Moreland House
    Cleish
    KY13 0LP Kinross-Shire
    Fife
    ScotlandBritish62286570008
    BEAL, John Anthony
    10 Princes Gate
    Bothwell
    G71 8SP Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    10 Princes Gate
    Bothwell
    G71 8SP Glasgow
    Lanarkshire
    British3560070001
    CAMPBELL, James Iain Cameron
    78 Riverside Road
    DD6 8LJ Wormit
    Fife
    পরিচালক
    78 Riverside Road
    DD6 8LJ Wormit
    Fife
    ScotlandBritish105556150001
    RAMSAY, John Beattie
    Kirkstyle
    St. Vigeans
    DD11 4RB Arbroath
    Angus
    পরিচালক
    Kirkstyle
    St. Vigeans
    DD11 4RB Arbroath
    Angus
    British102273550001
    BAIN, James Iain
    40 Ceres Crescent
    Barnhill
    DD5 3JW Dundee
    Tayside
    সচিব
    40 Ceres Crescent
    Barnhill
    DD5 3JW Dundee
    Tayside
    British52845870001
    BEAL, David John Anthony
    Dunaird House
    St Marys Road
    PH8 0BJ Birnam
    Perthshire
    সচিব
    Dunaird House
    St Marys Road
    PH8 0BJ Birnam
    Perthshire
    British62286570004
    BEAL, Victoria Katherine
    Dunaird House
    Saint Marys Road, Birnam
    PH8 0BJ Perthshire
    সচিব
    Dunaird House
    Saint Marys Road, Birnam
    PH8 0BJ Perthshire
    British83958390001
    COOK, Graeme James
    4 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    সচিব
    4 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    British95832310001
    MCDONALD, Alasdair Moodie
    Hollybank
    The Fleurs, Falkland
    KY15 7AL Cupar
    Fife
    সচিব
    Hollybank
    The Fleurs, Falkland
    KY15 7AL Cupar
    Fife
    British110711760001
    THORNTONS WS
    50 Castle Street
    DD1 3RU Dundee
    কর্পোরেট সচিব
    50 Castle Street
    DD1 3RU Dundee
    51582870001
    ANDREW, Kenneth Guthrie
    49 Cedar Road
    Broughty Ferry
    DD5 3BA Dundee
    Angus
    পরিচালক
    49 Cedar Road
    Broughty Ferry
    DD5 3BA Dundee
    Angus
    ScotlandBritish410900001
    BAIN, James Iain
    40 Ceres Crescent
    Barnhill
    DD5 3JW Dundee
    Tayside
    পরিচালক
    40 Ceres Crescent
    Barnhill
    DD5 3JW Dundee
    Tayside
    British52845870001
    BEAL, John Anthony
    10 Princes Gate
    Bothwell
    G71 8SP Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    10 Princes Gate
    Bothwell
    G71 8SP Glasgow
    Lanarkshire
    British3560070001
    BEAL, Victoria Katherine
    Dunaird House
    Saint Marys Road, Birnam
    PH8 0BJ Perthshire
    পরিচালক
    Dunaird House
    Saint Marys Road, Birnam
    PH8 0BJ Perthshire
    British83958390001
    BONAR, George Christopher
    St Kitts 24 Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NT Dundee
    Angus
    পরিচালক
    St Kitts 24 Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NT Dundee
    Angus
    ScotlandBritish410910001
    COOK, Graeme James
    4 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    পরিচালক
    4 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    United KingdomBritish95832310001
    COOK, Graeme James
    4 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    পরিচালক
    4 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    United KingdomBritish95832310001
    LOW, Ian Campbell
    Holly Hill 69 Dundee Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NA Dundee
    Angus
    পরিচালক
    Holly Hill 69 Dundee Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NA Dundee
    Angus
    British199460001
    MUSSEN, Elizabeth Anne
    6 Douglas Terrace
    Broughty Ferry
    DD5 1EA Dundee
    Tayside
    পরিচালক
    6 Douglas Terrace
    Broughty Ferry
    DD5 1EA Dundee
    Tayside
    British44711600001
    SHEPHERD, Thomas Charles
    70 Grange Road
    DD5 4LS Monifieth
    Angus
    পরিচালক
    70 Grange Road
    DD5 4LS Monifieth
    Angus
    British94918090001

    JTI REALISATIONS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    • ০১ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    • ০৫ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)

    JTI REALISATIONS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৪ ডিসে, ২০০৬প্রশাসন শুরু
    ২১ ডিসে, ২০১১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Blair Carnegie Nimmo
    St Nicholas House Park Row
    NG1 6FQ Nottingham
    অভ্যাসকারী
    St Nicholas House Park Row
    NG1 6FQ Nottingham
    Neil Anthony Armour
    Unit 2
    Delta House Gemini Crescent
    DD2 1SW Dundee Technology Park
    Dundee
    অভ্যাসকারী
    Unit 2
    Delta House Gemini Crescent
    DD2 1SW Dundee Technology Park
    Dundee
    2
    তারিখপ্রকার
    ২১ ডিসে, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৭ সেপ, ২০১৪ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    অভ্যাসকারী
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    টীকাscottish-insolvency-info

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0