SD DECISIONS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSD DECISIONS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC045704
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SD DECISIONS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    SD DECISIONS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    24 Great King Street
    Edinburgh
    EH3 6QN
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SD DECISIONS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BIS STRATEGIC DECISIONS LIMITED ২৮ জানু, ১৯৯১২৮ জানু, ১৯৯১
    BIS MACKINTOSH LIMITED২২ মার্চ, ১৯৮৮২২ মার্চ, ১৯৮৮
    BIS MACKINTOSH INTERNATIONAL LIMITED১১ জুল, ১৯৮৬১১ জুল, ১৯৮৬
    BIS-MACKINTOSH LIMITED২৮ মে, ১৯৬৮২৮ মে, ১৯৬৮

    SD DECISIONS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০১০

    SD DECISIONS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    MVL-এ দ্রবীভূত হওয়ার আগে চূড়ান্ত অ্যাকাউন্ট (চূড়ান্ত অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত)

    13 পৃষ্ঠাLIQ13(Scot)

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAC93

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    স্বেচ্ছাসেবী উইন্ড আপের চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    23 পৃষ্ঠা4.26(Scot)

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Thomas Edward Timothy Homer-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে James Cheesewright এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ জুল, ২০১০

    ২৬ জুল, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,500
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Nicholas Brian Farrimond-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Elizabeth Gray এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    সচিব হিসাবে Misys Corporate Secretary Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    সচিব হিসাবে Gurbinder Bains এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    SD DECISIONS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর07036299
    150502590001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    EnglandBritish75357260001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    পরিচালক
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Burleigh House
    Chapel Oak
    WR11 8SP Salford Priors
    Evesham
    কর্পোরেট পরিচালক
    Burleigh House
    Chapel Oak
    WR11 8SP Salford Priors
    Evesham
    82836510001
    ARMITAGE, Matthew
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    সচিব
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    British98110790002
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    সচিব
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    BICHEMO, Tracey Lynne
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    সচিব
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    British16560470002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    সচিব
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    সচিব
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    সচিব
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    সচিব
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WALDEN, Alan Derek
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    সচিব
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    British536150001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    সচিব
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    BEAR, John Peter
    1 Longwater Circle
    FOREIGN Norwell
    Usa
    পরিচালক
    1 Longwater Circle
    FOREIGN Norwell
    Usa
    American26180110001
    BIRD, John Francis
    8a Dell Close
    AL5 4HP Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    8a Dell Close
    AL5 4HP Harpenden
    Hertfordshire
    British35039540001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    পরিচালক
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish80646020001
    COOPER, Graham Barrie
    School House
    Cockernhoe
    LU2 8PY Luton
    Bedfordshire
    পরিচালক
    School House
    Cockernhoe
    LU2 8PY Luton
    Bedfordshire
    British603160001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    GORDON, George Michael Winston
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    British37797170001
    GORDON, George Michael Winston
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    British37797170001
    GRAHAM, George Malcolm Roger
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish36314420001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    পরিচালক
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    GUINCHARD, Philippe Albert
    37 Rue Des Longs Pres
    92100 Boulogne
    France
    পরিচালক
    37 Rue Des Longs Pres
    92100 Boulogne
    France
    French35039550001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    পরিচালক
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    পরিচালক
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    JARVIS, John Edwin
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    British62045640001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    পরিচালক
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PESKO, Charles Anton
    366 Moraine Street
    FOREIGN Marshfield
    Ma
    Usa
    পরিচালক
    366 Moraine Street
    FOREIGN Marshfield
    Ma
    Usa
    American603180001
    PYNE, Anthony Edwin
    1 Brook End
    Eversholt
    MK17 9DT Milton Keynes
    পরিচালক
    1 Brook End
    Eversholt
    MK17 9DT Milton Keynes
    British603190001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WALDEN, Alan Derek
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    পরিচালক
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    British536150001
    WEAVER, John Joseph, Doctor
    76 Western Avenue
    Woodley
    RG5 3BH Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    76 Western Avenue
    Woodley
    RG5 3BH Reading
    Berkshire
    British16376810001
    WHISKIN, Robin Stuart
    42 Crown Street
    Redbourn
    AL3 7PF St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    42 Crown Street
    Redbourn
    AL3 7PF St Albans
    Hertfordshire
    British603210001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    পরিচালক
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002

    SD DECISIONS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charge entire undertaking present debenture ranks immediately behind a mortgage and general charge and a debenture made between the company and business intelligence services LTD.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Business Intelligence Services LTD
    ব্যবসায়
    • ১২ মার্চ, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage & general charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £30,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Business Intelligence Services LTD
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £102,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Business Intelligence Services LTD
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due by the macintosh consultants co LTD & another
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Credit balances of any accounts held by the bank in the companys name.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ১৯৭১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ১৯৭১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole assets of the company.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৪ ফেব, ১৯৭১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)
    • অর্ডারে পরিবর্তন রয়েছে: হ্যাঁ

    SD DECISIONS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৮ জুন, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৬ জুন, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    টীকাscottish-insolvency-info

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0