LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC095134
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (4521) /
    • (6024) /

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MINTLAW TRANSPORT LIMITED২৫ অক্টো, ১৯৮৫২৫ অক্টো, ১৯৮৫
    TANERXAN LIMITED১৮ সেপ, ১৯৮৫১৮ সেপ, ১৯৮৫

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    আদালত দ্বারা উইন্ডিং-আপে দ্রবীভূত হওয়ার আগে চূড়ান্ত অ্যাকাউন্ট

    14 পৃষ্ঠাWU15(Scot)

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order INSOLVENCY:Removal of Ian Christopher Oakley-Smith as liquidator and Appointment of replacement liquidator Graham Douglas Frost on 27/12/2018.
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠাCO4.2(Scot)

    উইন্ড আপ আদেশের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা4.2(Scot)

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রিসিভারের প্রতিবেদনের নোটিশ

    11 পৃষ্ঠা3.5(Scot)

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রিসিভার নিয়োগের নোটিশ একটি ভাসমান চার্জধারী দ্বারা

    3 পৃষ্ঠা1(Scot)

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    31 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Peter Fawns এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ এপ্রি, ২০১০

    ২৯ এপ্রি, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 556,630
    SH01

    ২৫ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Janette Spence Taylor-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৫ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Ian Michael Nelson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৫ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Masson & Glennie-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04

    ২৫ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Mr Peter Robertson Fawns-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Leslie Taylor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    30 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MASSON & GLENNIE
    Broad Street
    AB42 1HY Peterhead
    Broad House
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Broad Street
    AB42 1HY Peterhead
    Broad House
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    আইনি ফর্মSOLICITORS
    পরিচয়পত্রের ধরননন ইইএ
    আইনি কর্তৃপক্ষSCOTLAND
    41524400001
    NELSON, Ian Michael
    Bieldybrae
    Auchnagatt
    AB41 8PW Ellon
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    Bieldybrae
    Auchnagatt
    AB41 8PW Ellon
    Aberdeenshire
    ScotlandScottish69301000003
    NOBLE, Paul
    6 Links View
    St Fergus
    AB42 3HY Peterhead
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    6 Links View
    St Fergus
    AB42 3HY Peterhead
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish113026280001
    TAYLOR, Janette Spence
    Home Lane
    New Leeds
    AB42 4HX Peterhead
    Windynook
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    Home Lane
    New Leeds
    AB42 4HX Peterhead
    Windynook
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish53769280003
    TAYLOR, Leslie George
    St Mary Terrace
    New Leeds
    AB42 4HX Peterhead
    Lesonta
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    St Mary Terrace
    New Leeds
    AB42 4HX Peterhead
    Lesonta
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish105528920001
    BREMNER, James
    Roselea Cottage
    Maud
    AB42 4QJ Peterhead
    পরিচালক
    Roselea Cottage
    Maud
    AB42 4QJ Peterhead
    ScotlandBritish304720001
    FAWNS, Peter Robertson
    Sycamore Den
    Commercial Road
    AB41 9BD Ellon
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    Sycamore Den
    Commercial Road
    AB41 9BD Ellon
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish41243050002
    GILMARTIN, Simon Pierre
    Beechfield House
    East Knock, Mintlaw
    AB42 5BU Peterhead
    পরিচালক
    Beechfield House
    East Knock, Mintlaw
    AB42 5BU Peterhead
    ScotlandBritish5610600002
    TAYLOR, Leslie Paterson
    Windynook
    Home Lane, New Leeds
    AB42 4HX Peterhead
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    Windynook
    Home Lane, New Leeds
    AB42 4HX Peterhead
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish56695460001
    THOMPSON, Philip Alexander
    4 Campbelltown
    Ardersier
    IV1 2UG Inverness
    পরিচালক
    4 Campbelltown
    Ardersier
    IV1 2UG Inverness
    British53345610001

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জানু, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Ground extending 26.20 hectares lying generally to the west of the A947 public road known as longbog quarry, newmacher, aberdeen ABN28622 and the access roadway ABN28620 and the subjects mill of cavil & woodside, disblair, newmacher ABN13184.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • James David Stewart Jamieson
    ব্যবসায়
    • ১৪ জানু, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Buildings, adjoining yard and additional area at longside road, mintlaw, peterhead, aberdeenshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole assets of the company.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    • 1১১ জানু, ২০১১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (1 Scot)
      • মামলা নম্বর 1
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Grain drying store at mintlaw.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    14 south street mintlaw.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০২ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Area of ground in mintlaw, aberdeenshire with garage built thereon together with ground attached.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)

    LES TAYLOR CONTRACTORS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1প্রশাসনিক রিসিভার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Andrew James Davison
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    প্রশাসনিক রিসিভার
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    Colin Peter Dempster
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    প্রশাসনিক রিসিভার
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    টীকাscottish-insolvency-info
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৯ আগ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৯ আগ, ২০১২আবেদন তারিখ
    ২৫ এপ্রি, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১১ সেপ, ২০১৯ভেঙে গেছে
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Ian C. Oakley-Smith
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Graham Douglas Frost
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    অভ্যাসকারী
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Alan Alexander Brown
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    অভ্যাসকারী
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    John Bruce Cartwright
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    অভ্যাসকারী
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    টীকাscottish-insolvency-info

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0