SSE PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSSE PLC
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC117119
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SSE PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    SSE PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SSE PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC১৪ ডিসে, ১৯৯৮১৪ ডিসে, ১৯৯৮
    SCOTTISH HYDRO-ELECTRIC PLC০১ আগ, ১৯৮৯০১ আগ, ১৯৮৯
    NORTH OF SCOTLAND ELECTRICITY PLC০১ এপ্রি, ১৯৮৯০১ এপ্রি, ১৯৮৯

    SSE PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০২৬
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২৫

    SSE PLC এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ নভে, ২০২৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৫ নভে, ২০২৬
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ নভে, ২০২৫
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    SSE PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন

    2 পৃষ্ঠাSH04

    ৩০ নভে, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 605,226,297.5
    4 পৃষ্ঠাSH01

    ৩১ অক্টো, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 556,266,512
    4 পৃষ্ঠাSH01

    ৩০ জানু, ২০২৪ তারিখে Mrs Deborah Anne Crosbie-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ নভে, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৩ আগ, ২০২৫ তারিখে Dame Elish Frances Angiolini-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন:

    • মূলধন: GBP 2,016,632.3
    2 পৃষ্ঠাSH04

    ৩০ সেপ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 556,264,346
    4 পৃষ্ঠাSH01

    ৩১ আগ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 555,579,712
    4 পৃষ্ঠাSH01

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন:

    • মূলধন: GBP 2,028,738.8
    2 পৃষ্ঠাSH04

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন:

    • মূলধন: GBP 2,034,627.3
    2 পৃষ্ঠাSH04

    ৩১ জুল, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 555,579,712
    4 পৃষ্ঠাSH01

    ৩০ জানু, ২০২৪ তারিখে Mrs Deborah Anne Crosbie-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10
    capital

    মূলধন থেকে নিজস্ব শেয়ার কেনার অনুমোদনের রেজুলেশন

    RES08

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত তৈরি

    287 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ জুল, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Morton Alistair Phillips-Davies এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৭ জুল, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Helen Margaret Mahy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন:

    • মূলধন: GBP 2,040,918.3
    2 পৃষ্ঠাSH04

    ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 555,579,712
    4 পৃষ্ঠাSH01

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন:

    • মূলধন: GBP 2,139,059.8
    2 পৃষ্ঠাSH04

    ৩১ মে, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 555,579,712
    4 পৃষ্ঠাSH01

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন:

    • মূলধন: GBP 2,139,456.5
    2 পৃষ্ঠাSH04

    ৩০ এপ্রি, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 555,579,712
    4 পৃষ্ঠাSH01

    কোষাগার শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তর। কোষাগার মূলধন:

    • মূলধন: GBP 2,151,304.5
    2 পৃষ্ঠাSH04

    ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 555,579,712
    4 পৃষ্ঠাSH01

    SSE PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TANNER, Elizabeth Anne
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    সচিব
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Perthshire
    311966630001
    ANGIOLINI, Elish Frances, Dame
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish171999980002
    BASON, John George
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    EnglandBritish55405970001
    COCKER, Anthony David
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish236308800001
    CROSBIE, Deborah Anne
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    EnglandBritish258069910002
    MANZONI, John Alexander, Sir
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish273824010001
    NYASULU, Thembalihle Hixonia
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    South AfricaSouth African72349620001
    O'REGAN, Barry
    South County Business Park, Leopardstown
    18 Dublin
    Red Oak South
    Ireland
    পরিচালক
    South County Business Park, Leopardstown
    18 Dublin
    Red Oak South
    Ireland
    IrelandIrish316559850001
    PIBWORTH, Martin James
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish159744000004
    SMITH, Melanie Jane
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    EnglandBritish152475820002
    STRANK, Angela Rosemary Emily, Dr
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    EnglandBritish269318170001
    WETSELAAR, Maarten
    Paseo Castellana 259-A
    28046
    Madrid
    Moeve
    Spain
    পরিচালক
    Paseo Castellana 259-A
    28046
    Madrid
    Moeve
    Spain
    SpainDutch313096230001
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    সচিব
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    British62794440002
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    31 Hillpark Way
    Blackhall
    EH4 7ST Edinburgh
    Midlothian
    সচিব
    31 Hillpark Way
    Blackhall
    EH4 7ST Edinburgh
    Midlothian
    British62794440001
    DUKE, George Cartner
    Office Of The Solicitor To The Secretary Of State
    EH1 3 Edinburgh
    সচিব
    Office Of The Solicitor To The Secretary Of State
    EH1 3 Edinburgh
    British752180001
    FAIRBAIRN, Sally
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    সচিব
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    193177720001
    JEBSON, James Francis Cameron
    11 Essex Road
    EH4 6LF Edinburgh
    Midlothian
    সচিব
    11 Essex Road
    EH4 6LF Edinburgh
    Midlothian
    British1052220001
    WALKER, Hazel Louise
    41a Broughton Street
    EH1 3JU Edinburgh
    Midlothian
    সচিব
    41a Broughton Street
    EH1 3JU Edinburgh
    Midlothian
    British63949790001
    ALEXANDER, Fraser Mcgregor
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    পরিচালক
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    United KingdomBritish65278040002
    ANDERSEN, Thomas Thune
    Viggo Rothes Vei 30
    Charlottenlund
    2920
    Denmark
    পরিচালক
    Viggo Rothes Vei 30
    Charlottenlund
    2920
    Denmark
    DenmarkDanish135849220002
    BALDWIN, Nicholas Peter
    Norton Close
    WR5 3EY Worcester
    30
    Worcestershire
    পরিচালক
    Norton Close
    WR5 3EY Worcester
    30
    Worcestershire
    EnglandBritish54043530002
    BEETON, Jeremy
    - 4 Cockspur Street
    SW1Y 5DH London
    2
    United Kingdom
    পরিচালক
    - 4 Cockspur Street
    SW1Y 5DH London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish161280620001
    BICKERSTAFFE, Katie
    Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    Dixons Retail Plc
    United Kingdom
    পরিচালক
    Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    Dixons Retail Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish248318210001
    BRADY, Paul Anthony, Dr
    32 Grange Road
    EH9 1UL Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    32 Grange Road
    EH9 1UL Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish752150001
    BRUCE, Susan Margaret, Dame
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish201202480001
    CASLEY, Henry Roberts
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish21786610001
    DUKE, George Cartner
    167 Craiglea Drive
    EH10 5PT Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    167 Craiglea Drive
    EH10 5PT Edinburgh
    Midlothian
    British752170001
    EVERETT, Peter
    Cluain
    Castleton Road
    PH3 1JW Auchterarder
    Perthshire
    পরিচালক
    Cluain
    Castleton Road
    PH3 1JW Auchterarder
    Perthshire
    British17567290001
    FARMER, Edwin Bruce, Dr
    Weston House Bracken Close
    Wonersh
    GU5 0QS Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Weston House Bracken Close
    Wonersh
    GU5 0QS Guildford
    Surrey
    EnglandBritish9750780001
    FORBES, James Alexander
    Rydale Lodge
    1a Racecourse View
    KA7 2TS Ayr
    Ayrshire
    পরিচালক
    Rydale Lodge
    1a Racecourse View
    KA7 2TS Ayr
    Ayrshire
    British141444100001
    GILLIES, Crawford Scott
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    101
    United Kingdom
    পরিচালক
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    101
    United Kingdom
    United KingdomBritish199916220001
    GILLINGWATER, Richard Dunnell
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    পরিচালক
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    British82071780002
    GRANT, Ian David, Sir
    Leal House Loyal Road
    Alyth
    PH11 8JQ Blairgowrie
    Perthshire
    পরিচালক
    Leal House Loyal Road
    Alyth
    PH11 8JQ Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritish1304830002
    GRANT, Peter James
    Mountgerald
    IV15 9TT Dingwall
    Ross-Shire
    পরিচালক
    Mountgerald
    IV15 9TT Dingwall
    Ross-Shire
    British53390530001
    GRAY, David Mclaren
    Dykeneuk
    Butterstone
    PH8 0HA Dunkeld
    Perthshire
    পরিচালক
    Dykeneuk
    Butterstone
    PH8 0HA Dunkeld
    Perthshire
    ScotlandBritish140884530001

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0