BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC117456
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    11 Park Circus
    G3 6AX Glasgow
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    FARTHINGBANK HOLDINGS LIMITED১৪ সেপ, ১৯৮৯১৪ সেপ, ১৯৮৯
    PACIFIC SHELF 256 LIMITED২৪ এপ্রি, ১৯৮৯২৪ এপ্রি, ১৯৮৯

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৪ সেপ, ২০০৯

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৪ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ জুন, ২০১০

    ১৫ জুন, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 14,003,829
    SH01

    ২৪ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Mr Andrew Jeremy Gardner-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৪ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Mr John Hindle-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৪ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Mr Peter Chape-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    পূর্ণ হিসাব ২৪ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ২৪ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ২৪ সেপ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ২৪ সেপ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ২৪ সেপ, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CHAPE, Peter
    168-170 Washway Road
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    168-170 Washway Road
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    British128204680001
    GARDNER, Andrew Jeremy
    168-170 Washway Road
    Haslingden
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    168-170 Washway Road
    Haslingden
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish102740340004
    HINDLE, John
    168-170 Washway Road
    Hale
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    168-170 Washway Road
    Hale
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish4891900001
    BANFI, James Peter
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    সচিব
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    British9872210002
    CAMPION, Clive James
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    সচিব
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    British40753600001
    EDWARDS, John Michael
    23 Marshals Drive
    AL1 4RB St. Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    23 Marshals Drive
    AL1 4RB St. Albans
    Hertfordshire
    British67868530001
    LEE, Jonathan Neville Hastings
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    সচিব
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    British77781880002
    MCKIE, Robert Gordon
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    সচিব
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    British30277090001
    NICHOL, Alistair John
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    সচিব
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    British79018920001
    SLATER, Gerald Anthony
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    সচিব
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    British1092060001
    SLATER, Gerald Anthony
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    সচিব
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    British1092060001
    BANFI, James Peter
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish9872210002
    BISHOP, David John
    Hill House
    Rettendon Common
    CM3 8EA Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Hill House
    Rettendon Common
    CM3 8EA Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish12294000001
    CAMPION, Clive James
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    পরিচালক
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    EnglandBritish40753600001
    CLOGGIE, Allan Marshall
    Low Farthingbank
    DG3 4AH Thornhill
    Dumfriesshire
    পরিচালক
    Low Farthingbank
    DG3 4AH Thornhill
    Dumfriesshire
    British1306770001
    JEVONS, David Peter
    Pear Tree Cottage 34 Wrenthorpe Lane
    Wrenthorpe
    WF2 0QA Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Pear Tree Cottage 34 Wrenthorpe Lane
    Wrenthorpe
    WF2 0QA Wakefield
    West Yorkshire
    British30213100001
    LEE, Jonathan Neville Hastings
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    পরিচালক
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    British77781880002
    MARSDEN, Ian Clifford
    47 Withington Avenue
    Culcheth
    WA3 4JE Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    47 Withington Avenue
    Culcheth
    WA3 4JE Warrington
    Cheshire
    British103608350001
    MCKIE, Robert Gordon
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    British30277090001
    NICHOL, Alistair John
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish79018920001
    NORTH, Brian Samuel
    Queensbury Priory Road
    Sunningdale
    SL5 9RQ Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Queensbury Priory Road
    Sunningdale
    SL5 9RQ Ascot
    Berkshire
    British6145410001
    SEMADENI, Trevor Nicholas
    Dorneywood Orchard Field
    Postling
    CT21 4EE Hythe
    Kent
    পরিচালক
    Dorneywood Orchard Field
    Postling
    CT21 4EE Hythe
    Kent
    EnglandEnglish23768270002

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank Investments LTD
    ব্যবসায়
    • ০১ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • অর্ডারে পরিবর্তন রয়েছে: হ্যাঁ
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • County Nat West Ventures LTD
    ব্যবসায়
    • ০১ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • অর্ডারে পরিবর্তন রয়েছে: হ্যাঁ
    Bond & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tsb Bank Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ এপ্রি, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (419a)
    • অর্ডারে পরিবর্তন রয়েছে: হ্যাঁ

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0