BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | SC142783 |
এখতিয়ার | স্কটল্যান্ড |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- নিজস্ব রিয়েল এস্টেট কেনাবেচা (68100) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম
- নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম
BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 4th Floor 115 George Street EH2 4JN Edinburgh |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
শেষ হিসাব | |
---|---|
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩০ সেপ, ২০১৪ |
BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?
বার্ষিক রিটার্ন |
|
---|
BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
২৮ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Terrace Hill (Secretaries) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH04 | ||||||||||
১৭ সেপ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ
| 4 পৃষ্ঠা | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | SH20 | ||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 1 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি | 8 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৮ জুন, ২০১৫ তারিখে Mr Philip Alexander Jeremy Leech-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০৮ জুন, ২০১৫ তারিখে Mr Jonathan Martin Austen-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 13 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
change-registered-office-address-company-with-date-old-address | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Mr Jonathan Martin Austen-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Thomas Walsh এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Mr Philip Alexander Jeremy Leech-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Miranda Kelly এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি | 13 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২২ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02s | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02s | ||||||||||
BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBAN&CIVIC (SECRETARIES) LIMITED | কর্পোরেট সচিব | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor United Kingdom |
| 41006000014 | ||||||||||
AUSTEN, Jonathan Martin | পরিচালক | W1S 1BJ London 50 New Bond Street United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 51921200001 | ||||||||
LEECH, Philip Alexander Jeremy | পরিচালক | W1S 1BJ London 50 New Bond Street United Kingdom | England | British | Director | 77080490002 | ||||||||
FOX, Jacqueline Elizabeth | সচিব | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||||||
GILLEN, Seamus Joseph | সচিব | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | Company Secretary | 66174560001 | |||||||||
MORRISON, John | সচিব | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||||||
TURNER, David Charles | সচিব | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
QUILL SERVE LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত সচিব | 30 Queensferry Road EH4 2HG Edinburgh | 900003050001 | |||||||||||
CUFLEY, Sean Dominic Hardy | পরিচালক | Bank Cottage Haywards Heath Road Balcombe RH17 6NF Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 9150920001 | ||||||||
DONNELLY, Anthony | পরিচালক | 1 Old Kirk Road Corstorphine EH12 6JY Edinburgh | United Kingdom | British | Development Director | 109258700001 | ||||||||
HOWELL, Keith Martin | পরিচালক | Woodbine Cottage Main Street EH46 7EA West Linton Borders Scotland | British | Finance Director | 1499960004 | |||||||||
HUTCHISON, Graeme | পরিচালক | 11 West Savile Gardens EH9 3AB Edinburgh | British | Banker | 38185540002 | |||||||||
IRONSIDE, Ronald Alexander Hamilton | পরিচালক | 24 Pentland Avenue EH13 0HZ Edinburgh Midlothian | British | Chartered Accountant | 296250001 | |||||||||
KELLY, Miranda Anne | পরিচালক | 21 Rozelle Avenue Waterside, Newton Mearns G77 6YS Glasgow | Scotland | British | Solicitor | 62817160003 | ||||||||
LAW, William Blyth | পরিচালক | Loanstone Crossing Loanstone EH26 8PH Penicuik Midlothian | British | Housing Manager | 33622620002 | |||||||||
LEITH, Brian James | পরিচালক | 10 Douglas Avenue Lenzie G66 4NW Glasgow | British | Company Director | 61660001 | |||||||||
LEITH, Brian James | পরিচালক | 10 Douglas Avenue Lenzie G66 4NW Glasgow | British | Company Director | 61660001 | |||||||||
MACDONALD, Donald Ross | পরিচালক | Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens Kelvinside G12 0SA Glasgow | United Kingdom | British | Solicitor | 76786510001 | ||||||||
MCDONALD, Derek | পরিচালক | 8 Glen Sannox Grove Craigmarloch G68 0GH Cumbernauld | Scotland | British | Bank Official | 190466700001 | ||||||||
MCDOUGALL, Alastair Douglas | পরিচালক | Mayfield House Frankscroft EH45 9DX Peebles Peebleshire | Scotland | British | Company Director | 33622580001 | ||||||||
MCDOWALL, June Patricia | পরিচালক | 139 Hamilton Road Rutherglen G73 3BE Glasgow | United Kingdom | British | Company Registrar | 50316470001 | ||||||||
MIDDLETON, Douglas Alister | পরিচালক | 16 Wesley Crescent Bonnyrigg EH19 3RT Edinburgh | British | Chartered Accountant | 73738070001 | |||||||||
MORRISON, John | পরিচালক | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | Company Secretary | 1500260013 | |||||||||
PRICHARD, Kim Alan | পরিচালক | 24 Pentland Gardens EH10 6NW Edinburgh Midlothian | British | Property Developer | 72744060002 | |||||||||
ROBB, Gordon William | পরিচালক | 7 High Buckstone Fairmilehead EH10 6XS Edinburgh Midlothian | British | Chartered Accountant | 11456230001 | |||||||||
WALSH, Thomas Gerard | পরিচালক | 26 Flanders Road Chiswick W4 1NG London | England | Irish | Accountant | 48520230001 | ||||||||
WILSON, Alistair Barclay | পরিচালক | 19 Cauldstream Place Milngavie G62 7NL Glasgow Lanarkshire | British | Accountant | 426640001 | |||||||||
QUILL FORM LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক | 30 Queensferry Road EH4 2HG Edinburgh | 900003040001 |
BELGRAVE RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Standard security | তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All sums due or to become due | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Area of ground lying in the parish of belhelvie and county of aberdeen extending to 1 acre 685 decimla or one thousandth parts of an acre. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Standard security | তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধ িত | সুরক্ষিত পরিমাণ All sums due or to become due | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 34,36,40,42,44,46,48 & 49 high mill, high mill court, dundee; 25C, 25A,23B, 21A,21B,11A,15A,15B,17A,17B,19A,19B & 43C taylors lane, dundee. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Standard security | তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All sums due or to become due | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Flatted dwellinghouses known as 256, 258, 259, 264 and 265 (also known as 2, 6, 8, 18 and 20) castle heather drive, inverness and those plots or areas of ground extending in total to 1071.20 square metres or thereby with the semi-detached dwellinghouse erected thereonknown as plots 268, 269, 272, 273, 415 and 417 (also known as 26, 28, 34, 36, 94 and 98) castle heather drive, inverness. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Standard security | তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All sums due or to become due | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Area of ground lying to the east of castle heather drive, inverness together with whole buildings and other erections thereon being plots 232-255 castle heather drive, inverness. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Standard security | তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All sums due or to become due | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 0.59 hectares of ground at orchard avenue and mossgiel road, ayr. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Standard security | তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All sums due or to become due | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 25-31 high street, penicuik. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Standard security | তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All sums due or to become due | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 6,7 & 8 grandfield, craighall road, newhaven. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
|