BOBATH SCOTLAND

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBOBATH SCOTLAND
    কোম্পানির স্থিতিরূপান্তরিত / বন্ধ
    আইনি ফর্মরূপান্তরিত / বন্ধ
    কোম্পানি নম্বর SC149287
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BOBATH SCOTLAND এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    BOBATH SCOTLAND কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Bradbury House
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BOBATH SCOTLAND এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BLUESLATE LIMITED২৫ ফেব, ১৯৯৪২৫ ফেব, ১৯৯৪

    BOBATH SCOTLAND এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৫

    BOBATH SCOTLAND এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    6 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    The company has been converted into a scio 01/03/2016
    RES13

    ১০ মে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Ian James Johnstone-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি কোন সদস্য তালিকা নেই

    11 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Morris-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Roy Buchanan Hudson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    24 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি কোন সদস্য তালিকা নেই

    10 পৃষ্ঠাAR01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৮ নভে, ২০১৯Other The address of CIARA MCCOLGAN, director of BOBATH SCOTLAND, was replaced with a service address on 28/11/2019 under section 1088 of the Companies Act 2006

    ১৪ জুন, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Elaine Jean Boyd-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ সেপ, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dr Ciara Mccolgan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৮ নভে, ২০১৯Other The address of CIARA MCCOLGAN, director of BOBATH SCOTLAND, was replaced with a service address on 28/11/2019 under section 1088 of the Companies Act 2006

    ০৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mary Munro এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Charles Coyle এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি কোন সদস্য তালিকা নেই

    10 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Janette Mcphail-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি কোন সদস্য তালিকা নেই

    9 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে David Lamont এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr David James Lamont-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি কোন সদস্য তালিকা নেই

    10 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Theresa Morrison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Roy Buchanan Hudson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি কোন সদস্য তালিকা নেই

    9 পৃষ্ঠাAR01

    BOBATH SCOTLAND এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    O'NEILL, Martin
    Laigh Road
    G77 5EQ Glasgow
    74
    Lanarkshire
    Scotland
    সচিব
    Laigh Road
    G77 5EQ Glasgow
    74
    Lanarkshire
    Scotland
    BritishTeacher62726100002
    BOYD, Elaine Jean
    Douglas Muir Gardens
    Milngavie
    G62 7RZ Glasgow
    4
    Scotland
    পরিচালক
    Douglas Muir Gardens
    Milngavie
    G62 7RZ Glasgow
    4
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant196077890001
    CAMPBELL, James Mossman
    23 Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    পরিচালক
    23 Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant9505320001
    JOHNSTONE, Ian James
    Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    47
    Scotland
    পরিচালক
    Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    47
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director58656120002
    MACINNES, Seumas
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    পরিচালক
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    ScotlandBritishRestaurateur117378130002
    MCCOLGAN, Ciara, Dr
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    C/O Bobath Scotland
    United Kingdom
    পরিচালক
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    C/O Bobath Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritishDoctor196077900001
    MCGEOUGH, Harry
    Lademill
    Whins Of Milton
    FK7 0HN Stirling
    28
    Stirlingshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Lademill
    Whins Of Milton
    FK7 0HN Stirling
    28
    Stirlingshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishCorporate Development Director132016240001
    MCPHAIL, Janette
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    পরিচালক
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    ScotlandBritishRisk - Governance180421090001
    MORRIS, Paul
    Park Place
    FK10 1RT Alloa
    8
    Clackmannanshire
    Scotland
    পরিচালক
    Park Place
    FK10 1RT Alloa
    8
    Clackmannanshire
    Scotland
    United KingdomBritishPolicy Officer203799950001
    O'NEILL, Martin
    74 Laigh Road
    G77 5EQ Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    74 Laigh Road
    G77 5EQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishTeacher62726100002
    REID, Donald Bremner
    120 Henderland Road
    Bearsden
    G61 1JB Glasgow
    পরিচালক
    120 Henderland Road
    Bearsden
    G61 1JB Glasgow
    United KingdomBritishSolicitor1234290003
    CAIRNS, Joseph Thomas Francis
    14 Fernhill Road
    PH2 7BE Perth
    সচিব
    14 Fernhill Road
    PH2 7BE Perth
    United KingdomCompany Director44890480002
    HEGGIE, Margaret
    25 Whitehill Avenue
    Stepps
    G33 6BN Glasgow
    সচিব
    25 Whitehill Avenue
    Stepps
    G33 6BN Glasgow
    BritishPhysiotherapist38739930001
    IRVINE, Ian James
    37 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QQ Glasgow
    Lanarkshire
    সচিব
    37 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QQ Glasgow
    Lanarkshire
    British139050001
    MUNRO, Graeme Alexander
    12 Ashfield Road
    Cults
    AB15 9NQ Aberdeen
    সচিব
    12 Ashfield Road
    Cults
    AB15 9NQ Aberdeen
    BritishAccountant60161760003
    THOMPSON, Alan Fyfe
    13 Lynedoch Crescent
    G3 6EQ Glasgow
    Lanarkshire
    সচিব
    13 Lynedoch Crescent
    G3 6EQ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChartered Accountant74820150005
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BAIN, Leslie Murison
    87 Rimbleton Avenue
    KY6 2DP Glenrothes
    Fife
    পরিচালক
    87 Rimbleton Avenue
    KY6 2DP Glenrothes
    Fife
    ScotlandScottishHorse Trainer60059120001
    BURNS, Alan Robert
    Fassiefern Barrhill Crescent
    Kilbarchan
    PA10 2EU Johnstone
    Renfrewshire
    পরিচালক
    Fassiefern Barrhill Crescent
    Kilbarchan
    PA10 2EU Johnstone
    Renfrewshire
    BritishConsultant Geoligist38747130001
    CAIRNS, Joseph Thomas Francis
    14 Fernhill Road
    PH2 7BE Perth
    পরিচালক
    14 Fernhill Road
    PH2 7BE Perth
    ScotlandUnited KingdomCompany Director44890480002
    COYLE, John Charles
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    পরিচালক
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director49142130002
    CULLENS, William Dobbie
    25 Old Mugdock Road
    G63 9ER Strathblane
    পরিচালক
    25 Old Mugdock Road
    G63 9ER Strathblane
    United KingdomBritishCompany Director30799140004
    EUNSON, Paul, Dr
    10 Brighton Crescent East
    EH15 1LR Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    10 Brighton Crescent East
    EH15 1LR Edinburgh
    Midlothian
    BritishPaediatrician104378790001
    GOWARD, Robert James
    Ashburn
    24 West Montrose Street
    G84 9NF Helensburgh
    পরিচালক
    Ashburn
    24 West Montrose Street
    G84 9NF Helensburgh
    United KingdomBritishConsultant75968770002
    HEGGIE, Margaret
    25 Whitehill Avenue
    Stepps
    G33 6BN Glasgow
    পরিচালক
    25 Whitehill Avenue
    Stepps
    G33 6BN Glasgow
    BritishPhysiotherapist38739930001
    HUDSON, Roy Buchanan
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    পরিচালক
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    ScotlandBritishRetired166882100001
    IRVINE, John Alastair
    The Coyle House
    KA6 5JY Sundrum
    Ayr
    পরিচালক
    The Coyle House
    KA6 5JY Sundrum
    Ayr
    BritishManaging Director104622710001
    LAMONT, David James
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    পরিচালক
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director653100002
    MCARTHUR, Martin
    45 Woodlands Drive
    Drumpellier
    ML5 1LB Coatbridge
    Lanarkshire
    পরিচালক
    45 Woodlands Drive
    Drumpellier
    ML5 1LB Coatbridge
    Lanarkshire
    ScotlandBritishFinancial Adviser125376440001
    MCINNES, Iain Thomas
    Mains Lodge
    Dalmoak Castle
    G82 4HQ Dumbarton
    Dunbartonshire
    পরিচালক
    Mains Lodge
    Dalmoak Castle
    G82 4HQ Dumbarton
    Dunbartonshire
    BritishConsultant61528730001
    MCKAY, Angelene
    53 Cairngrassie Drive
    Portlethen
    AB12 4TY Aberdeen
    পরিচালক
    53 Cairngrassie Drive
    Portlethen
    AB12 4TY Aberdeen
    BritishSecretary75968420001
    MCKENNA, Thomas
    99 Brownside Road
    G72 8AF Cambuslang
    পরিচালক
    99 Brownside Road
    G72 8AF Cambuslang
    United KingdomBritishSales80362220001
    MORRISON, Theresa
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    পরিচালক
    10 High Craighall Road
    G4 9UD Glasgow
    Bradbury House
    Scotland
    ScotlandScottishUnpaid Full Time Carer83758550001
    MUNRO, Graeme Alexander
    12 Ashfield Road
    Cults
    AB15 9NQ Aberdeen
    পরিচালক
    12 Ashfield Road
    Cults
    AB15 9NQ Aberdeen
    ScotlandBritishAccountant60161760003
    MUNRO, Graeme
    50 Cotton Street
    Unit 19
    AB2 1EE Aberdeen
    পরিচালক
    50 Cotton Street
    Unit 19
    AB2 1EE Aberdeen
    BritishAccountant60161760001

    BOBATH SCOTLAND এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    • ১৯ জুল, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ১১ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 13, craighall business park, glasgow (otherwise known as 10 high craighall business park, glasgow) LA179256.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (410)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0