GVA JAMES BARR LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGVA JAMES BARR LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC153920
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GVA JAMES BARR LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • রিয়েল এস্টেট এজেন্সি (68310) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    GVA JAMES BARR LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    206 St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    Scotland
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GVA JAMES BARR LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JAMES BARR LIMITED১৭ ডিসে, ২০০৪১৭ ডিসে, ২০০৪
    JAMES BARR & SON LIMITED৩১ জানু, ১৯৯৫৩১ জানু, ১৯৯৫
    MITBROOK LIMITED২৮ অক্টো, ১৯৯৪২৮ অক্টো, ১৯৯৪

    GVA JAMES BARR LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জানু, ২০১৩

    GVA JAMES BARR LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAC93

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৬ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.25
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    পরিচালক হিসাবে Malcolm Whetstone এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Yan Stewart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Jamie Thain এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Scott Simpson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Alasdair Roy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Stephen Pollock এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Simon Roberts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Kenneth Mccormack এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Alexander Mitchell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Craigie Marwick এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Graeme Davies এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে James Macgarvie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Robert Bould এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Charles Crighton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    GVA JAMES BARR LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PADBURY, Ian Stuart
    c/o Gva Grimley Limited
    Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    3
    England
    সচিব
    c/o Gva Grimley Limited
    Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    3
    England
    185592980001
    FORGIE, Eric Thomas
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish41391520001
    SMITH, Donald
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    EnglandBritish64565650001
    BLACK, Gillian
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    সচিব
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    162581200001
    LINDSAY, Sylvia
    96 Menock Road
    G44 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    সচিব
    96 Menock Road
    G44 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    British53389520002
    BRODIES WS
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    900000290001
    AITKEN, Keith
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish141684340001
    BARCLAY, Kenneth Mccombie
    Craig An Righ
    Toward
    PA23 7UA Dunoon
    Argyll
    পরিচালক
    Craig An Righ
    Toward
    PA23 7UA Dunoon
    Argyll
    British53389450002
    BODERICK, Mark
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish116116990001
    BOULD, Robert John
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    EnglandBritish90771120004
    BROWN, David John
    49 Hamilton Drive
    G12 8DW Glasgow
    পরিচালক
    49 Hamilton Drive
    G12 8DW Glasgow
    United KingdomBritish96427550001
    CAIRNS, Robert David
    12 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RX Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    12 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RX Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish48940270002
    CAMPBELL, Alistair Carnegie
    50 Inverleith Place
    EH3 5QB Edinburgh
    মনোনীত পরিচালক
    50 Inverleith Place
    EH3 5QB Edinburgh
    British900000310001
    CRIGHTON, Charles Soutar
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish104672860001
    DARE, Martin Leslie Roger
    28 Woodchurch Road
    Kilburn
    NW6 3PN London
    পরিচালক
    28 Woodchurch Road
    Kilburn
    NW6 3PN London
    British74305490004
    DAVIES, Graeme William
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish107509020001
    GALBRAITH, Alexander Taylor
    Rosehaugh
    49 Langside Drive
    G43 2QQ Glasgow
    পরিচালক
    Rosehaugh
    49 Langside Drive
    G43 2QQ Glasgow
    British75728980001
    HARRIS, Angela Jean
    Greenhead Farm
    Old Greenock Road, Inchinnan
    PA4 9PH Renfrew
    Renfrewshire
    পরিচালক
    Greenhead Farm
    Old Greenock Road, Inchinnan
    PA4 9PH Renfrew
    Renfrewshire
    British54521220003
    HILL, Graeme Frederick
    19 Elliot Avenue
    Giffnock
    G46 7NS Glasgow
    পরিচালক
    19 Elliot Avenue
    Giffnock
    G46 7NS Glasgow
    British49474010003
    HUNTER, Colin Watson
    5e Golf Court
    Strathview Park
    G44 3LD Glasgow
    পরিচালক
    5e Golf Court
    Strathview Park
    G44 3LD Glasgow
    British1117240002
    LIMB, Gregory Mark
    3 Champfleurie Mews
    Bridgend
    EH49 6ND Linlithgow
    পরিচালক
    3 Champfleurie Mews
    Bridgend
    EH49 6ND Linlithgow
    ScotlandBritish74305380002
    MACFARLANE, Roderick John Charles
    Linnhe East Mill Farm
    Abbey Road
    PH3 1DP Auchterarder
    Perthshire
    পরিচালক
    Linnhe East Mill Farm
    Abbey Road
    PH3 1DP Auchterarder
    Perthshire
    United KingdomBritish194262210001
    MACGARVIE, James Stuart
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish74305300006
    MAGUIRE, John Gerard
    2 Mansionhouse Grove
    Mount Vernon
    G32 0RD Glasgow
    পরিচালক
    2 Mansionhouse Grove
    Mount Vernon
    G32 0RD Glasgow
    British41950250001
    MARWICK, Craigie
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish141685610001
    MCARTHUR, Gordon
    32 Gallowhill Avenue
    G66 4QD Glasgow
    পরিচালক
    32 Gallowhill Avenue
    G66 4QD Glasgow
    British38138790002
    MCCLURE, Niall Renilson
    115 Broomhill Drive
    G11 7NA Glasgow
    পরিচালক
    115 Broomhill Drive
    G11 7NA Glasgow
    British101242270001
    MCCORMACK, Kenneth Ross
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish51046940006
    MITCHELL, Alexander Campbell
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    United KingdomBritish83322610002
    NICHOLSON, David Stephen
    Marquis Avenue
    NE5 1YF Newcastle Upon Tyne
    20
    Tyne And Wear
    পরিচালক
    Marquis Avenue
    NE5 1YF Newcastle Upon Tyne
    20
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish131317770001
    ORR, Robert
    9 Langside Park
    Kilbarchan
    PA10 2EP Johnstone
    Renfrewshire
    পরিচালক
    9 Langside Park
    Kilbarchan
    PA10 2EP Johnstone
    Renfrewshire
    British1360180002
    POLLOCK, Stephen George
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish80703320002
    ROBERTS, Simon Oliver
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish119061060004
    ROY, Alasdair Brodie
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    পরিচালক
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    206
    Scotland
    ScotlandBritish48940170001
    SANDERS, Graham John
    3f2, 1 Ascot Gate
    G12 0AP Glasgow
    পরিচালক
    3f2, 1 Ascot Gate
    G12 0AP Glasgow
    British79429840001

    GVA JAMES BARR LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    • ০৫ মার্চ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0