CRITIQOM LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCRITIQOM LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC160484
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CRITIQOM LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • কাগজের স্টেশনারি উৎপাদন (17230) / উৎপাদন

    CRITIQOM LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CRITIQOM LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DOCUMENT OUTSOURCING LIMITED২৯ সেপ, ২০০৫২৯ সেপ, ২০০৫
    STORTEXT UK LIMITED১১ ফেব, ২০০০১১ ফেব, ২০০০
    STORTEXT LOGISTICS LIMITED০৩ অক্টো, ১৯৯৫০৩ অক্টো, ১৯৯৫
    DUNWILCO (470) LIMITED২০ সেপ, ১৯৯৫২০ সেপ, ১৯৯৫

    CRITIQOM LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৪

    CRITIQOM LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১০ ফেব, ২০২৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৪ ফেব, ২০২৬
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১০ ফেব, ২০২৫
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    CRITIQOM LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ০৫ জানু, ২০২৬ তারিখে Chris Walsh-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৯ ডিসে, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anthony John Strong এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি

    28 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gerrard Martin Crawley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ফ্লোটিং চার্জে পরিবর্তন SC1604840009

    18 পৃষ্ঠা466(Scot)

    ফ্লোটিং চার্জে পরিবর্তন SC1604840010

    16 পৃষ্ঠা466(Scot)

    চার্জ নিবন্ধন SC1604840010, ২৯ মে, ২০২৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    20 পৃষ্ঠাMR01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসে, ২০২৪ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew David Herd-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Christian Alexander Paul Dickson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Pawen Jernas এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Marcin Jernas এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Mitul Jay Rughani-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ১০ ফেব, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Chris Walsh-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Shane William Joseph Woods-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicholas Keegan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Pawen Jernas-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Marcin Jernas-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Christopher Johnson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Samantha Jayne Ghysen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    চার্জ নিবন্ধন SC1604840009, ২৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    16 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ SC1604840008 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ SC1604840007 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি

    28 পৃষ্ঠাAA

    CRITIQOM LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    RUGHANI, Mitul Jay
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    সচিব
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    334018820001
    DICKSON, Christian Alexander Paul
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    EnglandBritish208390720001
    HERD, Andrew David
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    EnglandBritish129949980001
    KEEGAN, Nicholas
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    IrelandIrish332066450001
    SAVAGE, Hayden John
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    পরিচালক
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    EnglandBritish255239970001
    WALSH, Christopher James, Mr.
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    IrelandIrish332067440002
    WOODS, Shane William Joseph
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    IrelandIrish332066670001
    FRASER, William
    Woodside
    Houston
    PA6 7DD Johnstone
    19
    Renfrewshire
    Scotland
    সচিব
    Woodside
    Houston
    PA6 7DD Johnstone
    19
    Renfrewshire
    Scotland
    British140871510001
    GHYSEN, Samantha Jayne
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    LE3 1UQ Leicester
    133-137 Scudamore Road
    England
    সচিব
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    LE3 1UQ Leicester
    133-137 Scudamore Road
    England
    266282840001
    HARTLEY, Ian
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    সচিব
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    172860730001
    KELLY, Paul Matthew
    13 Ladysneuk Road
    FK9 5NE Stirling
    Stirlingshire
    সচিব
    13 Ladysneuk Road
    FK9 5NE Stirling
    Stirlingshire
    British71750740001
    KELLY, Paul Matthew
    13 Ladysneuk Road
    FK9 5NE Stirling
    Stirlingshire
    সচিব
    13 Ladysneuk Road
    FK9 5NE Stirling
    Stirlingshire
    British71750740001
    LAMONT, Julian Callum
    51 Queen Margaret Close
    EH10 7EE Edinburgh
    সচিব
    51 Queen Margaret Close
    EH10 7EE Edinburgh
    British56618420001
    MCCALLUM, Lynne Margaret
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    সচিব
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    181896050001
    MCILQUHAM, Lorraine
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    সচিব
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    161346900001
    MCNULTY, Gary Edward
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    সচিব
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    164409380001
    SAUNDERS, Scott
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    British72070340003
    WALLACE, Graham Alexander Drummond
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    সচিব
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    British70304160001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    QUILL SERVE LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Lanarkshire
    কর্পোরেট সচিব
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Lanarkshire
    110089630001
    BELL, Edward
    20 Newton Court
    SL4 2SN Old Windsor
    পরিচালক
    20 Newton Court
    SL4 2SN Old Windsor
    British95487590001
    COUTTS, Maureen Sheila
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    মনোনীত পরিচালক
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004630001
    CRAWLEY, Gerrard Martin
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish194792350001
    DE HAAN, Peter Charles
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    SwitzerlandBritish289241980001
    EVANS, Adrian Michael
    44 Beckwith Road
    Dulwich
    SE24 9LG London
    পরিচালক
    44 Beckwith Road
    Dulwich
    SE24 9LG London
    United KingdomBritish15391950001
    FARMER, Richard
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    পরিচালক
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    EnglandBritish250540630001
    FRASER, William
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish82128590002
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    মনোনীত পরিচালক
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    HARTLEY, Ian
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    ScotlandBritish36694500004
    HENDERSON, Howard Geoffrey
    28 Adrian Close
    CF36 3LX Porthcawl
    Mid Glamorgan
    পরিচালক
    28 Adrian Close
    CF36 3LX Porthcawl
    Mid Glamorgan
    United KingdomBritish80242420001
    JERNAS, Marcin
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    PolandPolish332066220001
    JERNAS, Pawen
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    পরিচালক
    Document House
    Phoenix Crescent
    ML4 3NJ Strathclyde Business Park
    Bellshill
    IrelandPolish332066270001
    JOHNSON, Simon Christopher
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    পরিচালক
    c/o Opus Trust Communications
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    EnglandBritish110558260001
    JOHNSTON, Alan Robert
    37 Grange View
    EH49 7HY Linlithgow
    West Lothian
    পরিচালক
    37 Grange View
    EH49 7HY Linlithgow
    West Lothian
    British79093650001
    KEELER, Simon Nicholas
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    পরিচালক
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    EnglandBritish79093730001

    CRITIQOM LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Document Outsourcing Group Limited
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Scotland
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Document House
    Scotland
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশScotland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানScotland
    নিবন্ধন নম্বরSc254626
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0