SIGHT ACTION LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSIGHT ACTION LTD
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মগ্যারান্টি ছাড়াই শেয়ার ক্যাপিটাল ছাড়াই ব্যক্তিগত সীমিত দায় কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC220448
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SIGHT ACTION LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • আবাসন ছাড়া অন্যান্য সামাজিক কাজের কার্যক্রম ন.এ.সি. (88990) / মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাজ কার্যক্রম

    SIGHT ACTION LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    39 Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SIGHT ACTION LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HIGHLAND AND ISLANDS SOCIETY FOR BLIND PEOPLE১৫ জানু, ২০০৯১৫ জানু, ২০০৯
    HIGHLAND SOCIETY FOR BLIND PEOPLE২০ জুন, ২০০১২০ জুন, ২০০১

    SIGHT ACTION LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০২৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০২৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২৪

    SIGHT ACTION LTD এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২০ জুন, ২০২৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে০৪ জুল, ২০২৬
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২০ জুন, ২০২৫
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    SIGHT ACTION LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ১৫ সেপ, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elizabeth Mcallister এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি

    37 পৃষ্ঠাAA

    ২০ জুন, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৩ জানু, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Robert George Polson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    37 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed highland and islands society for blind people\certificate issued on 22/11/23
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২২ নভে, ২০২৩

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২২ নভে, ২০২৩

    RES15

    ২১ নভে, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Edward Murray Cochrane-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ অক্টো, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Elizabeth Mcallister-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ অক্টো, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr William Bennet Sweeney-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ অক্টো, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ms Maureen Mary Macmillan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ অক্টো, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ms Emily Elizabeth Mary Gray-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ অক্টো, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Ross Mcloughlin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ সেপ, ২০২৩ তারিখে Mr Derek James Macdonald-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৩ সেপ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Daniel Geoffrey Lawrence Rabson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৩ সেপ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Derek James Macdonald-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৩ সেপ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Kim Hunter-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ জুন, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    38 পৃষ্ঠাAA

    ২০ জুন, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    38 পৃষ্ঠাAA

    ২৪ নভে, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Maureen Mary Macmillan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ মে, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Eric Malcolm Oswald এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জুন, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    পৃষ্ঠাCS01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    37 পৃষ্ঠাAA

    SIGHT ACTION LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COCHRANE, Edward Murray
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    ScotlandBritish162624860001
    GRAY, Emily Elizabeth Mary
    Highfield House
    IV14 9BA Strathpeffer
    Highfield House
    Scotland
    পরিচালক
    Highfield House
    IV14 9BA Strathpeffer
    Highfield House
    Scotland
    ScotlandBritish218607290003
    HUNTER, Kim
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    ScotlandBritish306457180001
    MACDONALD, Derek James
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    ScotlandBritish313462030002
    MACLEAN, Angela Margaret
    Grant Crescent
    Maryburgh
    IV7 8EW Dingwall
    21
    Scotland
    পরিচালক
    Grant Crescent
    Maryburgh
    IV7 8EW Dingwall
    21
    Scotland
    ScotlandBritish93204940001
    MACMILLAN, Maureen Mary
    Station Road
    EH12 7AF Edinburgh
    29/12 Station Road
    Scotland
    পরিচালক
    Station Road
    EH12 7AF Edinburgh
    29/12 Station Road
    Scotland
    ScotlandBritish26305820003
    MURRAY, Scott Alan
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    United KingdomBritish234202190001
    POLSON, Robert George
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    ScotlandScottish317647260001
    RABSON, Daniel Geoffrey Lawrence
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    ScotlandBritish288481890001
    ROWANTREE, Robert Ian
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    United KingdomBritish57180660001
    SUTHERLAND, David Oman
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    ScotlandBritish270180001
    SWEENEY, William Bennet
    Scorguie Road
    IV3 8QP Inverness
    46
    Scotland
    পরিচালক
    Scorguie Road
    IV3 8QP Inverness
    46
    Scotland
    ScotlandBritish220857810001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    সচিব
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    British57440560001
    MACDONALD, Sarah Margaret
    14 Morven Road
    IV2 4BU Inverness
    Inverness Shire
    সচিব
    14 Morven Road
    IV2 4BU Inverness
    Inverness Shire
    British115014610001
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    সচিব
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    British73180870001
    BOYLE, Nicholas
    32 Ballifeary Road
    IV3 5PF Inverness
    Inverness Shire
    পরিচালক
    32 Ballifeary Road
    IV3 5PF Inverness
    Inverness Shire
    British68288380001
    CHRISTIE, Alasdair Bryce
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    ScotlandBritish126636720003
    CULLINGHAM, Terence James
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    পরিচালক
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    United KingdomBritish97749010003
    CULLINGHAM, Terence James
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    পরিচালক
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    ScotlandBritish97749010002
    CUMMING, Christina
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    পরিচালক
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    British121428950001
    GORMAN, Sandra
    Aros
    12 Morven Road
    IV2 4BU Inverness
    Inverness Shire
    পরিচালক
    Aros
    12 Morven Road
    IV2 4BU Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish81043790001
    GRANT, John George
    4 Torness Road
    IV2 4RH Inverness
    Highland
    পরিচালক
    4 Torness Road
    IV2 4RH Inverness
    Highland
    British56176480001
    HO-YEN, Darrel Orlando, Doctor
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    ScotlandBritish183119510001
    HUTCHESON, George
    37 Kenneth Street
    IV3 5DH Inverness
    পরিচালক
    37 Kenneth Street
    IV3 5DH Inverness
    British90612600001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    পরিচালক
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Scotland,UkBritish57440560001
    JOHN, David Phillip
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    ScotlandBritish166909770001
    JOHNSTONE, Leslie Margaret Scott
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    ScotlandBritish181257080001
    JOHNSTONE, Leslie Margaret Scott
    Ardconnel Street
    IV2 3EX Inverness
    38
    Highland Region
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3EX Inverness
    38
    Highland Region
    United Kingdom
    ScotlandBritish181257080001
    MACDONALD, Margaret
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    পরিচালক
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    ScotlandBritish97901380001
    MACDONALD, Sarah Margaret
    14 Morven Road
    IV2 4BU Inverness
    Inverness Shire
    পরিচালক
    14 Morven Road
    IV2 4BU Inverness
    Inverness Shire
    British115014610001
    MACLEAN, Elizabeth Anne
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    পরিচালক
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    ScotlandBritish27235670001
    MACMILLAN, Maureen Mary
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Scotland
    পরিচালক
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Scotland
    ScotlandBritish26305820002
    MCALLISTER, Elizabeth
    Harris Road
    IV2 3LS Inverness
    17
    Scotland
    পরিচালক
    Harris Road
    IV2 3LS Inverness
    17
    Scotland
    ScotlandBritish149601950001
    MCLOUGHLIN, Kevin Ross
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    পরিচালক
    Ardconnel Street
    IV2 3HB Inverness
    39
    Scotland
    ScotlandBritish80161550001
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    পরিচালক
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish73180870001

    SIGHT ACTION LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ২০ জুন, ২০১৭কোম্পানি জানে বা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা নেই

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0