STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSTOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর SC225035
    এখতিয়ারস্কটল্যান্ড
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o KPMG LLP
    Saltire Court,
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HALLADALE VENTURES (SCOTLAND) LIMITED২৫ ফেব, ২০০২২৫ ফেব, ২০০২
    PACIFIC SHELF 1097 LIMITED০৭ নভে, ২০০১০৭ নভে, ২০০১

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১১

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    স্বেচ্ছাসেবী উইন্ড আপের চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.26(Scot)

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০২ আগ, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    ২৭ জুন, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Stuart Andrew Weir Duncan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ নভে, ২০১১

    ২২ নভে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Alan Macleod এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০৯ নভে, ২০০৯ তারিখে Alan Donald Ewen Macleod-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed halladale ventures (scotland) LIMITED\certificate issued on 30/06/08
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HARKIN, Mark James
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    পরিচালক
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Scotland UkBritishDirector42293490004
    LINDSAY, Kenneth Fraser
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishProperty Director121520410001
    DUNCAN, Stuart Andrew Weir
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    সচিব
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    BritishSolicitor80233100002
    HARKIN, Mark James
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    সচিব
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    BritishFinance Director42293490004
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    পরিচালক
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishBank Executive68241910003
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    পরিচালক
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritishBanker104442220001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    পরিচালক
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritishBanking Official113081830001
    LOCKHART, David Alfred Stevenson
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishDirector35520610001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    90 Flat 2 Mayfield Road
    Newington
    EH9 2NJ Edinburgh
    পরিচালক
    90 Flat 2 Mayfield Road
    Newington
    EH9 2NJ Edinburgh
    BritishChartered Accountant80118270001
    MACLEOD, Alan Donald Ewen
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Accountant107116780001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property now or in the future belonging to it and located in england or wales (see attached schedule) including fixed and floating charges.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৬ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Subjects known as the bargarren centre, barrhill road, erskine (title number REN34783).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Subjects known as 6/14 church street and 6 baron taylor's street, inverness together with buildings and erections thereon and right, title and interest.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Subjects known as 22 and 24 cambridge street, glasgow.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The tenant's interest in the lease over subjects known as 158-204 main street, barrhead.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Assignation of rents
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Gross rental income over 22 and 24 cambridge street, glasgow.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Assignation of rents
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The gross rental income over the tenant's interest in 158-204 main street, barrhead.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Assignation of rents
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The gross rental income over 6/14A church street and 6 baron taylor's street, inverness.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Assignation of rents
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The gross rental income over the barrangate centre, barhill road, erskine.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due under the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (410)

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১০ সেপ, ২০১৩ভেঙে গেছে
    ০২ আগ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    অভ্যাসকারী
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    টীকাscottish-insolvency-info

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0