FINE FARE PROPERTIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FINE FARE PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
Unternehmensnummer | 00002907 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?
- (7020) /
Wo befindet sich FINE FARE PROPERTIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AERATED BREAD COMPANY LIMITED | 28. Okt. 1862 | 28. Okt. 1862 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 04. Jan. 2011 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 04. Okt. 2011 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Jan. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FINE FARE PROPERTIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrierungsbescheinigung eines Sozialvereins | Seiten | CERTIPS | ||||||||||
Verschiedenes Forms b and z- conversion to I &ps | Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Parry als Sekretär | Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2010 | Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Hurrell am 01. Aug. 2010 | Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Humes am 01. Aug. 2010 | Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ am 23. Feb. 2010 | Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Mai 2009 | Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2010 bis 04. Jan. 2010 | Seiten | AA01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | Seiten | AUD | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Robson als Geschäftsführer | Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Caroline Jane Sellers als Sekretär | Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emily Martin als Sekretär | Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Apr. 2008 | Seiten | AA | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Apr. 2007 | Seiten | AA |
Wer sind die Geschäftsführer von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARRY, Stephen | Sekretär | Corporation Street M60 4ES Manchester New Century House United Kingdom | 154611440001 | |||||||
SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | Corporation Street M60 4ES Manchester New Century House M60 4es United Kingdom | 146911920001 | |||||||
HUMES, Stephen | Geschäftsführer | c/o Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 84087790001 | ||||
HURRELL, Timothy | Geschäftsführer | c/o Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | United Kingdom | British | General Manager Food Group | 99724260001 | ||||
BROWN, Michael Alfred | Sekretär | Windrush Great Billing Park NN3 9BL Northampton Northamptonshire | British | 50692920001 | ||||||
EGITTO, Joleen | Sekretär | 3 Abbots Close Whitchurch BS14 0UD Bristol | British | 61599540001 | ||||||
GRANT, Stephen Martin | Sekretär | 3 Trelawn Court Rodney Road GL50 1JJ Cheltenham Gloucestershire | British | 20888800002 | ||||||
GRANT, Stephen Martin | Sekretär | 2 Beechwood Close Battledown GL52 6QQ Cheltenham Gloucestershire | British | 20888800001 | ||||||
HENSHAW, Stephen Anthony | Sekretär | Eastleigh Stables Bishopstrow BA12 9HW Warminster Wiltshire | British | Company Secretary | 91828160006 | |||||
MARTIN, Emily Louise | Sekretär | 49 Henley Park Yatton BS49 4JJ Bristol | British | Company Secretary | 115285710001 | |||||
ASHTON, Yvonne Margaret | Geschäftsführer | 1 West Dene Stoke Bishop BS9 2BQ Bristol Avon | British | Chartered Accountant | 45225070002 | |||||
BACK, Steven John | Geschäftsführer | Fennels 119 Bicester Road Lower End HP18 9EF Long Crendon | United Kingdom | British | Finance Director | 85825120001 | ||||
CHEYNE, David George Thomson | Geschäftsführer | The Covert 98 Woodlands Road Ashurst SO40 7AH Southampton Hampshire | Britain | British | Company Director | 74956170001 | ||||
CLELAND, Jonathan Bradley | Geschäftsführer | 70 Andes Close Ocean Village SO14 3HS Southampton | British | Retail Director | 111624590001 | |||||
COATES, Philip Raymond | Geschäftsführer | 2 Berestede Road W6 9NP London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 60114990002 | ||||
COOPER, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Crossways House Old Coach Road Cross BS26 2EL Axbridge Somerset | British | Cost & Management Accountant | 59071930001 | |||||
GATTO, Salvatore Martin | Geschäftsführer | 11 Cavendish Lodge Cavendish Road BA1 2UD Bath Avon | United Kingdom | British | Finance Director | 37327260002 | ||||
GRANT, Stephen Martin | Geschäftsführer | 3 Trelawn Court Rodney Road GL50 1JJ Cheltenham Gloucestershire | British | Company Secretary | 20888800002 | |||||
HARTE, Damien Bernard | Geschäftsführer | 13 Cambridge Park Redland BS6 6XW Bristol | British | Certified Accountant | 33922420001 | |||||
HENSHAW, Stephen Anthony | Geschäftsführer | 2 Ashton Coombe Lower Road Bratton BA13 4JQ Westbury Wiltshire | British | Director | 91828160003 | |||||
MITCHELL INNES, Alistair Campbell | Geschäftsführer | Langton Lodge Station Road Sunningdale SL5 0QR Ascot Berkshire | British | Chief Executive | 1386650001 | |||||
NELLIST, Robert Henry Harger | Geschäftsführer | Spooners 28 Park St Lane Park Street AL2 2JB St Albans Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 5435750001 | |||||
ROBSON, William Henry Mark | Geschäftsführer | 12 Kimble Close Knightcote CV47 2SJ Southam Warwickshire | England | British | Finance Director | 57803420002 | ||||
SHARP, Ernest Henry | Geschäftsführer | 36 Tufton Court Tufton Street Westminster SW1P 3QH London | British | Chartered Accountant | 777200001 | |||||
SMITH, Alan Frank | Geschäftsführer | Brambledown Grove Farm Droitwich Road Feckenham B96 6JA Redditch Worcestershire | British | Director | 46000100003 | |||||
SMITH, Neil Reynold | Geschäftsführer | 27 Broom Farm Close Nailsea BS48 4YJ Bristol | British | Company Director | 61599510002 |
Hat FINE FARE PROPERTIES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Standard security | Erstellt am 08. Okt. 1993 Geliefert am 18. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H subjects at unit 1/2 (otherwise 182) township centre easterhouse glasgow t/no GLA101661. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 06/09/93 | Erstellt am 06. Sept. 1993 Geliefert am 24. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Car park at weaver row srirling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 06/09/93 | Erstellt am 06. Sept. 1993 Geliefert am 24. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite gaurantee and debenture | |
Kurze Angaben 1588 great western road anniesland glasgow title no GLA100884. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 06/09/93 | Erstellt am 06. Sept. 1993 Geliefert am 24. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Subjects at new cross centre hamilton,l/h subjects at 88 graham street airdrie title no LAN95127,l/h subjects at 275/277 main street bellshill title no LAN95128,l/h subjects at 28/32 the plaza town centre east kilbride title no LAN95129,l/h subjects at 300 victoria road glasgow title no GLA100883,l/h subjects forming part of shillinghill alloa. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 06/09/93 | Erstellt am 06. Sept. 1993 Geliefert am 22. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trusteee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture dated 05/07/93 | |
Kurze Angaben Area of ground in sinclair street helensburgh title no DMB11150 subjects under title no DMB16528 subjects on the south west side of carrochan road and north west side of lomond road balloch title no DMB18240. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 02/09/93 | Erstellt am 02. Sept. 1993 Geliefert am 22. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Shop premises at high street lochee dundee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotlands 02/09/93 | Erstellt am 02. Sept. 1993 Geliefert am 22. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Retaildevelopment at high street cowdenbeath. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 02/09/93 | Erstellt am 02. Sept. 1993 Geliefert am 22. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 101/105 high street invergordon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 02/09/93 | Erstellt am 02. Sept. 1993 Geliefert am 22. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Retail store at 46/48 high street alness. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security reg in scotland 02/09/93 | Erstellt am 02. Sept. 1993 Geliefert am 22. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Subjects at shillinghill alloa and dingwall,l/h 15/17 and 26 main street prestwick,l/h 485 great western road aberdeen,l/h 26/30 swan street brechin,l/h 45 castle street forfar,l/h 114 dalry road edinburgh,l/h 23 unicorn way glenrothes,subjects at grampian road aviemore. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Juli 1993 Geliefert am 16. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company,each other group company (as defined) andany other present or future subsidiary of gateway group limited (as defined) to the chargee and/or the facility agent and/or the security agent (as defined) | |
Kurze Angaben See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 05. Juli 1993 Geliefert am 15. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the lenders in respect of a guarantee & debenture dated 25/10/89 as amended by a supplemental deed dated 05/07/93 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 19. Sept. 1991 Geliefert am 04. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 and the charge | |
Kurze Angaben Subjects k/a new cross centre, hamilton. (For full details refer to doc 395 ref M216C). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 19. Sept. 1991 Geliefert am 02. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 25.10.1991 | |
Kurze Angaben Shillinghill place alloa and others. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 19. Sept. 1991 Geliefert am 26. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 & all other security documents | |
Kurze Angaben Area of ground at sinclair st, helensburgh county of dumbarton title no dmb 11150 & lease by strathclyde regional council in favour of the fine fare limited title no dmb 16528. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. Okt. 1990 Geliefert am 02. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to be come due from each obligen to the chagee on any account whatsoever to the agent and the banks or any of them (as defined in the charge) under the terms of the financing documents to which such obliger is a party and of each olbiger to the subordinated lenders agent and to the subordinated lenders under the subordinated facilities agreement (all as defined in the charge). | |
Kurze Angaben Various properties registered and unregistered, f'hold and r' hold. Please see form 395 (ref: M27) for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 25. Okt. 1989 Geliefert am 31. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent & trustee for itself and for the banks as defined in the charge & to G.e capital corporate furnace group limited as agent & trustee for the subordinated lenders (as defined) on any account whatsoever under the terms of the financing docs as defined in the charge & the subordinated facilities agreement dated 17.4.89 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security registered in scotland | Erstellt am 07. Aug. 1986 Geliefert am 21. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Charge over all the properties listed in the schedule attached to the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1939 Geliefert am 15. Dez. 1939 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben The camsden town bakery. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1939 Geliefert am 15. Dez. 1939 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys etc | |
Kurze Angaben 29, kensington high st, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1939 Geliefert am 15. Dez. 1939 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben 47, high st, floating, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1939 Geliefert am 15. Dez. 1939 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben 23, golden green rd, 1, accomodation rd, london, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1939 Geliefert am 15. Dez. 1939 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben 11, princes parade, north finchley, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0