FINE FARE PROPERTIES LIMITED

FINE FARE PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFINE FARE PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 00002907
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AERATED BREAD COMPANY LIMITED28. Okt. 186228. Okt. 1862

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am04. Jan. 2011
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am04. Okt. 2011
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Jan. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Registrierungsbescheinigung eines Sozialvereins

    SeitenCERTIPS

    Verschiedenes

    Forms b and z- conversion to I &ps
    SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to I & ps 05/10/2010
    RES13

    Ernennung von Mr Stephen Parry als Sekretär

    SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Sept. 2010

    Kapitalaufstellung am 14. Sept. 2010

    • Kapital: GBP 20,045,030
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2010

    SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Hurrell am 01. Aug. 2010

    SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Humes am 01. Aug. 2010

    SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ am 23. Feb. 2010

    SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Mai 2009

    SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2010 bis 04. Jan. 2010

    SeitenAA01

    Rücktritt des Auditors

    SeitenAUD

    Beendigung der Bestellung von William Robson als Geschäftsführer

    SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Caroline Jane Sellers als Sekretär

    SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Emily Martin als Sekretär

    SeitenTM02

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten288b

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten288a

    legacy

    Seiten288a

    legacy

    Seiten288b

    legacy

    Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Apr. 2008

    SeitenAA

    legacy

    Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Apr. 2007

    SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FINE FARE PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Sekretär
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154611440001
    SELLERS, Caroline Jane
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    Sekretär
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    146911920001
    HUMES, Stephen
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Food Group99724260001
    BROWN, Michael Alfred
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    British50692920001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Sekretär
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Sekretär
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Sekretär
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    BritishCompany Secretary115285710001
    ASHTON, Yvonne Margaret
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    BritishChartered Accountant45225070002
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Geschäftsführer
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishFinance Director85825120001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCompany Director74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Geschäftsführer
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    BritishRetail Director111624590001
    COATES, Philip Raymond
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    Geschäftsführer
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60114990002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    Geschäftsführer
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    BritishCost & Management Accountant59071930001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary20888800002
    HARTE, Damien Bernard
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    Geschäftsführer
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    BritishCertified Accountant33922420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector91828160003
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    BritishChief Executive1386650001
    NELLIST, Robert Henry Harger
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant5435750001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Geschäftsführer
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    BritishChartered Accountant777200001
    SMITH, Alan Frank
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector46000100003
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Geschäftsführer
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    BritishCompany Director61599510002

    Hat FINE FARE PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security
    Erstellt am 08. Okt. 1993
    Geliefert am 18. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H subjects at unit 1/2 (otherwise 182) township centre easterhouse glasgow t/no GLA101661.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent & Trustee for Itself & the Banks (As Defined in the Charge)
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Erstellt am 06. Sept. 1993
    Geliefert am 24. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    Car park at weaver row srirling.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Erstellt am 06. Sept. 1993
    Geliefert am 24. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite gaurantee and debenture
    Kurze Angaben
    1588 great western road anniesland glasgow title no GLA100884.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedasagent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Erstellt am 06. Sept. 1993
    Geliefert am 24. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    Subjects at new cross centre hamilton,l/h subjects at 88 graham street airdrie title no LAN95127,l/h subjects at 275/277 main street bellshill title no LAN95128,l/h subjects at 28/32 the plaza town centre east kilbride title no LAN95129,l/h subjects at 300 victoria road glasgow title no GLA100883,l/h subjects forming part of shillinghill alloa.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Erstellt am 06. Sept. 1993
    Geliefert am 22. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trusteee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture dated 05/07/93
    Kurze Angaben
    Area of ground in sinclair street helensburgh title no DMB11150 subjects under title no DMB16528 subjects on the south west side of carrochan road and north west side of lomond road balloch title no DMB18240.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Erstellt am 02. Sept. 1993
    Geliefert am 22. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shop premises at high street lochee dundee.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotlands 02/09/93
    Erstellt am 02. Sept. 1993
    Geliefert am 22. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Retaildevelopment at high street cowdenbeath.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Erstellt am 02. Sept. 1993
    Geliefert am 22. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    101/105 high street invergordon.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Erstellt am 02. Sept. 1993
    Geliefert am 22. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Retail store at 46/48 high street alness.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Erstellt am 02. Sept. 1993
    Geliefert am 22. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Subjects at shillinghill alloa and dingwall,l/h 15/17 and 26 main street prestwick,l/h 485 great western road aberdeen,l/h 26/30 swan street brechin,l/h 45 castle street forfar,l/h 114 dalry road edinburgh,l/h 23 unicorn way glenrothes,subjects at grampian road aviemore.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Juli 1993
    Geliefert am 16. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company,each other group company (as defined) andany other present or future subsidiary of gateway group limited (as defined) to the chargee and/or the facility agent and/or the security agent (as defined)
    Kurze Angaben
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 16. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 05. Juli 1993
    Geliefert am 15. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the lenders in respect of a guarantee & debenture dated 25/10/89 as amended by a supplemental deed dated 05/07/93
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 15. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 19. Sept. 1991
    Geliefert am 04. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 and the charge
    Kurze Angaben
    Subjects k/a new cross centre, hamilton. (For full details refer to doc 395 ref M216C).
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    Standard security
    Erstellt am 19. Sept. 1991
    Geliefert am 02. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 25.10.1991
    Kurze Angaben
    Shillinghill place alloa and others.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security
    Erstellt am 19. Sept. 1991
    Geliefert am 26. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 & all other security documents
    Kurze Angaben
    Area of ground at sinclair st, helensburgh county of dumbarton title no dmb 11150 & lease by strathclyde regional council in favour of the fine fare limited title no dmb 16528.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 1990
    Geliefert am 02. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to be come due from each obligen to the chagee on any account whatsoever to the agent and the banks or any of them (as defined in the charge) under the terms of the financing documents to which such obliger is a party and of each olbiger to the subordinated lenders agent and to the subordinated lenders under the subordinated facilities agreement (all as defined in the charge).
    Kurze Angaben
    Various properties registered and unregistered, f'hold and r' hold. Please see form 395 (ref: M27) for full details.
    Berechtigte Personen
    • S G Warburg & Co LTD(As Security Agent)
    • G E Capital Corporate Finance Group Limited(As Subordinated Lenders Agent)
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. März 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Okt. 1989
    Geliefert am 31. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent & trustee for itself and for the banks as defined in the charge & to G.e capital corporate furnace group limited as agent & trustee for the subordinated lenders (as defined) on any account whatsoever under the terms of the financing docs as defined in the charge & the subordinated facilities agreement dated 17.4.89
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • S.G. Warburg & Co Limited
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    • 01. Nov. 1990Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. März 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. März 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 31. März 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security registered in scotland
    Erstellt am 07. Aug. 1986
    Geliefert am 21. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Charge over all the properties listed in the schedule attached to the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Balfour Beatty Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1939
    Geliefert am 15. Dez. 1939
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc
    Kurze Angaben
    The camsden town bakery. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • National Prov Bank LTD
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1939Registrierung einer Belastung
    • 14. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1939
    Geliefert am 15. Dez. 1939
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys etc
    Kurze Angaben
    29, kensington high st, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1939Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1939
    Geliefert am 15. Dez. 1939
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc
    Kurze Angaben
    47, high st, floating, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1939Registrierung einer Belastung
    • 14. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1939
    Geliefert am 15. Dez. 1939
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc
    Kurze Angaben
    23, golden green rd, 1, accomodation rd, london, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1939Registrierung einer Belastung
    • 14. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1939
    Geliefert am 15. Dez. 1939
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc
    Kurze Angaben
    11, princes parade, north finchley, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1939Registrierung einer Belastung
    • 14. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0