WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00007633 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED?
- Sonstiger Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden a.n.g. (08990) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen (20150) / Verarbeitendes Gewerbe
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SINCLAIR HORTICULTURE & LEISURE LIMITED | 22. Jan. 1985 | 22. Jan. 1985 |
| SINCLAIR FERTILISERS PLC | 26. März 1982 | 26. März 1982 |
| LINDSEY AND KESTEVEN FERTILISERS LIMITED | 08. Sept. 1873 | 08. Sept. 1873 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 24 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 22 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 22 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 23 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 25 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Jan. 2017 | 25 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Juli 2016 | 26 Seiten | 2.24B | ||
Ernennung eines Receivers oder Managers | 4 Seiten | RM01 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Jan. 2016 | 29 Seiten | 2.24B | ||
Geänderte Bescheinigung über die Zusammensetzung des Gläubigerausschusses | 1 Seiten | 2.26B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 1 Seiten | 2.23B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 1 Seiten | 2.23B | ||
Vorschlag des Verwalters | 63 Seiten | 2.17B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 24 Seiten | 2.16B | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Firth Road Lincoln LN6 7AH zum Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH am 17. Aug. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
Ernennung von William Sinclair Holdings Plc als Direktor am 17. Juli 2015 | 2 Seiten | AP02 | ||
Ernennung von Ms Sheryl Anne Tye als Sekretär am 15. Mai 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||
Erfüllung der Belastung 000076330016 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Beendigung der Bestellung von Peter Dominic Williams als Sekretär am 14. Mai 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Peter Dominic Williams als Geschäftsführer am 14. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYE, Sheryl Anne | Sekretär | One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham Kpmg Llp | 198612810001 | |||||||||||||||
| BURGIN, Stuart James | Geschäftsführer | One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham Kpmg Llp | England | British | 90195130002 | |||||||||||||
| SINCLAIR, Richard Guy | Geschäftsführer | Church Laneham Church Laneham DN22 0NQ Retford Brunswick House Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 129159180002 | |||||||||||||
| WILLIAM SINCLAIR HOLDINGS PLC | Geschäftsführer | Firth Road LN6 7AH Lincoln Firth Road England |
| 199696120001 | ||||||||||||||
| DAWE, Edward William | Sekretär | Elm House Spridlington LN8 2DE Market Rasen Lincolnshire | British | 27044760002 | ||||||||||||||
| ROWLAND, Stephen | Sekretär | 45 Kingsley Square GU51 1AH Fleet Hampshire | British | 4796000003 | ||||||||||||||
| WILLIAMS, Peter Dominic | Sekretär | Woodview Ponton Road NG33 4DH Boothby Pagnell Lincolnshire | British | 41183690004 | ||||||||||||||
| ADAMSON, Daniel James | Geschäftsführer | MK46 5AR Ravenstone The Wheatsheaf Buckinghamshire | England | British | 186551160001 | |||||||||||||
| BARLOW, Roger | Geschäftsführer | Villa Farm Main Street, Wilberfoss YO41 5NA York North Yorkshire | British | 70191620001 | ||||||||||||||
| BARTON, Peter James Frederick | Geschäftsführer | Paddock House Owmby Road Spridlington LN8 2DD Market Rasen Lincolnshire | British | 9417220001 | ||||||||||||||
| BARTON, Peter James Frederick | Geschäftsführer | Paddock House Owmby Road Spridlington LN8 2DD Market Rasen Lincolnshire | British | 9417220001 | ||||||||||||||
| BURNS, Bernard Patrick | Geschäftsführer | Ashville 22 Wheatley Road LS29 8TS Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | 97913800001 | |||||||||||||
| CARRINGTON, Fiona Susan | Geschäftsführer | Inverinain Hall Drive,Canwick LN4 2RG Lincoln | United Kingdom | British | 69885030001 | |||||||||||||
| CARTWRIGHT, Stephen William | Geschäftsführer | Tarn Hows Sands Lane Carlton Le Moorland LN5 9HJ Lincoln | United Kingdom | British | 20222150001 | |||||||||||||
| DAVENPORT, Paul Thomas | Geschäftsführer | 5 Chalgrove Way LN6 0QH Lincoln Lincolnshire | England | British | 117041730001 | |||||||||||||
| DAW, Michael Garry | Geschäftsführer | 17 Davallia Drive Up Hatherley GL51 3XG Cheltenham Gloucestershire | England | British | 111145340001 | |||||||||||||
| DICK, Thomas Robert | Geschäftsführer | Garden Cottage Crosby On Eden CA6 4QZ Carlisle Cumbria | British | 31649490004 | ||||||||||||||
| EVERETT, Arthur Edward | Geschäftsführer | 6 St Helens Way Hemswell DN21 5XG Gainsborough Lincolnshire | British | 31649500001 | ||||||||||||||
| FEAVIOUR, Roger St Denis | Geschäftsführer | Hazeley House High Street Chieveley RG20 8UX Newbury Berkshire | England | British | 75855050001 | |||||||||||||
| HARPER, Steven David | Geschäftsführer | 2 Horton Place Saxilby LN1 2GW Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 70191660002 | |||||||||||||
| LAIDLAW, Alexander Duncan John | Geschäftsführer | Wellgarth Westlinton CA6 6AA Carlisle Cumbria | British | 37973180001 | ||||||||||||||
| MCCARTHY, Stewart Leslie | Geschäftsführer | 31 Shaftesbury Avenue LN6 0QN Lincoln Lincolnshire | British | 89810001 | ||||||||||||||
| ROWLAND, Stephen | Geschäftsführer | 45 Kingsley Square GU51 1AH Fleet Hampshire | England | British | 4796000003 | |||||||||||||
| RUSH, Peter John | Geschäftsführer | Firth Road Lincoln LN6 7AH | England | British | 94039640002 | |||||||||||||
| SINCLAIR, Thomas Humphrey | Geschäftsführer | Orchard House 8 Weston Road Edith Weston LE15 8HQ Oakham Leicestershire | British | 33820003 | ||||||||||||||
| UZZELL, Norman Frank | Geschäftsführer | 10 Tempest Street LN2 5NB Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 31649510001 | |||||||||||||
| WILLIAMS, Paul John | Geschäftsführer | Stables Cottage Dereham Road, Briningham NR24 2QJ Melton Constable Norfolk | England | British | 68920220002 | |||||||||||||
| WILLIAMS, Peter Dominic | Geschäftsführer | Woodview Ponton Road NG33 4DH Boothby Pagnell Lincolnshire | United Kingdom | British | 41183690004 | |||||||||||||
| YARROW, Ian Peter | Geschäftsführer | Melrow House 67 Lincoln Road Bassingham LN5 9JR Lincoln Lincolnshire | England | English | 65127300001 |
Hat WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 16. Nov. 2014 Geliefert am 04. Dez. 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Nov. 2014 Geliefert am 14. Nov. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Land at ellesmere port title no CH614737. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Nov. 2014 Geliefert am 14. Nov. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Land to the north of firth road lincoln title no LL27223. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Nov. 2014 Geliefert am 14. Nov. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Property to the north of beevor street lincoln title no LL247401. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Nov. 2014 Geliefert am 14. Nov. 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. März 2014 Geliefert am 18. März 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung A security agreement dated 18 march 2014 in relation to land and buildings at firth road, lincoln being the whole of the property registered at the land registry under title number LL27223. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 16. Jan. 2014 Geliefert am 18. Jan. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 16. Jan. 2014 Geliefert am 18. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Freehold land k/a stanlow works bridges road ellesmere port title no CH614737. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Dez. 2013 Geliefert am 07. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Dez. 2013 Geliefert am 03. Jan. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Sept. 2012 Geliefert am 18. Sept. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land and buildings at stanlow works bridges road great stanney ellesmere port. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 24. Feb. 2012 Geliefert am 15. März 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due up to a maximum amount of £1,000,000 from the company and william sinclair holdings public limited company to the william sinclair holdings PLC pension fund on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property to the north of beevor street lincoln t/no LL247401. All claims under and all proceeds of insurance see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 12TH december 1995 (the agreement) | Erstellt am 04. Jan. 2011 Geliefert am 06. Jan. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement dated 12TH december 1995 | Erstellt am 02. Nov. 2010 Geliefert am 05. Nov. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any present of future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 2010 Geliefert am 05. Nov. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Okt. 2009 Geliefert am 21. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Freehold property known as william sinclair holdings firth road lincoln (title number LL27223). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 16. Okt. 2009 Geliefert am 02. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Firth road lincoln t/no LL27223 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 16. Okt. 2009 Geliefert am 28. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land lying to the north of beevor street lincoln t/no LL247401; together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 27. Juli 2004 Geliefert am 27. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property at brevor street lincoln including buildings, fixed plant and machinery and fixtures, the benefit of all guarantees or covenants, any entitlement connected with the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set-off | Erstellt am 12. Sept. 1984 Geliefert am 24. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit present/future account of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set-off | Erstellt am 02. Feb. 1983 Geliefert am 08. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sums standing to the credit of any present/future accoutn of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Dez. 1980 Geliefert am 19. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 24.701 acres of land situate at saxilby lincoln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Dez. 1980 Geliefert am 19. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 5.122 acres of land at saxilby lincoln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WILLIAM SINCLAIR HORTICULTURE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Receiver/Manager bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0