JAEGER HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JAEGER HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00019149 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JAEGER HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich JAEGER HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ship Canal House 8th Floor 98 King Street M2 4WB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JAEGER HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Feb. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JAEGER HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 32 Seiten | AM23 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Alixpartners the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB zum Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB am 16. März 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 28 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 29 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||||||||||
Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt | 9 Seiten | AM16 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 31 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 34 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 4 Seiten | AM19 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 47 Seiten | AM10 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 9 Seiten | AM02 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 4 Seiten | AM06 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 72 Seiten | AM03 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 4 Seiten | AM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor, the White Building, 11 Evesham Street London W11 4AJ United Kingdom zum C/O Alixpartners the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB am 28. Apr. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Christopher Pilling als Geschäftsführer am 30. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth Charles Pratt als Direktor am 21. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Feb. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Harminder Singh Atwal als Geschäftsführer am 26. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 57 Broadwick Street London W1F 9QS zum 2nd Floor, the White Building, 11 Evesham Street London W11 4AJ am 15. Apr. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Richard Horobin als Direktor am 25. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 000191490015, erstellt am 02. Dez. 2015 | 12 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von JAEGER HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion | Sekretär | 98 King Street M2 4WB Manchester Ship Canal House 8th Floor | 173990650001 | |||||||
| HOROBIN, Christopher Richard | Geschäftsführer | 98 King Street M2 4WB Manchester Ship Canal House 8th Floor | United Kingdom | British | 204157860001 | |||||
| PRATT, Kenneth Charles | Geschäftsführer | 98 King Street M2 4WB Manchester Ship Canal House 8th Floor | England | British | 72306460002 | |||||
| ALDRIDGE, Gemma Jane Constance | Sekretär | 54 Crown Street HA2 0HR Harrow On The Hill Middlesex | British | 144966000001 | ||||||
| ATKAR, Dilbina Manjit Kaur | Sekretär | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | British | 93641970001 | ||||||
| GIFFORD, Derek William | Sekretär | 70 Manor Drive KT5 8NF Surbiton Surrey | British | 951440001 | ||||||
| JENKINS, David Huw | Sekretär | 25 Wingfield Close The Common CF37 4AB Pontypridd | British | 76742540002 | ||||||
| LITTLE, Mark Richard | Sekretär | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | British | 93642950001 | ||||||
| MCEWAN, Andrew Gilmour | Sekretär | 376 Wootton Road PE30 3EA Kings Lynn Norfolk | British | 2681910001 | ||||||
| OLIVER, Andrew Winship | Sekretär | 19 Mount Park Road Ealing W5 2RS London | British | 35023000004 | ||||||
| ROSE, Belinda | Sekretär | 45 Reginald Road HA6 1EF Northwood Middlesex | British | 90092080001 | ||||||
| STEPHENS, Julia | Sekretär | Chapel Lodge Old Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JW Winchester Hampshire | British | 63984570001 | ||||||
| ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | England | British | 168411280001 | |||||
| ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | England | British | 168411280001 | |||||
| ASPLIN, Robert Alexander | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | United Kingdom | British | 149870270004 | |||||
| ATWAL, Harminder Singh | Geschäftsführer | Evesham Street W11 4AJ London 2nd Floor, The White Building, 11 United Kingdom | United Kingdom | British | 167976490001 | |||||
| BAIN, Neville Clifford, Dr | Geschäftsführer | High Trees Cavendish Road St Georges Hill KT13 0JX Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 48436050001 | |||||
| BALL, John Adrian | Geschäftsführer | Watersmeet Mill Lane RG9 3LY Shiplake Oxfordshire | British | 11182730003 | ||||||
| BILLING, Mark Pemberton | Geschäftsführer | Old Blackhorse Cottage Old Dinton Road Teffont SP3 5QX Salisbury Wiltshire | British | 54813590002 | ||||||
| BURNETT, Patricia Ann | Geschäftsführer | The Conifers Seabrook Road WD4 8NU Kings Langley Hertfordshire | England | British | 70101270002 | |||||
| CHRISTMAS, Joan Iris | Geschäftsführer | 91 Napier Court Ranelagh Gardens SW6 3XA London | United Kingdom | British | 108153250001 | |||||
| COTTERELL, Rebecca Jane | Geschäftsführer | Pebworth Fields House Pebworth CV37 8XP Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 56625580002 | ||||||
| CRANSTON, John Charles | Geschäftsführer | 8 Nottingham Road NG25 0LF Southwell Nottinghamshire | England | British | 145205440001 | |||||
| EARL, Belinda | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street W1F 9QS London | United Kingdom | British | 97792020001 | |||||
| EDGERTON, Graham John | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | United Kingdom | British | 87214070001 | |||||
| GIBBS, Antony Wood | Geschäftsführer | Green Acre Buddon Lane Quorn LE12 8AA Loughborough Leicestershire | British | 13897740001 | ||||||
| HARRISON, Fiona Mary | Geschäftsführer | Yew Tree Cottage North Heath RG20 8UD Chieveley Newbury | British | 40555070001 | ||||||
| HENRY, Colin Glen | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | England | British | 185041040002 | |||||
| HOLT, David Leslie Frank | Geschäftsführer | Stonelow Flat Farm S42 7DE Eastmoor Derbyshire | British | 73659860001 | ||||||
| HOOPER, Mark | Geschäftsführer | 20 Grovelands Avenue SN1 4ET Swindon Wiltshire | England | British | 74493130001 | |||||
| JACKSON, Kenneth | Geschäftsführer | Flat 1 Hurlingham Court Ranelagh Gardens SW6 3SH London | British | 74203110001 | ||||||
| JOHHNSON, Rodney Norman Meredew | Geschäftsführer | 10 Wilson Ridge FOREIGN E Darien Connecticut 06820 Usa | British | 29573610001 | ||||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | England | British | 124967710001 | |||||
| LOMAX, Frank William | Geschäftsführer | Pipers 8 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 29573620001 | ||||||
| MACKENZIE, Andrew Macgregor | Geschäftsführer | 57 Broadwick Street London W1F 9QS | United Kingdom | British | 38695210004 |
Hat JAEGER HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 02. Dez. 2015 Geliefert am 18. Dez. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung L/H land at 2 livery street, leamington spa t/no WK471415 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Okt. 2015 Geliefert am 16. Okt. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung L/H 20-20A high street amersham bucks t/no BM306574 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 26. März 2014 Geliefert am 01. Apr. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 05. Apr. 2013 Geliefert am 16. Apr. 2013 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the loan note parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 16. Apr. 2012 Geliefert am 24. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 16. Apr. 2012 Geliefert am 24. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 13. Apr. 2012 Geliefert am 24. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 12. Mai 2010 Geliefert am 18. Mai 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Mai 2010 Geliefert am 18. Mai 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 16. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 35 bicester village bicester cheshire oaks unit 48 unit 13 great western designer outlet village churchwood swindon * please refer to form 395 for further details of property charged *. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. März 2003 Geliefert am 21. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 11. März 2003 Geliefert am 18. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Feb. 2003 Geliefert am 25. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1948 Geliefert am 25. Mai 1948 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Further security for a series of debentures aggregating £100,000 and a debenture for £130,000 dated 16 june 1921 | |
Kurze Angaben Forest house and land adjoining fronting leicester road and sullington road shipshed,leicestershire together with plant machinery fixtures implements and utensils present and future title no.p 177837. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1948 Geliefert am 25. Mai 1948 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Further security for a debenture dated 17 nov 1947 | |
Kurze Angaben Forest house and land adjoining fronting leicester rd.and sullington road,shipshed leicestershire together with plant machinery fixtures implements and utensils present and future.t/no.p 177837. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat JAEGER HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0