COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY
Überblick
Unternehmensname | COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 00019628 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7 Savoy Court WC2R 0EX London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP zum 7 Savoy Court London WC2R 0EX am 07. Jan. 2023 | 3 Seiten | AD01 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Feb. 2015 | 17 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Feb. 2015 | 17 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Feb. 2015 | 17 Seiten | 2.35B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Juli 2014 | 15 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Juli 2014 | 14 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Jan. 2014 | 15 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Aug. 2013 | 17 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||
Vorschlag des Verwalters | 20 Seiten | 2.17B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 262 Seiten | 2.16B | ||
Beendigung der Bestellung von Denise Brenda Robinson als Sekretär am 28. Feb. 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Suite 9 the Innovation Centre, Innovation Way Europarc, Grimsby, South Humberside, DN37 9TT, United Kingdom am 05. März 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
Wer sind die Geschäftsführer von COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSS, David Peter John | Geschäftsführer | Savoy Court WC2R 0EX London 7 | England | British | Director | 43841990004 | ||||
SANDS, Trevor Martin | Geschäftsführer | Savoy Court WC2R 0EX London 7 | United Kingdom | United Kingdom | Director | 164235220001 | ||||
CARRICK, Neil Richard | Sekretär | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | British | Chartered Accountant | 166312330001 | |||||
ROBINSON, Denise Brenda | Sekretär | Wellington Street LS1 4JP Leeds 33 West Yorkshire | 161118380001 | |||||||
WOOD, Frederick William | Sekretär | 5 Westlands Avenue DN34 4SP Grimsby North East Lincolnshire | British | 3783250001 | ||||||
BOLTON, David Martin | Geschäftsführer | 11 Harebell Hill KT11 2RS Cobham Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 47618000001 | ||||
BRIAN, Edward Arthur | Geschäftsführer | The Red House Coppice Lane RH2 9JF Reigate Surrey | British | Director | 1786140001 | |||||
CAMAMILE, Gerrard Hugh | Geschäftsführer | Brandon House 23 Lee Road LN2 4BJ Lincoln Lincolnshire | British | Chartered Accountant | 17499800001 | |||||
CARRICK, Neil Richard | Gesch äftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 166312330001 | ||||
DEAN, James Fitzroy | Geschäftsführer | East Mere House Bracebridge Heath LH4 2JB Lincoln Lincolnshire | England | British | Chartered Surveyor | 83206610001 | ||||
DOVER, Densmore Ronald | Geschäftsführer | 166 Furzehill Road WD6 2DS Borehamwood Hertfordshire | British | Member Of Parliament | 4248760001 | |||||
GILBERT, Simon George | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | United Kingdom | British | Partner | 124680260001 | ||||
HOBDEY, David William | Geschäftsführer | Woodlands Barn Risplith HG4 3EW Ripon North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 64819580003 | |||||
JONSSON, Per Anders | Geschäftsführer | 263 Petersham Road TW10 7DA Richmond Surrey | England | Swedish | Chief Executive | 189569310001 | ||||
KELLY, John Anthony Brian | Geschäftsführer | Fish Dock Road Grimsby DN31 3NW N E Lincolnshire | England | British | Company Director | 135315330001 | ||||
LEJMAN, Mark Timothy | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 153003320001 | ||||
LLOYD, Raoul Charles Francois | Geschäftsführer | Chilham 5 Park Drive DN32 0EE Grimsby South Humberside | British | Director | 3858760001 | |||||
MCCONNELL, John | Geschäftsführer | 12 Orme Court W2 4RL London | England | British | Graphic Design Consultant | 35560050002 | ||||
MELVILLE, Calum Gerrard | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | Scotland | British | Director | 77620530002 | ||||
MURRAY, John Kenneth | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | Scotland | British | Director | 135415610001 | ||||
NEVITT, Peter Thomas | Geschäftsführer | Carlbury Court Durham Lane Piercebridge DL2 3TW Darlington County Durham | United Kingdom | British | Company Director | 61356370001 | ||||
OPHIR, Yarom | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | Switzerland | Swiss | Company Director | 130890500001 | ||||
PEACOCK, Matthew Roy | Geschäftsführer | Villa Santa Maddalena Strada Santa Maddalena Amelia Tr 05022 Italy | Italy | British | Director | 104718150001 | ||||
PHILLIPS, Evan Devonald Winston | Geschäftsführer | Highfield House Ings Lane LN11 0TX Fotherby Lincolnshire | England | British | Company Director | 75342720006 | ||||
POWELL, Roderick Hugh Evelyn | Geschäftsführer | 319 South Union Street VA 22314 Alexandria United States | American | Company Director | 115964220001 | |||||
REYNOLDS, Michael Thomas | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | United Kingdom | British | Co Director | 4978610002 | ||||
THOMAS, Adrian Peter Harrison | Geschäftsführer | 26 Hartley Road WA14 4AY Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 26500450003 | ||||
WHITE, Maurice Alistair | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 41337310002 | ||||
WOOD, Frederick William | Geschäftsführer | Pleasant House Pleasant Place LN11 0NA Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 3783250004 |
Hat COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 31. Juli 2009 Geliefert am 15. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south east side of bell street fish quay northshields t/no TY308134,f/h land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/no's HS262302 and YEA3057, 60 sixhills street land and buildings to the south sixhills street and land and buidlings at convamore road and heneage road grimsby t/no's HS36616,HS114302,HS19612,HS18994,HS58210 and HS332319 and associated rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Juli 2009 Geliefert am 06. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south east side of bell street fish quay north shields t/no TY308134, f/h number 3 factory school road lowestoft and land lying on the west side of school lane lowestoft t/nos SK139594 and SK68171, f/h land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/nos HS262302 and YEA3057 (for details of further properties charged please refer to the form 395); any buildings fixtures fixed plant and machinery situated thereon. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 08. Apr. 2009 Geliefert am 19. Mai 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a and forming 18 palmerston road aberdeen. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 08. Apr. 2009 Geliefert am 12. Mai 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 18 palmerston road, aberdeen. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Share pledge | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 09. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title interest and benefit in and to the shares and/or other securities and all stocks shares and investments together with any dividends see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 09. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of the actual property charged please refer to the form 395). see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 04. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/no’s (for further details of property charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge over shares | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 04. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and the distribution rights from time to time accruing to or on the shares see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge over shares | Erstellt am 01. Aug. 2008 Geliefert am 06. Aug. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First legal mortgage, the shares and the distribution rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 1996 Geliefert am 23. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 15TH october 1990 | |
Kurze Angaben Land fronting clive street, north shields, tyne and wear. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Nov. 1995 Geliefert am 25. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a project finance agreement dated 15TH october 1990 | |
Kurze Angaben Premises situate and fronting to liddell street and clive street, north shields, tyne & wear. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Feb. 1993 Geliefert am 03. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 12/10/90 | |
Kurze Angaben Land at bell street north shields tyne and wear. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Juni 1992 Geliefert am 19. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the project finance agreement dated 12/10/90 | |
Kurze Angaben Land & buildings fronting on to liddell street north shields tyne and wear. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of substitution and charge. | Erstellt am 28. Nov. 1986 Geliefert am 03. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 29/12/86 as varied by a deed of variation and charge dated 13/5/86 | |
Kurze Angaben All that area of land containing 1,225 acres (5930 sq yds) or thereabouts together with the building known as number 3 factory and all other buildings and structures thereon situated at or near school road lowestoft. Suffolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 26. Sept. 1986 Geliefert am 07. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 24/8/70. | |
Kurze Angaben A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 22. Juli 1986 Geliefert am 25. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H premises scott lane, morley yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of verification and charge | Erstellt am 13. Mai 1986 Geliefert am 13. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £184,134.55 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 29/12/66. | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security registered at sasines on the 09/02/83 | Erstellt am 13. Okt. 1982 Geliefert am 17. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £22,500 | |
Kurze Angaben All and whole that area of fround in the parish of killirnie ayr extending to 1.692 acres together with the subjects k/a and forming stoney holm mill kilbirnie ayr. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Aircraft mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1980 Geliefert am 13. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000 | |
Kurze Angaben Aircraft - partenavia P6 8B reg mark g- bgxj (see doc M439 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Aircraft mortgage | Erstellt am 02. Juli 1980 Geliefert am 04. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000 | |
Kurze Angaben Aircraft partenavia P68B g-bgbt victor. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of rectification and charge | Erstellt am 30. Dez. 1974 Geliefert am 16. Jan. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 29.12.1966 and other deeds referred to therein. | |
Kurze Angaben Land at grimsby containing 9,833 sq yds (approx). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 15. Nov. 1971 Geliefert am 24. Apr. 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £42,835 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 1.45 acres at macanochie rd industrial estates, fraserburgh with all buildings erected thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of substitution and charge | Erstellt am 11. Nov. 1971 Geliefert am 15. Nov. 1971 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 and all other monies secured by a charge dated 31.12.1966 and deeds supplemental of thereto | |
Kurze Angaben Property on the north west side of fish dock rd, grimsby. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of confirmation and agreement | Erstellt am 27. Okt. 1969 Geliefert am 07. Nov. 1969 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 secured by a charge dated 29.12.1966 | |
Kurze Angaben Floating charge over the whole of the property which may from time to time be comprised in the property and undertaking of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage by ex-facia absolute disposition | Erstellt am 05. Sept. 1968 Geliefert am 16. Sept. 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing £375,000 due from the company to the chargee secured by & charges dated 27.3.1953, 25.4.1960, and 29.12.1960 respectively. | |
Kurze Angaben 3 pieces of land lying on the west side of market st and the north side o palmerston rd, aberdeen. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0