COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY

COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOSALT PUBLIC LIMITED COMPANY
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00019628
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7 Savoy Court
    WC2R 0EX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP zum 7 Savoy Court London WC2R 0EX am 07. Jan. 2023

    3 SeitenAD01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Feb. 2015

    17 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Feb. 2015

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Feb. 2015

    17 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Juli 2014

    15 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Juli 2014

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Jan. 2014

    15 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Aug. 2013

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    20 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    262 Seiten2.16B

    Beendigung der Bestellung von Denise Brenda Robinson als Sekretär am 28. Feb. 2013

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , Suite 9 the Innovation Centre, Innovation Way Europarc, Grimsby, South Humberside, DN37 9TT, United Kingdom am 05. März 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Wer sind die Geschäftsführer von COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROSS, David Peter John
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    Geschäftsführer
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    EnglandBritishDirector43841990004
    SANDS, Trevor Martin
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    Geschäftsführer
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    United KingdomUnited KingdomDirector164235220001
    CARRICK, Neil Richard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Sekretär
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant166312330001
    ROBINSON, Denise Brenda
    Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    33
    West Yorkshire
    Sekretär
    Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    33
    West Yorkshire
    161118380001
    WOOD, Frederick William
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    Sekretär
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    British3783250001
    BOLTON, David Martin
    11 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor47618000001
    BRIAN, Edward Arthur
    The Red House Coppice Lane
    RH2 9JF Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Red House Coppice Lane
    RH2 9JF Reigate
    Surrey
    BritishDirector1786140001
    CAMAMILE, Gerrard Hugh
    Brandon House
    23 Lee Road
    LN2 4BJ Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Brandon House
    23 Lee Road
    LN2 4BJ Lincoln
    Lincolnshire
    BritishChartered Accountant17499800001
    CARRICK, Neil Richard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant166312330001
    DEAN, James Fitzroy
    East Mere House
    Bracebridge Heath
    LH4 2JB Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    East Mere House
    Bracebridge Heath
    LH4 2JB Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritishChartered Surveyor83206610001
    DOVER, Densmore Ronald
    166 Furzehill Road
    WD6 2DS Borehamwood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    166 Furzehill Road
    WD6 2DS Borehamwood
    Hertfordshire
    BritishMember Of Parliament4248760001
    GILBERT, Simon George
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritishPartner124680260001
    HOBDEY, David William
    Woodlands Barn
    Risplith
    HG4 3EW Ripon
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodlands Barn
    Risplith
    HG4 3EW Ripon
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant64819580003
    JONSSON, Per Anders
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    EnglandSwedishChief Executive189569310001
    KELLY, John Anthony Brian
    Fish Dock Road
    Grimsby
    DN31 3NW N E Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Fish Dock Road
    Grimsby
    DN31 3NW N E Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director135315330001
    LEJMAN, Mark Timothy
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director153003320001
    LLOYD, Raoul Charles Francois
    Chilham 5 Park Drive
    DN32 0EE Grimsby
    South Humberside
    Geschäftsführer
    Chilham 5 Park Drive
    DN32 0EE Grimsby
    South Humberside
    BritishDirector3858760001
    MCCONNELL, John
    12 Orme Court
    W2 4RL London
    Geschäftsführer
    12 Orme Court
    W2 4RL London
    EnglandBritishGraphic Design Consultant35560050002
    MELVILLE, Calum Gerrard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector77620530002
    MURRAY, John Kenneth
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector135415610001
    NEVITT, Peter Thomas
    Carlbury Court Durham Lane
    Piercebridge
    DL2 3TW Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    Carlbury Court Durham Lane
    Piercebridge
    DL2 3TW Darlington
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director61356370001
    OPHIR, Yarom
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    SwitzerlandSwissCompany Director130890500001
    PEACOCK, Matthew Roy
    Villa Santa Maddalena
    Strada Santa Maddalena
    Amelia
    Tr 05022
    Italy
    Geschäftsführer
    Villa Santa Maddalena
    Strada Santa Maddalena
    Amelia
    Tr 05022
    Italy
    ItalyBritishDirector104718150001
    PHILLIPS, Evan Devonald Winston
    Highfield House
    Ings Lane
    LN11 0TX Fotherby
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Highfield House
    Ings Lane
    LN11 0TX Fotherby
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director75342720006
    POWELL, Roderick Hugh Evelyn
    319 South Union Street
    VA 22314 Alexandria
    United States
    Geschäftsführer
    319 South Union Street
    VA 22314 Alexandria
    United States
    AmericanCompany Director115964220001
    REYNOLDS, Michael Thomas
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritishCo Director4978610002
    THOMAS, Adrian Peter Harrison
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director26500450003
    WHITE, Maurice Alistair
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector41337310002
    WOOD, Frederick William
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChartered Accountant3783250004

    Hat COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 15. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south east side of bell street fish quay northshields t/no TY308134,f/h land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/no's HS262302 and YEA3057, 60 sixhills street land and buildings to the south sixhills street and land and buidlings at convamore road and heneage road grimsby t/no's HS36616,HS114302,HS19612,HS18994,HS58210 and HS332319 and associated rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Frederick William Wood,Ronald Briggs Heaton,Paul Arthur Bradbury,Alan Smith and Vincent Roger Whyte Mccracken (The "Pension Trustees")
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south east side of bell street fish quay north shields t/no TY308134, f/h number 3 factory school road lowestoft and land lying on the west side of school lane lowestoft t/nos SK139594 and SK68171, f/h land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/nos HS262302 and YEA3057 (for details of further properties charged please refer to the form 395); any buildings fixtures fixed plant and machinery situated thereon. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Standard security
    Erstellt am 08. Apr. 2009
    Geliefert am 19. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a and forming 18 palmerston road aberdeen.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 19. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security
    Erstellt am 08. Apr. 2009
    Geliefert am 12. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    18 palmerston road, aberdeen.
    Berechtigte Personen
    • The Pension Trustees, Frederick William Wood, Ronald Briggs Heaton, Paul Arthur Bradbury, Alan Smith, Vincent Rodger Whyte Mccracken
    Transaktionen
    • 12. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Share pledge
    Erstellt am 26. März 2009
    Geliefert am 09. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title interest and benefit in and to the shares and/or other securities and all stocks shares and investments together with any dividends see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Cimpany (UK) Limited (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Composite debenture
    Erstellt am 26. März 2009
    Geliefert am 09. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of the actual property charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Frederick William Wood, Ronald Briggs Heaton, Paul Arthur Bradbury, Alan Smith and Vincent Rodger Whyte Mccracken as the Trustees of the Cosalt Retirement Plan
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 26. März 2009
    Geliefert am 04. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/no’s (for further details of property charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Legal charge over shares
    Erstellt am 26. März 2009
    Geliefert am 04. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and the distribution rights from time to time accruing to or on the shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge over shares
    Erstellt am 01. Aug. 2008
    Geliefert am 06. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First legal mortgage, the shares and the distribution rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Apr. 1996
    Geliefert am 23. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 15TH october 1990
    Kurze Angaben
    Land fronting clive street, north shields, tyne and wear.
    Berechtigte Personen
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Nov. 1995
    Geliefert am 25. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a project finance agreement dated 15TH october 1990
    Kurze Angaben
    Premises situate and fronting to liddell street and clive street, north shields, tyne & wear.
    Berechtigte Personen
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 1993
    Geliefert am 03. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 12/10/90
    Kurze Angaben
    Land at bell street north shields tyne and wear.
    Berechtigte Personen
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transaktionen
    • 03. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 1992
    Geliefert am 19. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the project finance agreement dated 12/10/90
    Kurze Angaben
    Land & buildings fronting on to liddell street north shields tyne and wear.
    Berechtigte Personen
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transaktionen
    • 19. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of substitution and charge.
    Erstellt am 28. Nov. 1986
    Geliefert am 03. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 29/12/86 as varied by a deed of variation and charge dated 13/5/86
    Kurze Angaben
    All that area of land containing 1,225 acres (5930 sq yds) or thereabouts together with the building known as number 3 factory and all other buildings and structures thereon situated at or near school road lowestoft. Suffolk.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 12. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 26. Sept. 1986
    Geliefert am 07. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 24/8/70.
    Kurze Angaben
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juli 1986
    Geliefert am 25. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H premises scott lane, morley yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 25. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    Deed of verification and charge
    Erstellt am 13. Mai 1986
    Geliefert am 13. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £184,134.55 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 29/12/66.
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 12. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security registered at sasines on the 09/02/83
    Erstellt am 13. Okt. 1982
    Geliefert am 17. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £22,500
    Kurze Angaben
    All and whole that area of fround in the parish of killirnie ayr extending to 1.692 acres together with the subjects k/a and forming stoney holm mill kilbirnie ayr.
    Berechtigte Personen
    • Barbow Campbell Threads Limited
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1980
    Geliefert am 13. März 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000
    Kurze Angaben
    Aircraft - partenavia P6 8B reg mark g- bgxj (see doc M439 for details).
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central LTD
    Transaktionen
    • 13. März 1981Registrierung einer Belastung
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1980
    Geliefert am 04. Juli 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000
    Kurze Angaben
    Aircraft partenavia P68B g-bgbt victor.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central LTD
    Transaktionen
    • 04. Juli 1980Registrierung einer Belastung
    Deed of rectification and charge
    Erstellt am 30. Dez. 1974
    Geliefert am 16. Jan. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 29.12.1966 and other deeds referred to therein.
    Kurze Angaben
    Land at grimsby containing 9,833 sq yds (approx).
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance Company Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1975Registrierung einer Belastung
    • 12. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 15. Nov. 1971
    Geliefert am 24. Apr. 1972
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £42,835 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    1.45 acres at macanochie rd industrial estates, fraserburgh with all buildings erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • The County Council of Aberdeen
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1972Registrierung einer Belastung
    • 11. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of substitution and charge
    Erstellt am 11. Nov. 1971
    Geliefert am 15. Nov. 1971
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £250,000 and all other monies secured by a charge dated 31.12.1966 and deeds supplemental of thereto
    Kurze Angaben
    Property on the north west side of fish dock rd, grimsby.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance Company Limited
    Transaktionen
    • 15. Nov. 1971Registrierung einer Belastung
    • 12. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of confirmation and agreement
    Erstellt am 27. Okt. 1969
    Geliefert am 07. Nov. 1969
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £250,000 secured by a charge dated 29.12.1966
    Kurze Angaben
    Floating charge over the whole of the property which may from time to time be comprised in the property and undertaking of the company.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance Company Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1969Registrierung einer Belastung
    • 12. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage by ex-facia absolute disposition
    Erstellt am 05. Sept. 1968
    Geliefert am 16. Sept. 1968
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing £375,000 due from the company to the chargee secured by & charges dated 27.3.1953, 25.4.1960, and 29.12.1960 respectively.
    Kurze Angaben
    3 pieces of land lying on the west side of market st and the north side o palmerston rd, aberdeen.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance Company Limited
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1968Registrierung einer Belastung
    • 12. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Feb. 2015Ende der Verwaltung
    15. Feb. 2013Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Ross
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    David James Kelly
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0