TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00031254 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Forde als Geschäftsführer am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2020
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 79 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Michael Paterson als Direktor am 24. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David James Tannahill als Geschäftsführer am 24. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 24. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 000312540030 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 29 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Punch Taverns (Rh) Limited as a person with significant control on 04. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF zum Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE am 08. Sept. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francesca Appleby als Sekretär am 29. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOORE, Christopher John | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 136853310001 | ||||
MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | England | British | Director | 112375050001 | ||||
PATERSON, Sean Michael | Geschäftsführer | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | Finance Director | 257892140001 | ||||
APPLEBY, Francesca | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191629220001 | |||||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Sekretär | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175489890001 | |||||||
RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
TYRRELL, Helen | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161609290001 | |||||||
BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Geschäftsführer | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | Secretary | 637110001 | |||||
CONSTANTINE, Peter Anthony | Geschäftsführer | 83 South Rise CF14 0RG Cardiff South Glamorgan | Wales | British | Chartered Surveyor Estates Dir | 114160540001 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152083750001 | ||||
DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
FORDE, David | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | Director | 180590780001 | ||||
JONES, Bruce Abbott | Geschäftsführer | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | Company Director | 29595900002 | |||||
KEMP, Deborah Jane | Geschäftsführer | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | Director | 79388130005 | ||||
MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
TANNAHILL, David James | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | Director | 237381690001 | ||||
WHITEHEAD, Gordon William George | Geschäftsführer | Rosedale 24 Jacks Lane ST14 8LW Marchington Staffordshire | British | Accountant | 13507460001 | |||||
WILFORD, Nicholas James | Geschäftsführer | The Virgate Church Street Swepstone Coalville LE6 7SA Leicester Leicestershire | British | Chartered Surveyor | 33328990001 | |||||
WILKINSON, Anthony Eric | Geschäftsführer | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 4656080002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Uk Limited | 29. Aug. 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Punch Taverns (Rh) Limited | 06. Apr. 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TETLEY WALKER PRODUCTION LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 08. Okt. 2014 Geliefert am 15. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Third supplemental deed of charge | Erstellt am 03. Nov. 2003 Geliefert am 20. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 22. Apr. 2002 Geliefert am 08. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 22. Apr. 2002 Geliefert am 08. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A charge by way of first legal mortgage all of the company's right title interest and benefit present and future in to and under the freehold or leasehold property comprising the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge and all estates or interests in such property and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time on such freehold or leasehold property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 28. Juni 2000 Geliefert am 15. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein) | |
Kurze Angaben All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental trust deed. | Erstellt am 13. Sept. 1989 Geliefert am 18. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000,000 9 3/4% debenture stock 2019 of allied-lyons PLC created under this deed and all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as secured by this deed and deeds supplemental thereto. | |
Kurze Angaben By way of collateral security a first floating charge on the both present and future including any uncalled capital.. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Sixteenth supplemental trust deed | Erstellt am 16. Feb. 1989 Geliefert am 17. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000,000 9 3/4 % debenture stock 2019 of allied-lyons PLC constituted by this deed and all other moneys intended to be secured by this deed and various deeds (as defined) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben Present & future, including uncalled capital.. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 23. Nov. 1983 Geliefert am 25. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000,000 11 3/4% debenture stock 2009 of allied-lyons PLC | |
Kurze Angaben Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Equitable charge without instrument | Erstellt am 22. Juni 1983 Geliefert am 13. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000,000 debenture stock of allied lyons PLC | |
Kurze Angaben Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 15. März 1978 Geliefert am 30. März 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,352,930 7 per cent redeemable debenture stock 1982/87 of allied breweries limited and expressed to be supplemental to a trust deed dated 6TH june 1962 and thirteen deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Floating charge on the undertaking and assets for the time being of the company present and further wheresoever situate including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 04. Apr. 1972 Geliefert am 17. Apr. 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 redeemable debenture stock of allied breweries limited and expressed to be supplemental to a trust deed dated 6TH june 1962 and eleven deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Floating charge on undertaking assets & uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 11. März 1968 Geliefert am 25. März 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £12,000,000 redeemable debenture stock of allied breweries limited and expressed to be supplemental to a trust deed dated 6TH june 1962 and ten deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Floating charge on undertaking assets & uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 25. Aug. 1965 Geliefert am 07. Sept. 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 redeemable debenture stock of allied breweries limited and expressed to be supplemental to a trust deed dated 6TH june 1962 and eight deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Undertaking and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 16. Juni 1965 Geliefert am 17. Juni 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,000,000 redeemable debenture stock of allied breweries limited and expressed to be supplemental to a trust deed dated 6TH june 1962 and seven deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Undertaking and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
(1) trust deed and (2) trust deed | Erstellt am 14. Aug. 1964 Geliefert am 18. Aug. 1964 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Trust deed for securing £2,623,369 redeemable debenture stock of allied breweries limited and £10,000,000 redeemable debenture stock of allied breweries limited | |
Kurze Angaben (1) & (2) undertaking and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 19. Feb. 1964 Geliefert am 21. Feb. 1964 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,342,599 redeemable debenture stock of allied breweries limited and expressed to be supplemental to a trust deed dated 6TH june 1962 and to three deeds supplemental thereto dated 29TH august 1962, 29TH august 1962 and 18TH january 1963 respectively | |
Kurze Angaben Undertaking assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 18. Jan. 1963 Geliefert am 24. Jan. 1963 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing debenture stock £5,000,000 of ind coope tetley ansell limited and expressed to be supplemental to a trust deed dated 6TH june 1962 and to two deeds supplemental thereto each dated 29TH august 1962 | |
Kurze Angaben Undertaking and assets present and future including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 29. Aug. 1962 Geliefert am 03. Sept. 1962 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing £24,042,568 debenture stock of ind coope tetley ansell limited (inclusive of £23,202,533 previously outstanding) and expressed to be supplemental to two trust deeds dated 6TH june 1962 and 29TH august 1962 respectively | |
Kurze Angaben Undertaking and assets present and futur including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge by way of further or substituted security(supplemental to the debenture stock trust deed dated the 30TH may 1947) | Erstellt am 23. Sept. 1960 Geliefert am 29. Sept. 1960 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £800,000 2 1/4% 1ST mortgage debenture stock with a premium of 1% in certain events | |
Kurze Angaben All that piece of land situate on the north easterly side of church road halewood lancaster together with the public house and other buildings erected thereon known as the eagle & child inn halewood aforesaid. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge by way of further or substituted security (supplemental to the deneture stock trust deed dated the 30TH may 1947) | Erstellt am 19. Nov. 1954 Geliefert am 01. Dez. 1954 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £800,000 2 1/4% 1ST mortgage debenture stock with a premium of 1% in certain events | |
Kurze Angaben All that plot of land fronting to ledsham road little sutton in the county of chester together with the public house erected thereon and known as "travellers rest" and nod 14 ledsham road aforesaid. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge by way of further or substituted security (supplemental to the debenture stock trust deed dated the 30TH may 1947) | Erstellt am 10. Sept. 1953 Geliefert am 17. Sept. 1953 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £800,000 2 3/4% ist mortgage debenture stock with a premium of 1% in certain events | |
Kurze Angaben All that piece of and situate on the southerly side of prescot road fairfield liverpool together with the shop and dwellinghouse erected thereon and numbered 26A prescot road aforesaid. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 28. Sept. 1951 Geliefert am 10. Okt. 1951 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £800,000 debenture stock with a premium of 1% in certain events secured by a trust deed dated 30-5-47 | |
Kurze Angaben 5 mill lane, wallasey, cheshire and the benefit of the licence together with all fixtures fixed plant and machinery thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage by way of additional security (supplemental to trust deed dated 1 august 1890) | Erstellt am 08. Jan. 1942 Geliefert am 14. Jan. 1942 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 first mortgage debentures of the company, with a premium of 5% in certain events | |
Kurze Angaben F/H land situate on southwest side of greaves street and southeast side of denton street toxteth park liverpool. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage by way of additional security (supplemental to trust deed dated 1 august 1890 | Erstellt am 08. Dez. 1939 Geliefert am 11. Dez. 1939 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 first mortgage debentures of the company, with a premium of 5% in certain events | |
Kurze Angaben Freehold land & "the st. Georges tavern" nod. 238, 240 & 242 marsh lane, bootle, lancaster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage by way of additional security (supplemental to trust deed dated 1 august 1890) | Erstellt am 18. Okt. 1939 Geliefert am 26. Okt. 1939 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 first mortgage debentures of the company, with a premium of 5% in certain events | |
Kurze Angaben F/H land and premises formerly known as the "stamford arms" stamford street with 2 houses adjoining land and stables in gee street l/h land and workshop in dannett street, all in warrington lancaster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0