PILKINGTON'S TILES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePILKINGTON'S TILES LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00033221
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PILKINGTON'S TILES LIMITED?

    • (2625) /

    Wo befindet sich PILKINGTON'S TILES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp
    St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    M2 3ae
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PILKINGTON'S TILES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2010
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2010
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PILKINGTON'S TILES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. Aug. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung14. Sept. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PILKINGTON'S TILES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für PILKINGTON'S TILES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in Gläubigerinsolvenz

    3 SeitenREST-CVL

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    21 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2017

    23 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2017

    23 SeitenLIQ03

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    18 Seiten4.33

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2016

    22 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2015

    16 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp St. James's Square Manchester M2 6DS zum Kpmg Llp St Peter's Square Manchester M2 3AE M2 3AE am 30. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Juni 2014

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2013

    18 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2012

    26 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    28 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Dez. 2010

    29 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    23 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    38 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    77 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Po Box 4 Rake Lane Clifton Junction Manchester M27 8LP* am 23. Juli 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von PILKINGTON'S TILES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LLOYD, Stephen Paul
    3 The Meadows
    CH62 7JX Bromborough
    The Wirral
    Sekretär
    3 The Meadows
    CH62 7JX Bromborough
    The Wirral
    American98187130003
    ASHCROFT, Graham Edmund
    281 Brodie Avenue
    L19 7ND Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    281 Brodie Avenue
    L19 7ND Liverpool
    Merseyside
    British69185250001
    BANTON, David Stuart
    6 Glynrene Drive
    Wardley
    M27 9GL Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    6 Glynrene Drive
    Wardley
    M27 9GL Manchester
    Lancashire
    British108212780001
    CLARK, Stephen Jeremy
    8 Tennyson Close
    Heaton Mersey
    SK4 2ED Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    8 Tennyson Close
    Heaton Mersey
    SK4 2ED Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish60107140001
    LLOYD, Stephen Paul
    3 The Meadows
    CH62 7JX Bromborough
    The Wirral
    Geschäftsführer
    3 The Meadows
    CH62 7JX Bromborough
    The Wirral
    United KingdomAmerican98187130003
    TARR, Raymond Anthony Michael
    3 Aldford Place
    SK9 7RQ Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Aldford Place
    SK9 7RQ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish19212810002
    TURNER, Katie Louise
    45 Angelbank
    BL6 5GX Horwich
    Lancashire
    Geschäftsführer
    45 Angelbank
    BL6 5GX Horwich
    Lancashire
    British118790850001
    WHITELEY, Sean
    2 Windlehurst Hall
    Andrew Lane High Lane
    SK6 8HG Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    2 Windlehurst Hall
    Andrew Lane High Lane
    SK6 8HG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish60402070001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Sekretär
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    British118171450001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Sekretär
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    British118171450001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Sekretär
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    British77855520001
    RIDINGS, Nicholas Andrew
    Heath Cottage
    7 Pennys Lane
    CW9 7SJ Lach Dennis
    Cheshire
    Sekretär
    Heath Cottage
    7 Pennys Lane
    CW9 7SJ Lach Dennis
    Cheshire
    British48835840001
    ROBERTS, Timothy Guy
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    Sekretär
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    British127918950001
    WALKER, Stephen Michael
    62 Kennerley Road
    Davenport
    SK2 6EY Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    62 Kennerley Road
    Davenport
    SK2 6EY Stockport
    Cheshire
    British15125620001
    WHITELEY, Sean
    2 Windlehurst Hall
    Andrew Lane High Lane
    SK6 8HG Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    2 Windlehurst Hall
    Andrew Lane High Lane
    SK6 8HG Stockport
    Cheshire
    British60402070001
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    Sekretär
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    75491680001
    BELL, Stephen John
    3 Grazing Lane
    Webheath
    B97 5PE Redditch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    3 Grazing Lane
    Webheath
    B97 5PE Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish75074050001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish118171450001
    BREEZE, Stevan William
    The Hamlet Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Hamlet Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British82679240001
    BROOK, Nigel Charles
    The Spinney 170 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8SB Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Spinney 170 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8SB Stockport
    Cheshire
    British69544700001
    BROWN, Robert Casson
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    British6343100001
    CROWTHER, Ian
    19 The Burrows
    Cuddington
    CW8 2UG Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    19 The Burrows
    Cuddington
    CW8 2UG Northwich
    Cheshire
    British31205800001
    DOW, Warren Alexander
    4 Berriedale Terrace
    LA11 6ER Grange Over Sands
    Cumbria
    Geschäftsführer
    4 Berriedale Terrace
    LA11 6ER Grange Over Sands
    Cumbria
    United KingdomBritish108212830001
    FILDES, Hilary
    Tarrant Close
    Tarrant Hinton
    DT11 8JA Blandford Forum
    Dorset
    Geschäftsführer
    Tarrant Close
    Tarrant Hinton
    DT11 8JA Blandford Forum
    Dorset
    British15125630001
    GARRIDO, Antonio
    The Willows
    30 Moseley Road Cheadle Hulme
    SK8 5HJ Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Willows
    30 Moseley Road Cheadle Hulme
    SK8 5HJ Stockport
    Cheshire
    British102777480001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    British77855520001
    HUGHES, Mary-Lorraine, Dr
    12 Dingle Lane
    CW11 1FY Sandbach
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Dingle Lane
    CW11 1FY Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritish67402160001
    HULSE, David Alan
    22 Muirfield Drive
    Mickleover
    DE3 9YA Derby
    Geschäftsführer
    22 Muirfield Drive
    Mickleover
    DE3 9YA Derby
    British81492680001
    KENWORTHY BLAMIRE, Lesley-Anne
    80 Ringley Road
    Radcliffe
    M26 1ET Ringley
    Manchester
    Geschäftsführer
    80 Ringley Road
    Radcliffe
    M26 1ET Ringley
    Manchester
    British60771730001
    KNAPPETT, John Edwin, Dr
    25 Green Gate
    Halebarns
    WA15 0SH Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    25 Green Gate
    Halebarns
    WA15 0SH Altrincham
    Cheshire
    British27882590001
    MAYER, Michael Ian, Dr
    17 Firbank
    Euxton
    PR7 6HP Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    17 Firbank
    Euxton
    PR7 6HP Chorley
    Lancashire
    British28654860001
    MORRIS, Christine
    9 Longdale Avenue
    Ravenshead
    NG15 9EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    9 Longdale Avenue
    Ravenshead
    NG15 9EA Nottingham
    Nottinghamshire
    British31206090001
    O'DONOVAN, Kathleen Anne
    3c Cintra Park
    Upper Norwood
    SE19 2LH London
    Geschäftsführer
    3c Cintra Park
    Upper Norwood
    SE19 2LH London
    United KingdomBritish34401390005
    ROBERTS, Timothy Guy
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish127918950001
    SADLER, Patricia Ann
    3 Lingley Road
    Great Sankey
    WA5 3ND Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Lingley Road
    Great Sankey
    WA5 3ND Warrington
    Cheshire
    British15125640001

    Hat PILKINGTON'S TILES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 23. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Mai 2004
    Geliefert am 07. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment relating to credit insurance
    Erstellt am 28. Mai 2004
    Geliefert am 07. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of absolute assignment and with full title guarantee the trade credit insurance policy with gerling ncm (now k/a atradius N.v) policy number 621663.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over deposit
    Erstellt am 09. Feb. 2004
    Geliefert am 18. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All present and future rights, titles and benefit in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Feb. 2004
    Geliefert am 11. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment relating to credit insurance
    Erstellt am 09. Feb. 2004
    Geliefert am 14. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of absolute assignment the trade credit insurance policy with gerling ncm policy number 621663.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Feb. 2004
    Geliefert am 14. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land 28 blandford road poole dorset t/n DT302424, f/h land and buildings at lower hamworthy poole dorset t/n DT235032 and f/h land at clifton junction swinton t/n GM713128. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 2004
    Geliefert am 11. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 28 blandford road poole t/no DT302424 floating charge all unfixed plant machinery and other chattels present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 2004
    Geliefert am 11. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings at lower hamworthy poole t/no DT235032 floating charge all unfixed plant machinery and other chattels present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 21. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property k/a 28 blandford road poole BH15 4BD t/no DT302424. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Apr. 2002
    Geliefert am 23. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as land at clifton junction, swinton, salford, greater manchester t/n GM713128. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Apr. 2002
    Geliefert am 23. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as land as buildings at lower hamworthy, poole t/n DT235032. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juli 1997
    Geliefert am 30. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juli 1997
    Geliefert am 30. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Kurze Angaben
    F/H land at knoll lane corfe mullen wimborne dorest t/n-DT88806 and land at knoll lane corfe mullen wimborne dorset t/n-DT239714 by way of fixed charge all buildings and other structures, goodwill, all plant machinery and other items, the proceeds of any claim made under any insurance policy, by way of assignment all rents, profits, income, fees and other sums; by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Feb. 1996
    Geliefert am 04. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (I) f/hold land known as the clay pit,knoll lane,corfe mullen,wimborne,dorset; dt 88806. (ii) l/hold land/blds known as cheapside mills,bradford rd,batley,west yorkshire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC,as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 04. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PILKINGTON'S TILES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Juni 2011Ende der Verwaltung
    14. Juni 2010Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    2
    DatumTyp
    16. Juni 2011Beginn der Liquidation
    10. Apr. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praktiker
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0