JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY

JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00035160
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • (1723) /

    Wo befindet sich JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Snow Hill
    London
    EC1A 2EN
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am28. Feb. 2003
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am28. Sept. 2003
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis19. Juli 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung02. Aug. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in Zwangsliquidation

    3 SeitenREST-COCOMP

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Simon Charles Hathaway als Geschäftsführer am 31. Okt. 2014

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 26. Aug. 2008

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Verschiedenes

    Form 3.2 - statement of affairs
    23 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    7 Seiten3.10

    Vermögensübersicht in der Zwangsverwaltung nach Bericht an die Gläubiger

    24 Seiten3.3

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten288b

    Konzernabschluss erstellt bis zum 29. Feb. 2000

    34 SeitenAA

    legacy

    10 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    52 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OXLEY, Steven Anthony
    25 Kensington Road
    Birdcage Lane
    HX3 0HN Halifax
    West Yorkshire
    Sekretär
    25 Kensington Road
    Birdcage Lane
    HX3 0HN Halifax
    West Yorkshire
    British38082370001
    LA KJAER, Dirch Cornelius
    405-410 Radnor House
    93-97 Regent Street
    W1R 7TD London
    Geschäftsführer
    405-410 Radnor House
    93-97 Regent Street
    W1R 7TD London
    Danish63652330002
    OXLEY, Steven Anthony
    25 Kensington Road
    Birdcage Lane
    HX3 0HN Halifax
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    25 Kensington Road
    Birdcage Lane
    HX3 0HN Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritish38082370001
    WAITE, John Nigel Michael
    The Old House
    Water End
    HP1 3BH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Old House
    Water End
    HP1 3BH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British75356250003
    BUTLER, Nicholas Sowden
    Cedar Croft
    Great Ouseburn
    YO26 9RG York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Cedar Croft
    Great Ouseburn
    YO26 9RG York
    North Yorkshire
    British24135120001
    CRESWICK, Graham Michael
    Fairview Farmhouse
    Brackenthwaite Lane Pannal
    HG3 1PL Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    Fairview Farmhouse
    Brackenthwaite Lane Pannal
    HG3 1PL Harrogate
    North Yorkshire
    British93409870001
    WATKINSON, Carol Anne
    The House In The Woods
    Brockwell Triangle
    HX6 3PH Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Sekretär
    The House In The Woods
    Brockwell Triangle
    HX6 3PH Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British40920610001
    ALLEN, David William
    11 Hunters Court
    SK15 2UH Stalybridge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    11 Hunters Court
    SK15 2UH Stalybridge
    Cheshire
    United KingdomBritish16023190001
    BROOK, Clive Richard
    15 Wellhead Mews
    Chapelthorpe
    WF4 3JG Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 Wellhead Mews
    Chapelthorpe
    WF4 3JG Wakefield
    West Yorkshire
    British61092790001
    COLLINS, Simon Antony Cooper
    15 New Laithe Close
    BD23 6AZ Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 New Laithe Close
    BD23 6AZ Skipton
    North Yorkshire
    British37806120003
    COOPER, David Alan Irwin
    15 St Stephens Avenue
    KT21 1PJ Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 St Stephens Avenue
    KT21 1PJ Ashtead
    Surrey
    British42082470001
    CRESWICK, Graham Michael
    Fairview Farmhouse
    Brackenthwaite Lane Pannal
    HG3 1PL Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fairview Farmhouse
    Brackenthwaite Lane Pannal
    HG3 1PL Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish93409870001
    FOSTER, Neil William Derick
    Lexham Hall
    PE32 2QJ Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Lexham Hall
    PE32 2QJ Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish13693760001
    GARNETT, Martin John
    Mouldsworth House
    Chapel Lane
    CH3 8AP Mouldsworth
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Mouldsworth House
    Chapel Lane
    CH3 8AP Mouldsworth
    Cheshire
    United KingdomBritish40212170001
    GILES, Peter Hardwick
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish35521860001
    GOLDIE MORRISON, Keith Cooper
    125 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SD London
    Geschäftsführer
    125 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SD London
    British40909220002
    HALLIDAY, Keith Arthur
    24 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    West Yorkshire
    British11629740001
    HATHAWAY, Simon Charles
    1 Oulton Crescent
    EN6 3ED Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Oulton Crescent
    EN6 3ED Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish42082540002
    HORSMAN, David Raistrick
    3 The Grove
    Moorhead
    BD18 4LD Shipley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 The Grove
    Moorhead
    BD18 4LD Shipley
    West Yorkshire
    British38046360001
    MACKAY, Gordon
    35 Laund Road
    Salendine Nook
    HD3 3TT Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    35 Laund Road
    Salendine Nook
    HD3 3TT Huddersfield
    West Yorkshire
    British36347250001
    MAGUIRE, Vivian James
    Northridge East Hill
    South Bank
    TN16 1EN Westerham
    Kent
    Geschäftsführer
    Northridge East Hill
    South Bank
    TN16 1EN Westerham
    Kent
    EnglandIrish28977350001
    MASSIE, David Laurence, The Estate Of
    5 Alan Road
    Wimbledon
    SW19 7PT London
    Geschäftsführer
    5 Alan Road
    Wimbledon
    SW19 7PT London
    EnglandBritish37533940002
    PAGE, Roy
    8 Windsor Court
    FY6 7UX Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Windsor Court
    FY6 7UX Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British64642210004
    SPENCER, Barrymore James
    The Hollies
    Croft
    PE24 4SH Skegness
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Croft
    PE24 4SH Skegness
    Lincolnshire
    British33523440001
    TAYLOR, Paul Duncan
    Oakwood House
    Upper Batley
    WF17 0AL Batley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Oakwood House
    Upper Batley
    WF17 0AL Batley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish12028870001
    WATSON, Victor Hugo
    Moat Field Moor Lane
    East Keswick
    LS17 9ET Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Moat Field Moor Lane
    East Keswick
    LS17 9ET Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish53162800001
    WAXMAN, Albert Abraham
    11 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    EnglandBritish1540730001

    Hat JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 06. Sept. 1995
    Geliefert am 12. Sept. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2002Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 07. Juni 2006Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 1993
    Geliefert am 13. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land adjoining brighouse road queensbury bradford of factory shop and car park for black dyke mills. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 1993
    Geliefert am 13. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land in part adjoining and to the south of high streety queensbury bradford and fronting broomfield street,mount pleasant street and spring gardens. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 1993
    Geliefert am 13. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land near junction of brighouse road with bradford road queeensbury. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 1993
    Geliefert am 13. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H black dyke mills queensbury bradford. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 1993
    Geliefert am 13. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land adjoining alexaander street and chapel lane queensburyt bradford. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 1993
    Geliefert am 13. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land fronting to sandbeds at queensbury of allotment gardens and lock up garages. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a being the remaining part of upper dean stones halifax west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a part of the former gas works opposite black dyke mills queensbury bradford west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a as land off high street queensbury bradford west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a black dyke mills and the major part of the estate of john foster & son PLC situate at queensbury bradford west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land forming the remaining part of upper and lower collier syke and green lane top farms halifax west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a two plots of land extending in the whole to 104 sq yrds or thereabouts near to the old queensbury railway station queensbury bradford west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 1992
    Geliefert am 23. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a russell hall farm queensbury bradford west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. Nov. 1992
    Geliefert am 14. Nov. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    01.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture,
    Erstellt am 14. Sept. 1992
    Geliefert am 17. Sept. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC.
    Transaktionen
    • 17. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)

    Hat JOHN FOSTER & SON PUBLIC LIMITED COMPANY Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Sept. 1995Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark James Shaw
    Moore Stephens
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    Praktiker
    Moore Stephens
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    Phillip Rodney Sykes
    Moore Stephens Corporate Recover
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    Praktiker
    Moore Stephens Corporate Recover
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    2
    DatumTyp
    07. Feb. 2007Abschluss der Liquidation
    07. Feb. 2017Aufgelöst am
    29. Aug. 2002Antragsdatum
    10. Dez. 2002Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Leeds
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    Praktiker
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0