YATES'S WINE LODGES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameYATES'S WINE LODGES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00038397
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von YATES'S WINE LODGES LIMITED?

    • (5540) /

    Wo befindet sich YATES'S WINE LODGES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Zolfo Cooper Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von YATES'S WINE LODGES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    YATES BROTHERS LIMITED31. Dez. 198131. Dez. 1981
    ROCHDALE VINTNERS COMPANY,LIMITED (THE)14. März 189314. März 1893

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YATES'S WINE LODGES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Feb. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für YATES'S WINE LODGES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2011

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Sept. 2010

    6 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    18 Seiten2.34B

    legacy

    1 Seiten287

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. März 2009

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. März 2009

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Sept. 2008

    16 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von YATES'S WINE LODGES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    KEEN, Christian
    The Paddock
    Alverton
    NG13 9PB Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Paddock
    Alverton
    NG13 9PB Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish117424240001
    BEE, John Derek
    Hollowforth Mill Cottage
    Hollowforth Lane Woodplumpton
    PR4 0BD Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Hollowforth Mill Cottage
    Hollowforth Lane Woodplumpton
    PR4 0BD Preston
    Lancashire
    British46464230001
    COOPER, Andrew James
    9 Grenfell Road
    M20 6TG Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    9 Grenfell Road
    M20 6TG Manchester
    Lancashire
    British63484760001
    HODDINOTT, Ruth Elizabeth
    12 Waterside House Chandlers Row
    Worsley
    M28 2BW Manchester
    Sekretär
    12 Waterside House Chandlers Row
    Worsley
    M28 2BW Manchester
    British56095180001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Sekretär
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    WALKER, Philip
    Forest Bank Cottage 1 Forest Lane
    Barrowford
    BB9 6QL Nelson
    Lancashire
    Sekretär
    Forest Bank Cottage 1 Forest Lane
    Barrowford
    BB9 6QL Nelson
    Lancashire
    British35437590003
    NEWHALL NOMINEES LIMITED
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    Sekretär
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    18182520002
    BAKER, Suzanne Louise
    Lincoln House
    Rouse Court
    SL9 0NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lincoln House
    Rouse Court
    SL9 0NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish35409580006
    BROOK, Julie Helene
    Whisterfield Farm Whisterfield Lane
    Siddington
    SK11 9DB Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Whisterfield Farm Whisterfield Lane
    Siddington
    SK11 9DB Macclesfield
    Cheshire
    British57140740002
    BROWN, Aaron Maxwell
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    Geschäftsführer
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    United KingdomBritish98928830002
    BROWN, Stephen John
    17 Mill Road
    SL7 1PX Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    17 Mill Road
    SL7 1PX Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish102228010001
    BURBIDGE, Stephen
    24 Brownhill Lane
    OL3 6BZ Saddleworth
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Brownhill Lane
    OL3 6BZ Saddleworth
    Yorkshire
    EnglandBritish118573020001
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British13332510001
    FOWLER, Stevan Lloyd
    The Tower House
    Kirkless Hall Clifton
    HD6 4DH Brighouse
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Tower House
    Kirkless Hall Clifton
    HD6 4DH Brighouse
    Yorkshire
    British88380470001
    GERRARD, Philip Neil
    Halycon 4 Elmfield Road
    WN1 2RG Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Halycon 4 Elmfield Road
    WN1 2RG Wigan
    Lancashire
    British48885080001
    GREEN, Jeremy John
    Hunters Wood
    Northwich Road,Cranage
    CW4 8HL Holmes Chapel
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hunters Wood
    Northwich Road,Cranage
    CW4 8HL Holmes Chapel
    Cheshire
    United KingdomBritish2718520003
    GRUNNELL, Mark
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    Geschäftsführer
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    United KingdomBritish94144450002
    HENNESSY, Michael John Windsor
    Barn Close Riddings Lane
    Curbar Calver
    S32 3YT Hope Valley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Barn Close Riddings Lane
    Curbar Calver
    S32 3YT Hope Valley
    South Yorkshire
    British34175020002
    JONES, Mark Vincent
    The Hollies
    Hawley Lane, Halebarns
    WA15 0DR Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Hawley Lane, Halebarns
    WA15 0DR Altrincham
    Cheshire
    British84725550002
    LEWIS, Michael Collin
    Broxburn 12 Salisbury Street
    S75 2TL Barnsley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Broxburn 12 Salisbury Street
    S75 2TL Barnsley
    South Yorkshire
    British16901800002
    MARCALL, Raymond George
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish3977340001
    MARTIN-BIRD, Christopher Jelf
    Clay House Farm Clay Lane
    Mobberley
    WA16 7BH Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Clay House Farm Clay Lane
    Mobberley
    WA16 7BH Knutsford
    Cheshire
    British16735350001
    MEGGITT, Timothy Andrew
    7 Park House
    Kirklees Hall, Clifton
    HD6 4HD Brighouse
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 Park House
    Kirklees Hall, Clifton
    HD6 4HD Brighouse
    West Yorkshire
    British57975880002
    MITCHINSON, Brian
    Wansford House
    16 Wansford Way Summerley Estate
    PO22 7NL Felpham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Wansford House
    16 Wansford Way Summerley Estate
    PO22 7NL Felpham
    West Sussex
    British77665680001
    PAYNE, Ian Timothy
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    EnglandBritish78974110003
    ROWLINSON, Colin
    Copt Hill Shaw
    Alcocks Lane
    KT20 6BB Kingswood
    Surrey
    Geschäftsführer
    Copt Hill Shaw
    Alcocks Lane
    KT20 6BB Kingswood
    Surrey
    British77454060001
    SHEPHERD, Simon John
    6 Canterbury Close
    L37 7HY Formby
    Merseyside
    Geschäftsführer
    6 Canterbury Close
    L37 7HY Formby
    Merseyside
    EnglandBritish42257450002
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Geschäftsführer
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    SYMONDS, Paul
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish80167420001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish190689780001

    Hat YATES'S WINE LODGES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 19. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever and all monies due or to become due from any obligor to the chargee or any other finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a heron house, albert square, manchester t/no GM787611. L/h property k/a unit e, wilmslow road, didsbury t/no GM794080. L/h property k/a ground floor, block a, civic centre, riverside, stafford and l/h property k/a 96 charing cross road, london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Apr. 2006
    Geliefert am 26. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a basement 13 kensington high street london, l/h property k/a part of the back yard and roof space above the plant room above the plant room at 13 kensington high street london, l/h property k/a ground floor riverside house water lane richmond surrey t/nos SGL452493 and SGL498060. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 2006
    Geliefert am 25. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 25 bucklesbury house london , l/h 9 high street harpenden hertfordshire and l/h 29-33 winchester street basingstoke t/no hp 562020 for details of further properties charged please refer to form 395.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H properties k/a town hall, heron house, albert square, manchester t/n GM787611, 38 warwick street, leamington spa t/n WK404048 and herald buildings, montpellier parade, harrogate t/n NYK196874 for details of further properties charged please refer to from 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Feb. 2006
    Geliefert am 27. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 63/67 broad street banbury t/no ON223691,l/h property k/a 32-34 borough high street london t/no TGL177044,l/h property k/a unit 3 the embassy centre grand parade skegness t/no LL19713 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Feb. 2006
    Geliefert am 27. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 100 high street crawley west sussex t/no WSX238985,l/h property k/a cirrus house lower claremount bank victoria quay t/no SL159390,l/h property k/a 11 kensington high street london t/no BGL30089 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 2006
    Geliefert am 15. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties or any other finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a slug & lettuce, ground floor, 27/28 southgate, chichester, the l/h property k/a 9-13 lord street, leigh , great manchester t/no GM907590 and the l/h property k/a 55 yorkshire street, oldham, greater manchester t/no GM902160 for further property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 2006
    Geliefert am 15. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 1 islington green, london, the l/h property k/a the havana bar, 490 fulham road, the l/h property k/a slug & lettuce, ground floor and part basement, 100 fenchurch street, london for further property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Jan. 2006
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 41 corn street, bristol t/no BL52910, l/h property k/a part pearl house, greyfriars road, cardiff t/no WA965103, l/h property k/a 138A and 138B high street, sevenoaks t/no K817267, for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch 'Security Trustee'
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 2005
    Geliefert am 13. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 47 market place long eaton t/n DY351895, the l/h property known as litten tree basement ground and first floor 89/91 high street leicester t/n LT326834, the l/h property known as unit 1 33-39 church street lancaster t/n LA924278 and LA930829, for details of further property charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 2005
    Geliefert am 06. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being l/h property k/a 49/50 frogmoor, high wycombe t/no BM277410; l/h property k/a 39-41 watergate street, chester t/no CH413744 and l/h property k/a 26/28 st nicholas street, bristol t/no BL59735, for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 06. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being part basement ground and first floor premises k/a unit a, 58 commercial road, hereford. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 20TH may 2005 and
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 15. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    54 to 56 duke street barrow in furness t/no CU209679, 20 to 22 london street basingstoke t/no HP659672 and 2 mayplace road west bexleyheath t/no SGL665724 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 23. Juni 2005
    Geliefert am 01. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the secured parties) or to the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture creating fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 03. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the secured parties) or to the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 22. Okt. 2004
    Geliefert am 28. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Target group debenture
    Erstellt am 10. Sept. 2004
    Geliefert am 15. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat YATES'S WINE LODGES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Sept. 2009Ende der Verwaltung
    27. März 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    James John Gleave
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    09. Nov. 2012Aufgelöst am
    28. Sept. 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    James John Gleave
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0