THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00038832 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY(THE) | 10. Mai 1893 | 10. Mai 1893 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Aviva Wellington Row York North Yorkshire YO90 1WR England zum 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS am 09. Juli 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Karina Jane Bye als Direktor am 29. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Amy Victoria Gwynne Garvin als Geschäftsführer am 29. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Linda Hall als Geschäftsführer am 29. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Rowley Rose als Direktor am 29. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clair Louise Marshall als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Amy Victoria Gwynne Garvin als Direktor am 31. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Linda Hall als Direktor am 31. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Aviva Company Secretarial Services Limited als Geschäftsführer am 31. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Aviva Director Services Limited als Geschäftsführer am 24. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 Rougier Street York YO90 1UU zum Aviva Wellington Row York North Yorkshire YO90 1WR am 29. Feb. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Jane Wilman als Geschäftsführer am 31. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Clair Louise Marshall als Direktor am 01. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom |
| 1278390004 | ||||||||||
| BYE, Karina Jane | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 239237640001 | |||||||||
| ROSE, David Rowley | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||||||
| BOURNER, Penelope Ellen Moira | Sekretär | 30 Saint Peters Road West Mersea CO5 8LJ Colchester Essex | British | 63901950001 | ||||||||||
| HOWLETT, Annette Frances | Sekretär | 2 Newfound Drive Cringleford NR4 7RY Norwich Norfolk | British | 51808770001 | ||||||||||
| JONES, Edward Graham | Sekretär | 61 The Street Brundall NR13 5LZ Norwich Norfolk | British | 33670360003 | ||||||||||
| STANFORTH, John David | Sekretär | 8 Surrey Street NR1 3NG Norwich Norfolk | British | 34926770001 | ||||||||||
| UTTING, Harry William | Sekretär | 17 Bishops Close NR7 0EH Norwich Norfolk | British | 5286930001 | ||||||||||
| WHITE, Philip Martin | Sekretär | 5 Buttacre Lane Askham Richard YO23 3PE York | British | 41789910004 | ||||||||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 1278390004 | |||||||||||
| BASSET, Bryan Ronald | Geschäftsführer | 67 Cottesmore Court Stamford Road W8 5QW Kensington London | British | 37804060002 | ||||||||||
| BIGGS, Michael Nicholas | Geschäftsführer | 415 Unthank Road NR4 7QB Norwich Norfolk | British | 28234260001 | ||||||||||
| BIGGS, Michael Nicholas | Geschäftsführer | 415 Unthank Road NR4 7QB Norwich Norfolk | British | 28234260001 | ||||||||||
| BRIDGEWATER, Allan | Geschäftsführer | 30 St Mary Axe EC3A 8EP London | British | 484540003 | ||||||||||
| BUXTON, Andrew Edward | Geschäftsführer | Hoveton Hall Wroxham NR12 8RJ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 21920860003 | |||||||||
| CALVER, Ronald | Geschäftsführer | 16 Wentworth Green NR4 6AE Norwich Norfolk | British | 37627040001 | ||||||||||
| CATOR, Francis | Geschäftsführer | The Old House Ranworth NR13 6HS Norwich Norfolk | British | 10596830001 | ||||||||||
| CLEMINSON, James Arnold Stacey, Sir | Geschäftsführer | Loddon Hall Hales NR14 6TB Norfolk | British | 22530210003 | ||||||||||
| COPEMAN, Geoffrey Henry Charles | Geschäftsführer | Willows Farm Weston Longville NR9 5LG Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 484580001 | |||||||||
| COURTENAY-SMITH, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | Hillcrest Mount Pleasant NR2 2DG Norwich Norfolk | British | 38586970004 | ||||||||||
| FALCON, Michael Gascoigne | Geschäftsführer | Keswick Old Hall NR4 6TZ Norwich Norfolk | England | British | 1922950001 | |||||||||
| GARVIN, Amy Victoria Gwynne | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 237531640001 | |||||||||
| HALL, Linda | Geschäftsführer | Wellington Row YO90 1WR York Aviva North Yorkshire England | United Kingdom | British | 180622890001 | |||||||||
| HARVEY, Richard John | Geschäftsführer | 33 Burnsall Street Chelsea SW3 3SR London | British | 73191390001 | ||||||||||
| HEYWORTH-DUNNE, James Anthony | Geschäftsführer | Smallburgh Hall Smallburgh NR12 9NW Norwich | British | 45398490002 | ||||||||||
| HOLMES, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | The Old Rectory Shotesham All Saints NR15 1YL Norwich Norfolk | British | 484600001 | ||||||||||
| KELLY, Thomas Anthony | Geschäftsführer | The Hollies 89 The Street Brooke NR15 1JT Norwich Norfolk | British | 1147200001 | ||||||||||
| KEYS, David Chaloner | Geschäftsführer | Tower Hill House Tower Hill RH4 2AP Dorking Surrey | British | 13890050001 | ||||||||||
| LEAKE, Nigel Paul | Geschäftsführer | 15 Hinckley Road Burton Hastings CV11 6RG Nuneaton Warwickshire | British | 36807440001 | ||||||||||
| MARSHALL, Clair Louise | Geschäftsführer | Wellington Row YO90 1WR York Aviva United Kingdom | United Kingdom | British | 200178890001 | |||||||||
| MILLS, Albert Gordon | Geschäftsführer | Rossacre Church Lane Wicklewood Wymondham NR18 9QH Norwich Norfolk | British | 19967790002 | ||||||||||
| PARTRIDGE, Michael John Anthony, Sir | Geschäftsführer | 27 High View HA5 3NZ Pinner Middlesex | England | British | 28205070001 | |||||||||
| PAUL, George William | Geschäftsführer | Bluegates Wherstead IP9 2AU Ipswich Suffolk | England | British | 1724130001 | |||||||||
| PEEL, Jonathan Sidney, Reverend | Geschäftsführer | Barton Hall Barton Turf NR12 8AU Norwich Norfolk | British | 484620001 | ||||||||||
| PERELMAN, Alan Steven | Geschäftsführer | 66 Woodside Avenue Highgate N6 4ST London | British And Australian | 78359020001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Life & Pensions Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Wellington Row YO90 1WR York Aviva United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Agreement in respect of a deposit and pledge | Erstellt am 11. Juni 1997 Geliefert am 28. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All payment and indemnity obligations of the company to the chargee under the pledge agreement and deed of indemnity dated 11TH june 1997 including but not limited to the obligations by the company to buy a loan (the loan) of an amount of £158,200,000 from the chargee to winchester property investments limited made under an agreement dated 11TH june 1997 pursuant to the terms and conditions of the pledge agreement for an amount equal to the monies due to the chargee in respect of the loan and under the pledge agreement or the deed of indemnity | |
Kurze Angaben The registered certificate of deposit issued by the bank documented by an inscription in a special register held by the bank and representing the deposit of an amount of £158,200,000 placed in cash by the company with the bank on 11TH june 1997 and held in account number 196899. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement in respect of a deposit and pledge (the "pledge agreement") | Erstellt am 26. März 1997 Geliefert am 12. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the "pledge agreement" and a deed of indemnity of even date including, but not limited to, the obligation by the company to buy a loan of an amount of £58,275,000 from the chargee to winchester property investments limited made under an agreement of even date, pursuant to the terms and conditions of the pledge agreement, for an amount equal to the principal, interest, accessories, fees, costs, expenses and other amounts due to the chargee in respect of the loan and under the pledge agreement of the deed of indemnity | |
Kurze Angaben The registered certificate of deposit issued by the bank, documented by an inscription in a special register held by the bank and representing the deposit of an amount of £58,275,000 placed in cash by the company with the bank on 26/3/97 and held in account number 196881 (designated as the "account which includes all sub-accounts bearing the same number) together with interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement in respect of a deposit and pledge (the "pledge agreement") | Erstellt am 26. März 1997 Geliefert am 12. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the "pledge agreement" and a deed of indemnity of even date including, but not limited to, the obligation by the company to buy a loan of an amount of £84,975,000 from the chargee to winchester property investments limited made under an agreement of even date, pursuant to the terms and conditions of the pledge agreement, for an amount equal to the principal, interest, accessories, fees, costs, expenses and other amounts due to the chargee in respect of the loan and under the pledge agreement of the deed of indemnity | |
Kurze Angaben The registered certificate of deposit issued by the bank, documented by an inscription in a special register held by the bank and representing the deposit of an amount of £84,975,000 placed in cash by the company with the bank on 26/3/97 and held in account number 196550 (designated as the "account which includes all sub-accounts bearing the same number) together with interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Juli 1990 Geliefert am 01. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £57,000 and all monies due or to become due from the company and michael joseph perry and meryl ann perry to the chargee. | |
Kurze Angaben F/H property k/a 5 blackthorn close lutterworth leicestershire (held by the said michael joseph perry and meryl ann perry and the company as tenants in common in unequal shares). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 16. Juli 1990 Geliefert am 21. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £88,500 due from the company and roger william watts and dawn tanya watts to the chargee | |
Kurze Angaben F/Hold property k/as 5 oaklands cross oak rd, berkhamsted hertfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Sept. 1989 Geliefert am 06. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £30,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or john michael callaghan and/or ann whitley callaghan to the chargee including further advances under the terms of the mortgage. | |
Kurze Angaben F/H property k/a or being "ashling" meynell gardens snailwell road, newmarket suffolk including all fixtures thereon and additions thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0