GREEN (T.P.) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREEN (T.P.) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00049157
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREEN (T.P.) LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich GREEN (T.P.) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GREEN (T.P.) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRAFFORD PARK ESTATES LIMITED17. Aug. 189617. Aug. 1896

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREEN (T.P.) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREEN (T.P.) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Juni 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Juni 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Dez. 2009

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Insolvenzbeschluss

    Resolution insolvency:ordinary resolution "books,records.etc"
    2 SeitenLIQ MISC RES

    Insolvenzbeschluss

    Resolution insolvency:extraordinary resolution "in specie"
    2 SeitenLIQ MISC RES

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Dez. 2008

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    20 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von GREEN (T.P.) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MUNRO, Mark
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    Sekretär
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    Irish88709730004
    CULHANE, Paul
    Ballyorney Road
    Enniskerry
    Killough House
    Wicklow
    Ireland
    Geschäftsführer
    Ballyorney Road
    Enniskerry
    Killough House
    Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish49388470004
    MCKENNA, James
    3 Kilteragh Road Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Geschäftsführer
    3 Kilteragh Road Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish84380760001
    MUNRO, Mark
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrish88709730004
    VERNON, Stephen
    7 Winton Road
    Ranelagh
    Dublin 6
    Ireland
    Geschäftsführer
    7 Winton Road
    Ranelagh
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandBritish6399990006
    BRIGGS, Richard Jonathan
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    British9000960002
    MCDOWELL, David
    The Bungalow
    Silchester
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    Sekretär
    The Bungalow
    Silchester
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    Irish85557670001
    WALKER, Andrew James
    240 Padgbury Lane
    CW12 4HU Congleton
    Cheshire
    Sekretär
    240 Padgbury Lane
    CW12 4HU Congleton
    Cheshire
    British36424560001
    BRIGGS, Richard Jonathan
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    British9000960002
    CHERRY, Mark Edward
    Glebe House
    Chequers Lane Preston
    SG4 7TY Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Chequers Lane Preston
    SG4 7TY Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish141619810001
    DAVIS, James Wilson
    The Stables, Smithy Fold
    Watling Street, Affetside
    BL8 3QS Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Stables, Smithy Fold
    Watling Street, Affetside
    BL8 3QS Bury
    Lancashire
    EnglandBritish67445010001
    GERRARD, Raymond Ormesher
    12 Woodlea Walkden Road
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    12 Woodlea Walkden Road
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    Lancashire
    British63565710001
    HARRIS, Alan Joseph
    Brendon
    Catlins Lane Eastcote
    HA5 2EZ Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Brendon
    Catlins Lane Eastcote
    HA5 2EZ Pinner
    Middlesex
    Irish141619800001
    HOWE, Robert Philip Graham
    60 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    Geschäftsführer
    60 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    British59138110008
    HUNT, Michelle Marie
    62 First Avenue
    CM1 1RU Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    62 First Avenue
    CM1 1RU Chelmsford
    Essex
    British68329820002
    KITCHEN, Daniel John
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Geschäftsführer
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    United KingdomBritish153028260001
    LEADER, Thomas David
    Silvers
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Surrey
    Geschäftsführer
    Silvers
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Surrey
    United KingdomBritish115424450002
    SIMPKIN, Andrew Gordon
    Chapel Lane House
    Chapel Lane, Mere
    WA16 6PP Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Chapel Lane House
    Chapel Lane, Mere
    WA16 6PP Knutsford
    Cheshire
    British71318160001
    SMITH, Ian Fredric
    56 Sandown Crescent
    Cuddington
    CW8 2QW Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    56 Sandown Crescent
    Cuddington
    CW8 2QW Northwich
    Cheshire
    British18178840001
    TAPP, Michael Stuart
    132 Wymering Mansions
    Wymering Road
    W9 2NF London
    Geschäftsführer
    132 Wymering Mansions
    Wymering Road
    W9 2NF London
    British68137250003
    WESTBROOK, Fraser Gowanloch
    23 Lingfield Road
    SW19 4QD London
    Geschäftsführer
    23 Lingfield Road
    SW19 4QD London
    British22092430001
    WESTBROOK, Neil Gowanloch, Sir
    White Gables Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    White Gables Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    British19592890001

    Hat GREEN (T.P.) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 07. Nov. 2003
    Geliefert am 25. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties (or any of them)
    Kurze Angaben
    The mortgage property being the parkway shopping centre newham way coulby newham middlesborough t/n CE89343, 56 oxford street manchester t/n LA276480, 90 great bridgewater street & part of 56 oxford street manchester LA37145. For details of further properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 29. Okt. 2002
    Geliefert am 18. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In relation to each irish obligor (other than the company and green) prior to the whitewash completion date all present and future obligations and liabilities due or to become due from green and each other obligor (other than the company) to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the chargeand the company, gpm finance and each obligor incorporated in the U.K. or jersey; and from the whitewash completion date; each irish obligor other than green,all present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Aug. 1993
    Geliefert am 11. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property being or k/a the westbrook road industrial estate trafford park manchester.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Series of debentures
    Erstellt am 19. Sept. 1983
    Geliefert am 19. Sept. 1983
    Ausstehend
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1983Registrierung einer Belastung
    Equitable charges
    Erstellt am 03. Mai 1983
    Geliefert am 23. Mai 1983
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £6,250,000 first mortgage debenture stock of trafford park estates PLC inclusive of £3,250,000 stock secured by a trust deed dated 13 oct 11965 and deeds supplemental thereto.
    Kurze Angaben
    Floating charge on fixed charges on chief rents and f/hold properties as mentioned in the schedules attached to doc M289.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Corporation PLC.
    Transaktionen
    • 23. Mai 1983Registrierung einer Belastung
    Sixth supplemental trust deed.
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 15. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing 1,250,000 7 1/4 percent fixed mortgage debenture stock 1990/95 of the company & £2,000,000 9 percent first mortgage debenture stock 1991/96 of the company & other monies intended to the secured by the principal deed dated 13 october 1965 and the first supplemental trust deed dated 25 august 1969.
    Kurze Angaben
    1.95 acres of land with building thereon known as laing national building situate between trafford park road and trafford wharf road, trafford park, manchester. Title no:- la 345299 with fixed plant & machinery & other fixtures, all buildings erections, structures & things constructed or in the course of construction thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Corporation Limited
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    • 04. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed
    Erstellt am 27. Mai 1980
    Geliefert am 29. Mai 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Debenture stock of the company £3,250,000 and all other moneys secured by a principal deed dated 13TH october, 1965, and the first supplemental trust deed dated 25TH august, 1969
    Kurze Angaben
    F/Hold, laing national building between trafford park road and trafford wharf road, trafford park, manchester.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Corporation Limited.
    Transaktionen
    • 29. Mai 1980Registrierung einer Belastung
    • 04. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Series of debentures
    Erstellt am 25. Aug. 1969
    Geliefert am 26. Aug. 1969
    Vollständig erfüllt
    Kurze Angaben
    See doc. 250 & attached schedules.
    Berechtigte Personen
    • Baring Brothers & Co., Limited
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1969Registrierung einer Belastung
    • 04. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Series of debentures
    Erstellt am 13. Okt. 1965
    Geliefert am 13. Okt. 1965
    Vollständig erfüllt
    Kurze Angaben
    See rider attached to doc. 236.
    Berechtigte Personen
    • Baring Brothers & Co., Limited
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1965Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 04. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GREEN (T.P.) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Dez. 2011Aufgelöst am
    18. Dez. 2008Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Praktiker
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0