ESTATES & GENERAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ESTATES & GENERAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00050072 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ESTATES & GENERAL LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich ESTATES & GENERAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP 31st Floor 40 Bank Street E14 5NR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ESTATES & GENERAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ESTATES & GENERAL PLC | 18. Juni 1990 | 18. Juni 1990 |
| ESTATES & GENERAL INVESTMENTS PLC | 14. Juli 1987 | 14. Juli 1987 |
| ESTATES AND GENERAL INVESTMENTS PLC | 11. Nov. 1896 | 11. Nov. 1896 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ESTATES & GENERAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ESTATES & GENERAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 20 Seiten | LIQ14 | ||
Beendigung der Bestellung von Maurice Moses Benady als Geschäftsführer am 10. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2021 | 19 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2020 | 19 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2019 | 22 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2018 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2018 | 22 Seiten | LIQ03 | ||
Beendigung der Bestellung von F & C Reit (Corporate Services) Limited als Sekretär am 08. Aug. 2016 | 2 Seiten | TM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2017 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2017 | 19 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2016 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2016 | 19 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2015 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2014 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2015 | 18 Seiten | 4.68 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR zum 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR am 26. Sept. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Receivers oder Managers | 4 Seiten | RM01 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2014 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2014 | 19 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2014 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2013 | 22 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2013 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Feb. 2012 | 3 Seiten | 3.6 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ESTATES & GENERAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road FOREIGN Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540001 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Sekretär | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||||||
| HOLLAND, Philip John | Sekretär | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | British | 163838050001 | ||||||||||
| JACOBS, Adrian Mark | Sekretär | 13 Beaufort Gardens Hendon NW4 3QN London | British | 59392140001 | ||||||||||
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | Wigmore Street W1U 1PB London 5 United Kingdom |
| 79571870006 | ||||||||||
| ANAHORY, Moshe Jaacov | Geschäftsführer | 608 Eurotowers Europort Gibraltar | United Kingdom | British | 88548180001 | |||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | 57/63 Line Wall Road Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Bishop Rapallo's Ramp Gibraltar 1b | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| BLOOMFIELD, David William | Geschäftsführer | Hillcroft The Drive Harefield Place UB10 8AQ Ickenham Middlesex | British | 7927670001 | ||||||||||
| CLEGG, Barry Stuart | Geschäftsführer | The Gate House 18a Ducks Hill Road HA6 2NR Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11296610002 | |||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||||||
| DOSSETT, Roger John | Geschäftsführer | Charlecote Harewood Road HP8 4UA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 116927100001 | |||||||||
| HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | 163838050001 | |||||||||
| LLOYD, David Griffith | Geschäftsführer | Edenbridge House TN8 6SJ Edenbridge Kent | British | 40639900001 | ||||||||||
| MCGRATH, Kevin David | Geschäftsführer | 19 Elm Avenue W5 3XA London | England | British | 83872490002 | |||||||||
| PROWTING, Peter Brian | Geschäftsführer | Old Farm House SL3 6HU Fulmer Buckinghamshire | United Kingdom | British | 11296620003 | |||||||||
| SHEPPARD, Martin Paul | Geschäftsführer | 53 Etchingham Park Road N3 2EB London | United Kingdom | British | 127658820001 | |||||||||
| SMITH, Ivor | Geschäftsführer | 3 Shirehall Lane NW4 2PE London | United Kingdom | British | 21120940002 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | 9 4 Naval Hospital Hill Gibraltar | British | 99490560001 | ||||||||||
| WILSON, Thomas Frederick | Geschäftsführer | Myton House Manor Fields Putney Heath Putney SW15 3NJ London | British | 35556920001 | ||||||||||
| REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 79571870001 | |||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat ESTATES & GENERAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Eleventh supplemental trust deed | Erstellt am 15. Aug. 2006 Geliefert am 30. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land and buildings k/a tontines hanley stoke on trent t/n SF414169 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumberances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Ninth supplemental trust | Erstellt am 01. Dez. 2005 Geliefert am 02. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First specific security the capital sum of £13,750,000 and the investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the real properties specified in part iii of schedule 2. by way of floating charge (I) the whole of its assets, present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sixth supplemental trust deed | Erstellt am 18. Feb. 2003 Geliefert am 25. Feb. 2003 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £3,500,000 and the investments from time to time representing the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 01. Sept. 2000 Geliefert am 05. Sept. 2000 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock of estates & general PLC and all other monies intended to be secured by the deed and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/H land at lower end chorleywood t/n HD190157 together with all buildings and erections fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 24. Aug. 1998 Geliefert am 25. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture | |
Kurze Angaben (A) all moneys whether principal or interest owing now and/or from time to time on the security of the legal mortgage dated 24TH september 1991 between (1) ka-ar construction limited and (2) estates & general PLC ("the mortgage") and the benefit of the mortgage (unless the mortgage was effected by demise or sub-demise) and any other securities at any time held by the mortgagor for the mortgage debt to hold to the security trustee absolutely subject to the proviso for redemption contained in the supplemental debenture;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 23. Dez. 1997 Geliefert am 08. Jan. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,000,000 12.4 per cent. First mortgage debenture stock 2008 and on the £18,000,000 11.25 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 21.12.83, 23.8.85, 10.9.85, 14.5.86, 27.4.87, 28.4.87, 22.2.89, 26.6.91, 12.7.91, 11.11.91, 15.1.93, 10.8.93, 13.8.93, 15.9.93, 3.3.95, 23.6.95 and 26.11.97 to which it is supplemental | |
Kurze Angaben Freehold 25 to 35 (odd numbers) castle way, southampton title number hp 101820; leasehold the tontines shopping centre hanley title number sf 286975; freehold manfield park guildford road cranleigh title number sy 488061; freehold land at lower end chorleywood title number hd 190157; freehold 69/70 high street, thame title number on 59401; freehold property at prebendal court oxford road aylesbury buckinghamshire and all buildings, erections, fixtures, fittings, fixed plant and machinery, all improvements, additions, benefit of all leases, underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants, and conditions. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of pledge | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 06. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fourth supplemental trust deed | Erstellt am 15. Sept. 1993 Geliefert am 24. Sept. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined) | |
Kurze Angaben See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1992 Geliefert am 19. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture and the security constituted thereby | |
Kurze Angaben (For full details of charge see form 395 and contd sheets for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1992 Geliefert am 14. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the charge | |
Kurze Angaben Prebendal court, oxford road, aylesbury, bucks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-mortgage | Erstellt am 07. Feb. 1992 Geliefert am 11. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 17 high street, thame t/n-DN126205. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-mortgage | Erstellt am 07. Feb. 1992 Geliefert am 11. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 40 lower icknield way, chinnor t/n-ON112789. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-mortgae | Erstellt am 07. Feb. 1992 Geliefert am 11. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben "Troutbeck", 31 wyatts road, choleywood, t/n-HD184877. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-mortgage | Erstellt am 07. Feb. 1992 Geliefert am 11. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10/12 temple end, high wycombe t/n-BM123266. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-mortgage | Erstellt am 07. Feb. 1992 Geliefert am 11. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 1, triangle business park, wendover road, stock mandeville, buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subcharge | Erstellt am 24. Dez. 1991 Geliefert am 31. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 40 lower icknield way chinnor oxfordshire t/n-ON112789. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subcharge | Erstellt am 24. Dez. 1991 Geliefert am 31. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 17 high street, thame oxfordshire t/n ON126205. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subcharge | Erstellt am 24. Dez. 1991 Geliefert am 31. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a "troutbeck", 31 wyatts road chorleywood hertfordshire t/n-HD184877. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subcharge | Erstellt am 24. Dez. 1991 Geliefert am 31. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10-12 temple end, high wycombe, buckinghamshire t/n-BM123266. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release & substitution | Erstellt am 12. Juli 1991 Geliefert am 16. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £1,200,000 & the investments from time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release & substitution | Erstellt am 26. Juni 1991 Geliefert am 04. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £1,104,000 & the investments for the timebeing. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter confirming deposit of deeds by way of equitable mortgage | Erstellt am 02. Nov. 1990 Geliefert am 08. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge | |
Kurze Angaben Prebendal court, oxford road, alesbury, buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge without written instrument | Erstellt am 14. Feb. 1990 Geliefert am 02. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a letter dated 14/2/90 | |
Kurze Angaben 1) fund lying to teh south-west of sunderland avenue bowerhill melksham wilkshire title no wt 72820 2) all that estate right title and interest as is owned by by county & surburbon properties limited in the land at outmarsh railway farm semington trowbridge wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| General charge | Erstellt am 08. Nov. 1989 Geliefert am 20. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Specific equitable charge ovoer all the company's estates or interests in any f/h or l/h property now or at any time belonging to or charged to the company and/or the proceedsd of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ESTATES & GENERAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Administrativer Receiver bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0