TI MEDIA LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TI MEDIA LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00053626 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TI MEDIA LIMITED?
- Veröffentlichung von Verbraucher- und Wirtschaftszeitschriften und -periodika (58142) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich TI MEDIA LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quay House The Ambury BA1 1UA Bath England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TI MEDIA LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TIME INC. (UK) LTD | 03. Sept. 2014 | 03. Sept. 2014 |
| IPC MEDIA LIMITED | 08. Juni 2000 | 08. Juni 2000 |
| I.P.C. MAGAZINES LIMITED | 05. Aug. 1897 | 05. Aug. 1897 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TI MEDIA LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TI MEDIA LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Ernennung von Mr Andrew John Thomas als Direktor am 01. März 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Penelope Anne Ladkin-Brand als Geschäftsführer am 01. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Oliver James Foster als Geschäftsführer am 01. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Oliver James Foster als Direktor am 30. Mai 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr David John Bateson als Sekretär am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr David John Bateson als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Zillah Ellen Byng-Thorne als Geschäftsführer am 31. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Robert William Tompkins als Direktor am 18. Dez. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 18 Seiten | AA | ||
legacy | 182 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Penelope Anne Ladkin-Brand am 20. Apr. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Zillah Ellen Byng-Thorne am 17. Feb. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Penelope Anne Ladkin-Brand als Direktor am 01. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Rachel Bernadette Addison als Geschäftsführer am 31. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Change of details for Sapphire Bidco Limited as a person with significant control on 18. Aug. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 27 Seiten | AA | ||
legacy | 172 Seiten | PARENT_ACC | ||
Wer sind die Geschäftsführer von TI MEDIA LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATESON, David John | Sekretär | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 307920790001 | |||||||
| BATESON, David John | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | United Kingdom | British | 259939150001 | |||||
| THOMAS, Andrew John | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 137715700001 | |||||
| TOMPKINS, Robert William | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 303888570001 | |||||
| GORE, John Francis | Sekretär | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Sekretär | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Sekretär | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Sekretär | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Sekretär | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| ADDISON, Rachel Bernadette | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | United Kingdom | British | 250816460001 | |||||
| ALEY, William Robert | Geschäftsführer | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ANDERSON, Alun, Dr | Geschäftsführer | 2 Park Avenue South N8 8LT London | England | British | 54339140001 | |||||
| ARCULUS, Thomas David Guy | Geschäftsführer | Flat 193 County Hall North Block 1a Belvedere Road SE1 7GH London | British | 80344070001 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Geschäftsführer | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Geschäftsführer | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Geschäftsführer | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Geschäftsführer | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Geschäftsführer | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| BOREHAM, Edward Charles | Geschäftsführer | 19 The Meads Cranham RM14 3YP Upminster Essex | British | 18237280001 | ||||||
| BOYD, Christopher James | Geschäftsführer | The Old Farmhouse Biddenden Road TN17 2BE Frittenden Kent | British | 104281560001 | ||||||
| BROOKS, Timothy Stephen | Geschäftsführer | 3 Bowers Way AL5 4EP Harpenden Hertfordshire | England | British | 72643520002 | |||||
| BROWN, Philippa Anne | Geschäftsführer | 93 Studdridge Street SW6 3TD London | United Kingdom | British | 64176480004 | |||||
| BYNG-THORNE, Zillah Ellen | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 182681640004 | |||||
| CARAYOL, Rene Roland | Geschäftsführer | 3 Victoria Rise Hilgrove Road NW6 4TH Swiss Cottage London | United Kingdom | British | 155413470001 | |||||
| CHEAL, Paul Andrew | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 112376740002 | |||||
| CLAYTON, Michael Aylwin | Geschäftsführer | Sunnyside Cottage Braunston LE15 8QW Oakham Leicestershire | British | 64639900001 | ||||||
| CRACE, Georgina | Geschäftsführer | Garden Flat 14 Lawn Road NW3 2XS London | British | 55927170001 | ||||||
| D'EMIC, Susana Alves | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DAVIDSON, Nigel James | Geschäftsführer | Luton Cottage The Street Selling ME13 9RQ Faversham Kent | British | 18237320001 | ||||||
| DAVIES, Andrea Clare | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 266948310001 | |||||
| DENT, Fiona Ann | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | 192515270001 | |||||
| DRINKALL, Christopher John Julian | Geschäftsführer | 39 Saltoun Road SW2 1EN London | England | British | 76437030001 | |||||
| EDEN, Keith Leslie | Geschäftsführer | 6 Friends Walk CB11 4EA Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 53429470001 | |||||
| EVANS, Richard John | Geschäftsführer | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Geschäftsführer | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TI MEDIA LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Plc | 20. Apr. 2020 | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Sapphire Topco Limited | 15. März 2018 | Marsh Wall E14 9AP London 161 United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Sapphire Bidco Limited | 15. März 2018 | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ipc Magazines Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Time Inc. | 06. Apr. 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TI MEDIA LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 05. Apr. 2018 Geliefert am 11. Apr. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Intellectual property with trademark number 270056.. please see instrument for further details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 1999 Geliefert am 02. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part basement and ground and fourth fifth and sixth floors 237-247 tottenham court road london W1P oau; ground floor workshop and first and second floor offices in westover house west quay road poole dorset; 39 car parking spaces at westover house west quay road poole dorset t/nos: NGL78946 and DT42610 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment dated 22 december 1998 deed of accession dated 12 october 1998 supplemental to the debenture dated 19 january 1998 | Erstellt am 22. Dez. 1998 Erworben am 15. Feb. 1999 Geliefert am 03. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession dated 12 october 1998 supplemental to the debenture dated 19 january 1998 | Erstellt am 12. Okt. 1998 Erworben am 15. Feb. 1999 Geliefert am 03. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Erstellt am 12. Okt. 1998 Geliefert am 15. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1998 Geliefert am 06. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 06. Nov. 1968 Geliefert am 22. Nov. 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing debenture stock of international publishing corporation limited amounting to £16,960,172 inclusive of £6,960,172 secured by a trust deed dated 27/6/63 and deeds supplemental. | |
Kurze Angaben The property comprised in a trust deed dated 27/06/1963. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 27. Juni 1963 Geliefert am 01. Juli 1963 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing £6,960,172 debenture stock of international publishing corporation limited | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets including uncalled capital within the UK. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0