TERMINUS 13 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTERMINUS 13 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00061193
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TERMINUS 13 LIMITED?

    • (2222) /

    Wo befindet sich TERMINUS 13 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TERMINUS 13 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POLESTAR MILTON KEYNES LIMITED06. Nov. 199806. Nov. 1998
    BPC MILTON KEYNES LTD26. Nov. 199626. Nov. 1996
    BPC MAGAZINES (MILTON KEYNES) LTD18. Jan. 199418. Jan. 1994
    BPCC MAGAZINES (MILTON KEYNES) LTD07. Mai 199107. Mai 1991
    BPCC BUSINESS MAGAZINES (PULMAN) LTD04. Mai 198904. Mai 1989
    PULMAN WEB OFFSET LIMITED12. Feb. 198612. Feb. 1986
    GEORGE PULMAN AND SONS LIMITED21. März 189921. März 1899

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TERMINUS 13 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für TERMINUS 13 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed polestar milton keynes LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    3 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 10. Mai 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 23,308
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    10 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    10 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004

    11 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TERMINUS 13 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Sekretär
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    British98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Geschäftsführer
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritish98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritish68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Geschäftsführer
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritish138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British16105360002
    FERGUSON, Alastair
    Sunrise Main Street
    Walton
    LS23 7DJ Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Sunrise Main Street
    Walton
    LS23 7DJ Wetherby
    West Yorkshire
    British50470110002
    HEALY, Scott
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    British79690160001
    HIBBERT, Barry Alan
    2 Yeates Close
    MK18 3RH Winslow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Yeates Close
    MK18 3RH Winslow
    Buckinghamshire
    British68122470001
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    British83714120001
    MEARNS, Ian Kenneth
    44 The Gallops
    Langdon Hills
    SS16 6RR Basildon
    Essex
    Geschäftsführer
    44 The Gallops
    Langdon Hills
    SS16 6RR Basildon
    Essex
    British51116490001
    RICHARDSON, Douglas
    12 Keeble Close
    Tiptree
    CO5 0NU Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    12 Keeble Close
    Tiptree
    CO5 0NU Colchester
    Essex
    British90947730001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritish44908110001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Geschäftsführer
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritish127238050003
    WATSON, Peter
    42 Breck Road
    Marton
    FY3 9DT Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    42 Breck Road
    Marton
    FY3 9DT Blackpool
    Lancashire
    British66119150001
    WHEELER, Bruce Raymond
    27 Wisdoms Green
    Coggeshall
    CO6 1SG Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    27 Wisdoms Green
    Coggeshall
    CO6 1SG Colchester
    Essex
    British30507580001

    Hat TERMINUS 13 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 10. Juli 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    Kurze Angaben
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 08. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 05. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed
    Kurze Angaben
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Therein)as Agent and Trustee for the Lenders (As Defined
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 31. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the governor and company of the bank of scotland as agent and trustee for the banks and the overdraft bank under the terms of "the facilities agreement" dated 21-12-88 and the overdraft facilities as defined in this deed on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    (Please refer to form 395 ref M221). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 22. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 31. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from buchsmere limited to the chargee under a mezzanine loan agreement dated 21/12/88 on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    (Please refer to form M395). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders.
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 24. Sept. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0