TERMINUS 13 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TERMINUS 13 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00061193 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TERMINUS 13 LIMITED?
- (2222) /
Wo befindet sich TERMINUS 13 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Apex Business Centre Boscombe Road LU5 4SB Dunstable Bedfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TERMINUS 13 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| POLESTAR MILTON KEYNES LIMITED | 06. Nov. 1998 | 06. Nov. 1998 |
| BPC MILTON KEYNES LTD | 26. Nov. 1996 | 26. Nov. 1996 |
| BPC MAGAZINES (MILTON KEYNES) LTD | 18. Jan. 1994 | 18. Jan. 1994 |
| BPCC MAGAZINES (MILTON KEYNES) LTD | 07. Mai 1991 | 07. Mai 1991 |
| BPCC BUSINESS MAGAZINES (PULMAN) LTD | 04. Mai 1989 | 04. Mai 1989 |
| PULMAN WEB OFFSET LIMITED | 12. Feb. 1986 | 12. Feb. 1986 |
| GEORGE PULMAN AND SONS LIMITED | 21. März 1899 | 21. März 1899 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TERMINUS 13 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TERMINUS 13 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed polestar milton keynes LIMITED\certificate issued on 12/05/11 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alan Goodwin am 31. Juli 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alan Goodwin am 31. Juli 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 10 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TERMINUS 13 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODWIN, Alan | Sekretär | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | British | 98921850001 | ||||||
| GOODWIN, Alan James | Geschäftsführer | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | United Kingdom | British | 98921850003 | |||||
| HEARN, Catherine Ann | Geschäftsführer | White Gate House Ellesborough Road HP22 6ES Wendover Buckinghamshire | United Kingdom | British | 83713930001 | |||||
| HIBBERT, Barry Alan | Geschäftsführer | River Steps Gibraltar Lane SL6 9TR Cookham Dean Berkshire | United Kingdom | British | 68122470005 | |||||
| JOHNSTON, Peter Douglas | Geschäftsführer | Peters Lane HP27 OLQ Whiteleaf Tanglewood Bucks | England | British | 138015860001 | |||||
| BRIDGES, Clive | Sekretär | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | 987230001 | ||||||
| BRIDGES, Clive | Geschäftsführer | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | 987230001 | ||||||
| BROWN, Frederick James | Geschäftsführer | 61 Handside Lane AL8 6SH Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 16105360002 | ||||||
| FERGUSON, Alastair | Geschäftsführer | Sunrise Main Street Walton LS23 7DJ Wetherby West Yorkshire | British | 50470110002 | ||||||
| HEALY, Scott | Geschäftsführer | 7 Mount Pleasant MK17 9EX Stoke Hammond Buckinghamshire | British | 79690160001 | ||||||
| HIBBERT, Barry Alan | Geschäftsführer | 2 Yeates Close MK18 3RH Winslow Buckinghamshire | British | 68122470001 | ||||||
| HOLLORAN, Peter John | Geschäftsführer | Southmoor Farmhouse Stonehill Lane Southmoor OX13 5HU Abingdon Oxfordshire | England | British | 61418710001 | |||||
| JOHNSTON, Peter Douglas | Geschäftsführer | Flat 3 76 Carter Lane EC4V 5EA London | British | 83714120001 | ||||||
| MEARNS, Ian Kenneth | Geschäftsführer | 44 The Gallops Langdon Hills SS16 6RR Basildon Essex | British | 51116490001 | ||||||
| RICHARDSON, Douglas | Geschäftsführer | 12 Keeble Close Tiptree CO5 0NU Colchester Essex | British | 90947730001 | ||||||
| ROBERTSON, Malcolm Murray | Geschäftsführer | Mardale 85 Harmer Green Lane Digswell AL6 0ER Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | 39155140002 | |||||
| RUDSTON, Anthony | Geschäftsführer | Minstrels Barn Henton OX9 4AE Chinnor Oxfordshire | England | British | 44908110001 | |||||
| TIMMINS, Richard Keith | Geschäftsführer | 3 Maxey View Deeping Gate PE6 9BE Peterborough | United Kingdom | British | 127238050003 | |||||
| WATSON, Peter | Geschäftsführer | 42 Breck Road Marton FY3 9DT Blackpool Lancashire | British | 66119150001 | ||||||
| WHEELER, Bruce Raymond | Geschäftsführer | 27 Wisdoms Green Coggeshall CO6 1SG Colchester Essex | British | 30507580001 |
Hat TERMINUS 13 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998 | Erstellt am 28. Okt. 2004 Geliefert am 10. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98 | Erstellt am 28. Okt. 2004 Geliefert am 10. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Juni 1998 Geliefert am 10. Juli 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents | |
Kurze Angaben F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 28. Dez. 1995 Geliefert am 08. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 28. Dez. 1995 Geliefert am 05. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed | |
Kurze Angaben Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 31. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the governor and company of the bank of scotland as agent and trustee for the banks and the overdraft bank under the terms of "the facilities agreement" dated 21-12-88 and the overdraft facilities as defined in this deed on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (Please refer to form 395 ref M221). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 31. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from buchsmere limited to the chargee under a mezzanine loan agreement dated 21/12/88 on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (Please refer to form M395). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0