OT OFFICE SUPPLIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OT OFFICE SUPPLIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00065882 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OYEZSTRAKER OFFICE SUPPLIES LIMITED | 12. Okt. 1998 | 12. Okt. 1998 |
| STRAKER OFFICE SUPPLIES PLC | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| STRAKER GRAPHIC AND DRAWING OFFICE SUPPLIES LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
| WIGHTMAN MOUNTAIN LIMITED | 09. Mai 1900 | 09. Mai 1900 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 12 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Juli 2022 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 13 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Juli 2021 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 4 500 Purley Way Croydon Surrey CR0 4NZ zum 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR am 03. Aug. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Graham Mobbs als Geschäftsführer am 17. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard John Oates als Direktor am 17. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Jonathan Paul Moulton as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Officezone Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen James Horne als Direktor am 04. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeffrey Michael Whiteway als Geschäftsführer am 18. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 000658820022, erstellt am 23. Nov. 2018 | 60 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 000658820016 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYNARD, Philippa Anne | Sekretär | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | British | 44140850002 | ||||||
| HORNE, Stephen James | Geschäftsführer | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | 256352360001 | |||||
| OATES, Richard John | Geschäftsführer | Purley Way CR0 4NZ Croydon Unit 4 C/O Officeteam England | United Kingdom | British | 198603960001 | |||||
| BLANCHARD, Lisa Anne | Sekretär | 156 Casewick Road West Norwood SE27 0SZ London | British | 40576530001 | ||||||
| GRAY, David Peter | Sekretär | 28a Chaldon Common Road CR3 5DA Caterham Surrey | British | 67707480001 | ||||||
| PARNELL, Julie Caroline | Sekretär | 45 Hilldale Road SM1 2JA Cheam Surrey | British | 25488170003 | ||||||
| SEAR, Hugh Edward | Sekretär | 1 Lynwood Avenue KT17 4LQ Epsom Surrey | English | 47246600001 | ||||||
| ADAMS, Paul | Geschäftsführer | Cob House 69 Sevenoaks Road Borough Green TN15 8AR Sevenoaks Kent | British | 29789530001 | ||||||
| APPLETON, William John | Geschäftsführer | 28 Bedford Avenue Silsoe MK45 4ER Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | 55953830001 | |||||
| BROWN, Stephen Thomas | Geschäftsführer | 15 Cambridge Road CO13 9HN Frinton On Sea Essex | British | 107928550001 | ||||||
| CAHILL, Peter Charles | Geschäftsführer | Poplar Cottage Leighs Road CM3 3NH Little Waltham Essex | British | 36596500005 | ||||||
| COX, David | Geschäftsführer | Marloes Comp Lane St Marys Platt TN15 8NR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 70818680001 | |||||
| DALE, Nicholas Robin | Geschäftsführer | 19 Roseacre Lane Bearsted ME14 4HZ Maidstone Kent | United Kingdom | British | 65374210001 | |||||
| DAVIS, William | Geschäftsführer | 38 Harwater Drive IG10 1LW Loughton Essex | British | 14385550001 | ||||||
| EADES, Lisa Anne | Geschäftsführer | 4 Moorland Road Maidenbower RH10 7JB Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 40576530004 | |||||
| EALES, Paul John | Geschäftsführer | 36 Great Ellshams SM7 2BA Banstead Surrey | British | 1457430001 | ||||||
| GRAINGER, Terence Arthur | Geschäftsführer | 60 Penland Road RH16 1PH Haywards Heath West Sussex | British | 55826910001 | ||||||
| GRAY, David Peter | Geschäftsführer | 28a Chaldon Common Road CR3 5DA Caterham Surrey | British | 67707480001 | ||||||
| HEYS, David Michael | Geschäftsführer | Woodside House 597 Wheatley Lane Road BB12 9EP Burnley Lancashire | United Kingdom | British | 71032080003 | |||||
| HICKFORD, John | Geschäftsführer | Oak Cottage Kitten Lane MK43 ORJ Stanstead Abbotts Hertfordshire | British | 61175600002 | ||||||
| HODGES, Nicholas Robin | Geschäftsführer | 34 Holland Road MK45 2RS Ampthill Bedfordshire | England | British | 48585350003 | |||||
| LAWSON, Philip Andrew | Geschäftsführer | Clayton Cottages 65 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | United Kingdom | British | 50604220003 | |||||
| LENNARD, Andrew Dacre | Geschäftsführer | Pheasant Hill House Kemble GL7 6AW Cirencester Gloucestershire | England | British | 68152930001 | |||||
| MARROW, Colin John | Geschäftsführer | 14 Asquith House Dunnymans Road SM7 2AN Banstead Surrey | British | 14385520001 | ||||||
| MCATEE, Reginald Francis | Geschäftsführer | 8 Kerrix Road Symington KA1 5QD Ayrshire Scotland | British | 772340004 | ||||||
| MCCALLUM, Alexander James | Geschäftsführer | 28 Ouseley Road SW12 8EF London | United Kingdom | British | 93679470001 | |||||
| MOBBS, Andrew Graham | Geschäftsführer | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | United Kingdom | British | 100613070001 | |||||
| MORGAN, Richard James | Geschäftsführer | Parkfield 4 Somerville Road B73 6JA Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 15621070003 | |||||
| PITT, Derek Neil | Geschäftsführer | 52 Albany Drive CT6 8PX Herne Bay Kent | British | 14385530005 | ||||||
| PURVES, Duncan | Geschäftsführer | The Stables Crook Road, Brenchley TN12 7BE Tonbridge Kent | British | 70629590001 | ||||||
| SEAR, Hugh Edward | Geschäftsführer | 1 Lynwood Avenue KT17 4LQ Epsom Surrey | England | English | 47246600001 | |||||
| SEWARD, Timothy Clifton | Geschäftsführer | Whiteposts 2 The Netherlands CR5 1ND Coulsdon Surrey | British | 51783710001 | ||||||
| SEWARD, Timothy Clifton | Geschäftsführer | Whiteposts 2 The Netherlands CR5 1ND Coulsdon Surrey | British | 51783710001 | ||||||
| SEWARD, Timothy Clifton | Geschäftsführer | Whiteposts 2 The Netherlands CR5 1ND Coulsdon Surrey | British | 51783710001 | ||||||
| SMITH, Graham | Geschäftsführer | The Old Vicarage Cottage Atcham SY5 6QE Shrewsbury | British | 69193860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Jonathan Paul Moulton | 06. Apr. 2016 | Buckingham Street WC2N 6DF London 10 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Guernsey | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Officezone Limited | 06. Apr. 2016 | Purley Way CR0 4NZ Croydon Unit 4 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OT OFFICE SUPPLIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 23. Nov. 2018 Geliefert am 29. Nov. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Guild HOUSE6, the courtyard reddicap tgrading estate broomie close sutton coldfield west midlands t/nos WM542345 and WM542346. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 17. Juli 2015 Geliefert am 20. Juli 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The chargor with full title guarantee as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations hereby charges to lloyds by way of legal mortgage the property known as the leasehold land adjoining guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield, B75 7BU registered at the land registry with title number WM542345 and the freehold property being guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield, B75 7BU registered at the land registry with title number WM542346 (the "property") (and the proceeds of sale of the property) and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time in and on the property and the benefit of all rights, easements and privileges appurtenant to or benefiting the property.. All defined terms are as defined in the legal charge. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 17. Juli 2015 Geliefert am 20. Juli 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Aug. 2014 Geliefert am 18. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 24. Juli 2014 Geliefert am 08. Aug. 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 24. Juli 2014 Geliefert am 08. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. Juni 2013 Geliefert am 22. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. Juni 2013 Geliefert am 20. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield t/no WM542346 (freehold); and land adjoining guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield t/no WM542345 (leasehold). Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 20. Juni 2007 Geliefert am 22. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The acceding company assigns, with full title guarantee by way of absolute legal assignment the contracts, intellectual property rights, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Apr. 2003 Geliefert am 10. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policy | Erstellt am 03. Apr. 2003 Geliefert am 16. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The life policy with the policy number RNF00024729A taken out by the company with royal & sun alliance over the life of jeffrey whiteway. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Apr. 2003 Geliefert am 10. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined) | Erstellt am 30. Apr. 2001 Geliefert am 15. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 16. März 1999 Geliefert am 06. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee and debenture dated 1ST september 1997 (as defined) | |
Kurze Angaben L/Hold property - 771 buckingham ave,slough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 16. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee and debenture dated 1ST september 1997 | |
Kurze Angaben L/Hold property known as 137 high st,eton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 01. Sept. 1997 Geliefert am 11. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Apr. 1989 Geliefert am 19. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a ground floor suite 1 ward street guildford surrey. And/or the proceeds of the sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 1984 Geliefert am 08. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge on all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts please see doc m/53. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 08. Mai 1984 Geliefert am 21. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 17A and part of 19 artillery row westminster london SW1 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 08. Mai 1984 Geliefert am 21. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 15 artillery row westminster london SW1 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 1980 Geliefert am 06. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £35,000 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben L/H premises being, 17A and part 19, artillery row, victoria, london SW1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental agreement for deposit of six outstanding second debentures as further security | Erstellt am 22. Juli 1914 Geliefert am 30. Juli 1914 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Second charge on undertaking and all property,stock in trade machinery goods and other assets,present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OT OFFICE SUPPLIES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0