OT OFFICE SUPPLIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOT OFFICE SUPPLIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00065882
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OYEZSTRAKER OFFICE SUPPLIES LIMITED12. Okt. 199812. Okt. 1998
    STRAKER OFFICE SUPPLIES PLC31. Dez. 198031. Dez. 1980
    STRAKER GRAPHIC AND DRAWING OFFICE SUPPLIES LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    WIGHTMAN MOUNTAIN LIMITED09. Mai 190009. Mai 1900

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Juli 2022

    10 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    13 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Juli 2021

    11 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 4 500 Purley Way Croydon Surrey CR0 4NZ zum 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR am 03. Aug. 2020

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 08. Juli 2020

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beendigung der Bestellung von Andrew Graham Mobbs als Geschäftsführer am 17. Jan. 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard John Oates als Direktor am 17. Jan. 2020

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Cessation of Jonathan Paul Moulton as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC07

    Notification of Officezone Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name15. Apr. 2019

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 15. Apr. 2019

    RES15

    Ernennung von Mr Stephen James Horne als Direktor am 04. März 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jeffrey Michael Whiteway als Geschäftsführer am 18. Jan. 2019

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 000658820022, erstellt am 23. Nov. 2018

    60 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    8 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 000658820016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MAYNARD, Philippa Anne
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Sekretär
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    British44140850002
    HORNE, Stephen James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritish256352360001
    OATES, Richard John
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    Geschäftsführer
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    United KingdomBritish198603960001
    BLANCHARD, Lisa Anne
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    Sekretär
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    British40576530001
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Sekretär
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    British67707480001
    PARNELL, Julie Caroline
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    Sekretär
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    British25488170003
    SEAR, Hugh Edward
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    Sekretär
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    English47246600001
    ADAMS, Paul
    Cob House 69 Sevenoaks Road
    Borough Green
    TN15 8AR Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Cob House 69 Sevenoaks Road
    Borough Green
    TN15 8AR Sevenoaks
    Kent
    British29789530001
    APPLETON, William John
    28 Bedford Avenue
    Silsoe
    MK45 4ER Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    28 Bedford Avenue
    Silsoe
    MK45 4ER Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritish55953830001
    BROWN, Stephen Thomas
    15 Cambridge Road
    CO13 9HN Frinton On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    15 Cambridge Road
    CO13 9HN Frinton On Sea
    Essex
    British107928550001
    CAHILL, Peter Charles
    Poplar Cottage
    Leighs Road
    CM3 3NH Little Waltham
    Essex
    Geschäftsführer
    Poplar Cottage
    Leighs Road
    CM3 3NH Little Waltham
    Essex
    British36596500005
    COX, David
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish70818680001
    DALE, Nicholas Robin
    19 Roseacre Lane
    Bearsted
    ME14 4HZ Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    19 Roseacre Lane
    Bearsted
    ME14 4HZ Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish65374210001
    DAVIS, William
    38 Harwater Drive
    IG10 1LW Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    38 Harwater Drive
    IG10 1LW Loughton
    Essex
    British14385550001
    EADES, Lisa Anne
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish40576530004
    EALES, Paul John
    36 Great Ellshams
    SM7 2BA Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    36 Great Ellshams
    SM7 2BA Banstead
    Surrey
    British1457430001
    GRAINGER, Terence Arthur
    60 Penland Road
    RH16 1PH Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    60 Penland Road
    RH16 1PH Haywards Heath
    West Sussex
    British55826910001
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    British67707480001
    HEYS, David Michael
    Woodside House
    597 Wheatley Lane Road
    BB12 9EP Burnley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Woodside House
    597 Wheatley Lane Road
    BB12 9EP Burnley
    Lancashire
    United KingdomBritish71032080003
    HICKFORD, John
    Oak Cottage
    Kitten Lane
    MK43 ORJ Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Oak Cottage
    Kitten Lane
    MK43 ORJ Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    British61175600002
    HODGES, Nicholas Robin
    34 Holland Road
    MK45 2RS Ampthill
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    34 Holland Road
    MK45 2RS Ampthill
    Bedfordshire
    EnglandBritish48585350003
    LAWSON, Philip Andrew
    Clayton Cottages 65 High Street
    RH9 8DT Godstone
    Surrey
    Geschäftsführer
    Clayton Cottages 65 High Street
    RH9 8DT Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish50604220003
    LENNARD, Andrew Dacre
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish68152930001
    MARROW, Colin John
    14 Asquith House
    Dunnymans Road
    SM7 2AN Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    14 Asquith House
    Dunnymans Road
    SM7 2AN Banstead
    Surrey
    British14385520001
    MCATEE, Reginald Francis
    8 Kerrix Road Symington
    KA1 5QD Ayrshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    8 Kerrix Road Symington
    KA1 5QD Ayrshire
    Scotland
    British772340004
    MCCALLUM, Alexander James
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    Geschäftsführer
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    United KingdomBritish93679470001
    MOBBS, Andrew Graham
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish100613070001
    MORGAN, Richard James
    Parkfield 4 Somerville Road
    B73 6JA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Parkfield 4 Somerville Road
    B73 6JA Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish15621070003
    PITT, Derek Neil
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    Geschäftsführer
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    British14385530005
    PURVES, Duncan
    The Stables
    Crook Road, Brenchley
    TN12 7BE Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    The Stables
    Crook Road, Brenchley
    TN12 7BE Tonbridge
    Kent
    British70629590001
    SEAR, Hugh Edward
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    EnglandEnglish47246600001
    SEWARD, Timothy Clifton
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    British51783710001
    SEWARD, Timothy Clifton
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    British51783710001
    SEWARD, Timothy Clifton
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    British51783710001
    SMITH, Graham
    The Old Vicarage Cottage
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage Cottage
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    British69193860001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OT OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Jonathan Paul Moulton
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    06. Apr. 2016
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Guernsey
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4
    England
    06. Apr. 2016
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02848787
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat OT OFFICE SUPPLIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 23. Nov. 2018
    Geliefert am 29. Nov. 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Guild HOUSE6, the courtyard reddicap tgrading estate broomie close sutton coldfield west midlands t/nos WM542345 and WM542346.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • BECAP12 Gp Limited as General Partner of BECAP12 Gp LP as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 17. Juli 2015
    Geliefert am 20. Juli 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The chargor with full title guarantee as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations hereby charges to lloyds by way of legal mortgage the property known as the leasehold land adjoining guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield, B75 7BU registered at the land registry with title number WM542345 and the freehold property being guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield, B75 7BU registered at the land registry with title number WM542346 (the "property") (and the proceeds of sale of the property) and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time in and on the property and the benefit of all rights, easements and privileges appurtenant to or benefiting the property.. All defined terms are as defined in the legal charge.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC as Receivables Purchaser, Inventory Lender and Property Lender and Lloyds Bank Commercial Finance Limited as Agent (Together "Lloyds")
    Transaktionen
    • 20. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 17. Juli 2015
    Geliefert am 20. Juli 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC as Receivables Purchaser, Inventory Lender and Property Lender and Lloyds Bank Commercial Finance Limited as Agent (Together "Lloyds")
    Transaktionen
    • 20. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 14. Aug. 2014
    Geliefert am 18. Aug. 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Becap 12 Gp Limited Acting in Its Capaciy as General Partner of BECAP12 Gp LP, Acting in Its Capacity as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 24. Juli 2014
    Geliefert am 08. Aug. 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • BECAP12 Gp Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 24. Juli 2014
    Geliefert am 08. Aug. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • BECAP12 Gp Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Juni 2013
    Geliefert am 22. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 24. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Juni 2013
    Geliefert am 20. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield t/no WM542346 (freehold); and land adjoining guild house, 6 the courtyard, reddicap trading estate, broomie close, sutton coldfield t/no WM542345 (leasehold). Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession
    Erstellt am 20. Juni 2007
    Geliefert am 22. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The acceding company assigns, with full title guarantee by way of absolute legal assignment the contracts, intellectual property rights, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 2003
    Geliefert am 10. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 03. Apr. 2003
    Geliefert am 16. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The life policy with the policy number RNF00024729A taken out by the company with royal & sun alliance over the life of jeffrey whiteway.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Apr. 2003
    Geliefert am 10. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined)
    Erstellt am 30. Apr. 2001
    Geliefert am 15. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 16. März 1999
    Geliefert am 06. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee and debenture dated 1ST september 1997 (as defined)
    Kurze Angaben
    L/Hold property - 771 buckingham ave,slough.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 16. März 1999
    Geliefert am 25. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee and debenture dated 1ST september 1997
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as 137 high st,eton.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Sept. 1997
    Geliefert am 11. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Bank of Scotland Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Apr. 1989
    Geliefert am 19. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a ground floor suite 1 ward street guildford surrey. And/or the proceeds of the sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 1984
    Geliefert am 08. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge on all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts please see doc m/53.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    • 27. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Mai 1984
    Geliefert am 21. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 17A and part of 19 artillery row westminster london SW1 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    • 08. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Mai 1984
    Geliefert am 21. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 15 artillery row westminster london SW1 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    • 08. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1980
    Geliefert am 06. Jan. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £35,000 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    L/H premises being, 17A and part 19, artillery row, victoria, london SW1.
    Berechtigte Personen
    • Tollit & Harvey Limited
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1981Registrierung einer Belastung
    Supplemental agreement for deposit of six outstanding second debentures as further security
    Erstellt am 22. Juli 1914
    Geliefert am 30. Juli 1914
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Second charge on undertaking and all property,stock in trade machinery goods and other assets,present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Juli 1914Registrierung einer Belastung
    • 06. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat OT OFFICE SUPPLIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Juli 2020Beginn der Liquidation
    12. Dez. 2023Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3DF Manchester
    Praktiker
    2 St Peters Square
    M2 3DF Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0