RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED

RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRICHARDSONS WESTGARTH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00067599
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RICHARDSONS WESTGARTH P L C29. Okt. 190029. Okt. 1900

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Sept. 2022

    7 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von George Clinton Jones als Geschäftsführer am 16. Dez. 2021

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 24. Sept. 2021

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2021 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    4 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 20. Dez. 2020

    • Kapital: GBP 0.10
    3 SeitenSH19

    legacy

    4 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Peter Whiting als Direktor am 01. Apr. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Barrie Clive Salter als Direktor am 14. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Gross als Direktor am 14. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kakha Avaliani als Geschäftsführer am 14. Dez. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Henry Gross als Sekretär am 01. Okt. 2018

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ciara Milne als Sekretär am 01. Okt. 2018

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Ciara Milne als Geschäftsführer am 16. Juli 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GROSS, David Henry
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Sekretär
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    251144510001
    GROSS, David
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Geschäftsführer
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandAmerican253044410001
    SALTER, Barrie Clive
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Geschäftsführer
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandBritish253495610001
    WHITING, Peter
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Geschäftsführer
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandBritish256986430001
    DEVONPORT, Karen
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Sekretär
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    British108483890002
    JOYCE, Martin Joseph
    2 Spa Mews
    Boston Spa
    LS23 6TR Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    2 Spa Mews
    Boston Spa
    LS23 6TR Leeds
    West Yorkshire
    British7474650002
    MARJORIBANKS, Richard John Bradley
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    Sekretär
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    178398790001
    MIDDIS, Kevin John
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    Sekretär
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    British81620510001
    MILNE, Ciara
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    Sekretär
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    212823850001
    SPENCER, Joanne Louise
    22 Lidgett Way
    Royston
    S71 4FD Barnsley
    South Yorkshire
    Sekretär
    22 Lidgett Way
    Royston
    S71 4FD Barnsley
    South Yorkshire
    British83985870001
    ARMSTRONG, Gregory Francis John
    5 Barnetts Grove
    DY10 3HG Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    5 Barnetts Grove
    DY10 3HG Kidderminster
    Worcestershire
    British9444610001
    AVALIANI, Kakha
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Geschäftsführer
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandBritish152448300001
    DEAN, Alan Martin
    Bollindale South Road
    Hale
    WA14 3HT Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bollindale South Road
    Hale
    WA14 3HT Altrincham
    Cheshire
    British62800840003
    DEVONPORT, Karen
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Geschäftsführer
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    United KingdomBritish108483890002
    HURST, Philip John
    The Court House
    12 Draycott Road Upper Tean
    ST10 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Court House
    12 Draycott Road Upper Tean
    ST10 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    British9447640003
    JONES, George Clinton
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Geschäftsführer
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    United KingdomBritish70121220002
    JOYCE, Martin Joseph
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish7474650008
    MACDONALD, Alexander Scott
    2 St Helens Grove
    Sandal
    WF2 6RR Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 St Helens Grove
    Sandal
    WF2 6RR Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish3480700001
    MIDDIS, Kevin John
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    EnglandBritish81620510001
    MILNE, Ciara
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish209116720001
    PAYTON, Roger Louis
    Little Bedwell Essendon
    Cucumber Lane
    AL9 6JA Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Little Bedwell Essendon
    Cucumber Lane
    AL9 6JA Hatfield
    Hertfordshire
    British1866960001
    RINGWOOD, George
    26 Dower Chase
    Escrick
    YO4 6JF York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    26 Dower Chase
    Escrick
    YO4 6JF York
    North Yorkshire
    British9298090001
    SKELTON, Nichola
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish161424200001
    TAINTON, John Samuel
    Bramblings
    Frenchlands Lane
    WR2 6QU Lower Broadheath
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Bramblings
    Frenchlands Lane
    WR2 6QU Lower Broadheath
    Worcestershire
    British9305720001
    TAYLOR, Paul
    32 Sutherland Drive
    Westlands
    ST5 3EN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    32 Sutherland Drive
    Westlands
    ST5 3EN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British50931220001
    TIPLADY, John Eason
    7 Osborne Drive
    Todwick
    S26 1HW Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 Osborne Drive
    Todwick
    S26 1HW Sheffield
    South Yorkshire
    British3480680001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Kloeckner Metals Uk Holdings Limited
    Valley Farm Road
    LS10 1SD Leeds
    Kmuk
    England
    06. Apr. 2016
    Valley Farm Road
    LS10 1SD Leeds
    Kmuk
    England
    Nein
    RechtsformLimited
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006, Uk Gaap Inc Frs 101
    RegistrierungsortCompanies House - Cardiff
    Registrierungsnummer5310738
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Group debenture
    Erstellt am 16. März 2005
    Geliefert am 19. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as security agent and trustee for the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transaktionen
    • 19. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Okt. 1994
    Geliefert am 31. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property at drum road, drum industrial estate, chester-le-street, county durham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Mai 1992
    Geliefert am 03. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a premises at tunstall road, biddulph, stafford and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Licence to underlet
    Erstellt am 31. Okt. 1986
    Geliefert am 17. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £4,500 deposited pursuant to a licence to underlet dated 31/10/86.
    Berechtigte Personen
    • W P Pension Trustees Limited
    • W P Group Pension Trustees Limited
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 20. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Apr. 1984
    Geliefert am 30. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the south of elm road shoeburyness southend on sea, essex. Title no ex 189555 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Apr. 1984
    Geliefert am 30. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the south side of vanguard way, shoeburyness, southend on sea, essex. Title no. Ex 170499 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. März 1984
    Geliefert am 12. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the east of easthampstead road, bracknell berkshire title no. Bk 123332 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1984
    Geliefert am 12. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as land lying to the east of easthampstead road bracknell, berkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1984Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. März 1984
    Geliefert am 12. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the east of easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 53565 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1984Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. März 1984
    Geliefert am 12. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the north side of easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 83638 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1984Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. März 1984
    Geliefert am 12. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 rosemount easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 149899 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1984Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. März 1984
    Geliefert am 12. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 rosemount easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 150306 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 29. Sept. 1983
    Geliefert am 10. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts goodwill uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    • 13. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Sept. 2021Beginn der Liquidation
    18. März 2023Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0