RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00067599 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Gesch äftstelle | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RICHARDSONS WESTGARTH P L C | 29. Okt. 1900 | 29. Okt. 1900 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Sept. 2022 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von George Clinton Jones als Geschäftsführer am 16. Dez. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter Whiting als Direktor am 01. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Barrie Clive Salter als Direktor am 14. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Gross als Direktor am 14. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kakha Avaliani als Geschäftsführer am 14. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Henry Gross als Sekretär am 01. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ciara Milne als Sekretär am 01. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ciara Milne als Geschäftsführer am 16. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS, David Henry | Sekretär | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | 251144510001 | |||||||
| GROSS, David | Geschäftsführer | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | England | American | 253044410001 | |||||
| SALTER, Barrie Clive | Geschäftsführer | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | England | British | 253495610001 | |||||
| WHITING, Peter | Geschäftsführer | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | England | British | 256986430001 | |||||
| DEVONPORT, Karen | Sekretär | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | British | 108483890002 | ||||||
| JOYCE, Martin Joseph | Sekretär | 2 Spa Mews Boston Spa LS23 6TR Leeds West Yorkshire | British | 7474650002 | ||||||
| MARJORIBANKS, Richard John Bradley | Sekretär | Road Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm West Yorkshire England | 178398790001 | |||||||
| MIDDIS, Kevin John | Sekretär | Silverdale Old Forge Gardens DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | British | 81620510001 | ||||||
| MILNE, Ciara | Sekretär | Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm Road West Yorkshire England | 212823850001 | |||||||
| SPENCER, Joanne Louise | Sekretär | 22 Lidgett Way Royston S71 4FD Barnsley South Yorkshire | British | 83985870001 | ||||||
| ARMSTRONG, Gregory Francis John | Geschäftsführer | 5 Barnetts Grove DY10 3HG Kidderminster Worcestershire | British | 9444610001 | ||||||
| AVALIANI, Kakha | Geschäftsführer | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | England | British | 152448300001 | |||||
| DEAN, Alan Martin | Geschäftsführer | Bollindale South Road Hale WA14 3HT Altrincham Cheshire | British | 62800840003 | ||||||
| DEVONPORT, Karen | Geschäftsführer | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | United Kingdom | British | 108483890002 | |||||
| HURST, Philip John | Geschäftsführer | The Court House 12 Draycott Road Upper Tean ST10 4JF Stoke On Trent Staffordshire | British | 9447640003 | ||||||
| JONES, George Clinton | Geschäftsführer | Valley Farm Road Stourton LS10 1SD Leeds | United Kingdom | British | 70121220002 | |||||
| JOYCE, Martin Joseph | Geschäftsführer | 2 Meynell Lane Meynell Road Colton LS15 9BZ Leeds West Yorkshire | England | British | 7474650008 | |||||
| MACDONALD, Alexander Scott | Geschäftsführer | 2 St Helens Grove Sandal WF2 6RR Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 3480700001 | |||||
| MIDDIS, Kevin John | Geschäftsführer | Silverdale Old Forge Gardens DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | England | British | 81620510001 | |||||
| MILNE, Ciara | Geschäftsführer | Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm Road West Yorkshire England | United Kingdom | British | 209116720001 | |||||
| PAYTON, Roger Louis | Geschäftsführer | Little Bedwell Essendon Cucumber Lane AL9 6JA Hatfield Hertfordshire | British | 1866960001 | ||||||
| RINGWOOD, George | Geschäftsführer | 26 Dower Chase Escrick YO4 6JF York North Yorkshire | British | 9298090001 | ||||||
| SKELTON, Nichola | Geschäftsführer | Road Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm West Yorkshire England | United Kingdom | British | 161424200001 | |||||
| TAINTON, John Samuel | Geschäftsführer | Bramblings Frenchlands Lane WR2 6QU Lower Broadheath Worcestershire | British | 9305720001 | ||||||
| TAYLOR, Paul | Geschäftsführer | 32 Sutherland Drive Westlands ST5 3EN Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 50931220001 | ||||||
| TIPLADY, John Eason | Geschäftsführer | 7 Osborne Drive Todwick S26 1HW Sheffield South Yorkshire | British | 3480680001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloeckner Metals Uk Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Valley Farm Road LS10 1SD Leeds Kmuk England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Erstellt am 16. März 2005 Geliefert am 19. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as security agent and trustee for the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Okt. 1994 Geliefert am 31. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at drum road, drum industrial estate, chester-le-street, county durham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Mai 1992 Geliefert am 03. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a premises at tunstall road, biddulph, stafford and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Licence to underlet | Erstellt am 31. Okt. 1986 Geliefert am 17. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sum of £4,500 deposited pursuant to a licence to underlet dated 31/10/86. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Apr. 1984 Geliefert am 30. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the south of elm road shoeburyness southend on sea, essex. Title no ex 189555 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Apr. 1984 Geliefert am 30. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the south side of vanguard way, shoeburyness, southend on sea, essex. Title no. Ex 170499 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. März 1984 Geliefert am 12. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the east of easthampstead road, bracknell berkshire title no. Bk 123332 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. März 1984 Geliefert am 12. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as land lying to the east of easthampstead road bracknell, berkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. März 1984 Geliefert am 12. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the east of easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 53565 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. März 1984 Geliefert am 12. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the north side of easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 83638 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. März 1984 Geliefert am 12. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 rosemount easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 149899 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. März 1984 Geliefert am 12. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 rosemount easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 150306 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Sept. 1983 Geliefert am 10. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts goodwill uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0