RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00078153 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TI RALEIGH (INTERNATIONAL) LIMITED | 31. Dez. 1977 | 31. Dez. 1977 |
| RALEIGH INDUSTRIES (INTERNATIONAL) LIMITED | 17. Juli 1903 | 17. Juli 1903 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam Joseph Stubbins als Sekretär am 01. März 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Adam Joseph Stubbins als Sekretär am 24. Nov. 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart Atkins als Sekretär am 24. Nov. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lee Stephen Kidger als Geschäftsführer am 04. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Philippa Wibberley als Direktor am 04. Aug. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Accell Global Bv als Direktor am 20. Juni 2023 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthonie Hilbert Anbeek als Geschäftsführer am 20. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Lee Kidger am 01. Feb. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Nov. 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Dez. 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Lee Kidger als Direktor am 01. Juli 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philippa Wibberley als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBBERLEY, Philippa | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | England | British | 203202500001 | |||||||||||||
| ACCELL GLOBAL BV | Geschäftsführer | Industrieweg 8444ar Heerenveen 4 Netherlands |
| 310707160001 | ||||||||||||||
| ATKINS, Stuart | Sekretär | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | 196324330001 | |||||||||||||||
| BIRD, Catherine Anne | Sekretär | 29 Hall Croft NG9 1EL Beeston Nottingham | British | 95128680001 | ||||||||||||||
| BOOTH, Lyne | Sekretär | 22 Milton Road DE7 8NU Ilkeston Derbyshire | British | 74497280001 | ||||||||||||||
| CHOLERTON, Hugh Nevil | Sekretär | 48 Burnside Drive Bramcote Hills NG9 3EE Nottingham Nottinghamshire | British | 8803710001 | ||||||||||||||
| FATKIN, David Anthony | Sekretär | Fairways Sycamore Lane Bleasby NG14 7GJ Nottingham Nottinghamshire | British | 49698200001 | ||||||||||||||
| GODDARD, Simon John | Sekretär | 45 Ullswater Crescent Bramcote NG9 3BE Nottingham Nottinghamshire | British | 9733060001 | ||||||||||||||
| GOULDTHORP, Mark Aidan | Sekretär | 10 Olive Grove Burton Joyce NG14 5FG Nottingham | British | 78952750002 | ||||||||||||||
| GRAHAM, Alan Norman | Sekretär | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | 170918330001 | |||||||||||||||
| STUBBINS, Adam Joseph | Sekretär | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | 316366040001 | |||||||||||||||
| TESSYMAN, Keith Francis | Sekretär | 18 Oak Tree Drive Gedling NG4 4DA Nottingham | British | 24873820001 | ||||||||||||||
| WALKER, Timothy | Sekretär | 6 Zulla Road Mapperley Park NG3 5BY Nottingham Nottinghamshire | British | 8803780003 | ||||||||||||||
| ANBEEK, Anthonie Hilbert | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | Netherlands | Dutch | 245587790001 | |||||||||||||
| BLOK, Jeroen Maria Snijders | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | Netherlands | Dutch | 180302150001 | |||||||||||||
| DARNTON, Phillip Leyland | Geschäftsführer | 75 Limerston Street SW10 0BL London | United Kingdom | British | 48864380001 | |||||||||||||
| FATKIN, David Anthony | Geschäftsführer | Fairways Sycamore Lane Bleasby NG14 7GJ Nottingham Nottinghamshire | British | 49698200001 | ||||||||||||||
| FEENEMA, Gerard Jacob | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | Netherlands | Dutch | 225902350001 | |||||||||||||
| FILS-AIME, Reggie | Geschäftsführer | 8 Gault Avenue Westport IRISH Connecticut Ct 06880 Usa | American | 65981880001 | ||||||||||||||
| FINDEN-CROFTS, Alan John | Geschäftsführer | Willowhayne House Tamarisk Way Willowhayne Estate East Preston BN16 2TE Little Hampton West Sussex | British | 1546980003 | ||||||||||||||
| GODDARD, Simon John | Geschäftsführer | 45 Ullswater Crescent Bramcote NG9 3BE Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 9733060001 | |||||||||||||
| GOULDTHORP, Mark Aidan | Geschäftsführer | Main Street Oxton NG25 0SD Southwell Carrick House Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 78952750004 | |||||||||||||
| HANCOCK, Michael William | Geschäftsführer | De Cortenaer Biesdelsalaan 1-A2 FOREIGN 6881 Ca Velp (Gld) Netherlands | British | 17107510001 | ||||||||||||||
| HANDLEY, Christopher John | Geschäftsführer | 9 Egerton Road Woodthorpe NG5 4FF Nottingham Nottinghsmshire | British | 31694220002 | ||||||||||||||
| JONES, Mervyn Bernard | Geschäftsführer | Oak Tree Court Tollerton NG12 4HJ Nottingham Greenacres United Kingdom | United Kingdom | English | 90496990003 | |||||||||||||
| KIDGER, Lee Stephen | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | England | British | 271948180002 | |||||||||||||
| MACNAUGHTON, John Godfrey | Geschäftsführer | 3 Kingston Hall NG11 0DJ Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 90496950001 | |||||||||||||
| REYNOLDS, Michael John | Geschäftsführer | 24 Main Street LE14 4QW Saltby Leicestershire | United Kingdom | British | 95504810001 | |||||||||||||
| SYBESMA, Hielke Hayo | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | Netherlands | Dutch | 181817310001 | |||||||||||||
| TAKENS, Rene Jan | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | Netherlands | Dutch | 180304610001 | |||||||||||||
| THOMAS, Eric Robert | Geschäftsführer | 252 Melton Road Edwalton NG12 4AG Nottingham | British | 9733070001 | ||||||||||||||
| TODD, Mark James | Geschäftsführer | 2 Esk Hause Close West Bridgford NG2 6SG Nottingham | British | 54190140002 | ||||||||||||||
| WALKER, Timothy | Geschäftsführer | 6 Zulla Road Mapperley Park NG3 5BY Nottingham Nottinghamshire | British | 8803780003 | ||||||||||||||
| WIBBERLEY, Philippa | Geschäftsführer | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham Nottinghamshire | England | British | 203202500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh Holdings Ltd | 06. Apr. 2016 | Church Street Eastwood NG16 3HT Nottingham 136 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Erstellt am 28. Feb. 2013 Geliefert am 12. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all the right title and interest from time to time in under and to all inventory together with all related rights and by way of floating charge all present and future trade receivables and inventory see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Feb. 2010 Geliefert am 26. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Mai 1998 Geliefert am 22. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the secured beneficiaries) or any of the other secured beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital intellectual property rights buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination agreement | Erstellt am 06. März 1997 Geliefert am 21. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by derby holding B.V. (the "borrower") to the chargee under or in connection with the senior credit agreement, the subordination agreement, each inter-group guarantee, the fee letter, novation certificate, deed of accession or any other document designated as a finance document by banque nationale de paris (the "agent") and the borrower, (each such document being a "finance document") together with all such sums being referred to as the "senior debt" | |
Kurze Angaben All present and future liabilities of the borrower to the company the "junior debt". | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. März 1992 Geliefert am 04. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture & guarantee | Erstellt am 03. Apr. 1987 Geliefert am 23. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company derby international corporation S.A. and/or raleigh ireland limited under or in respect of the "secured liabilities" as defined in the charge. | |
Kurze Angaben For full details see form 395 and continuation sheet relevant to this charge.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A debenture & guarantee | Erstellt am 03. Apr. 1987 Geliefert am 14. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing all moneys due or to become due from raleigh international limited and/or derby international corporation S.A. and/or raleigh industries limited and/or sturmey-archer limited to the chargee under the terms of two facility letters dated 3RD april '87 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0