RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED

RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRALEIGH INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00078153
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TI RALEIGH (INTERNATIONAL) LIMITED31. Dez. 197731. Dez. 1977
    RALEIGH INDUSTRIES (INTERNATIONAL) LIMITED17. Juli 190317. Juli 1903

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Adam Joseph Stubbins als Sekretär am 01. März 2024

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Adam Joseph Stubbins als Sekretär am 24. Nov. 2023

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Stuart Atkins als Sekretär am 24. Nov. 2023

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Lee Stephen Kidger als Geschäftsführer am 04. Aug. 2023

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Philippa Wibberley als Direktor am 04. Aug. 2023

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Accell Global Bv als Direktor am 20. Juni 2023

    2 SeitenAP02

    Beendigung der Bestellung von Anthonie Hilbert Anbeek als Geschäftsführer am 20. Juni 2023

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Lee Kidger am 01. Feb. 2023

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2022 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 23. Nov. 2021

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Dez. 2019

    10 SeitenAA

    Ernennung von Mr Lee Kidger als Direktor am 01. Juli 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philippa Wibberley als Geschäftsführer am 30. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WIBBERLEY, Philippa
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish203202500001
    ACCELL GLOBAL BV
    Industrieweg
    8444ar Heerenveen
    4
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Industrieweg
    8444ar Heerenveen
    4
    Netherlands
    RechtsformBESLOTEN VENNOOTSCHAP
    Art des AusweisesAndere Körperschaft oder Firma
    RechtsgrundlageDUTCH CIVIL CODE
    Registrierungsnummer857984081
    310707160001
    ATKINS, Stuart
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    196324330001
    BIRD, Catherine Anne
    29 Hall Croft
    NG9 1EL Beeston
    Nottingham
    Sekretär
    29 Hall Croft
    NG9 1EL Beeston
    Nottingham
    British95128680001
    BOOTH, Lyne
    22 Milton Road
    DE7 8NU Ilkeston
    Derbyshire
    Sekretär
    22 Milton Road
    DE7 8NU Ilkeston
    Derbyshire
    British74497280001
    CHOLERTON, Hugh Nevil
    48 Burnside Drive
    Bramcote Hills
    NG9 3EE Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    48 Burnside Drive
    Bramcote Hills
    NG9 3EE Nottingham
    Nottinghamshire
    British8803710001
    FATKIN, David Anthony
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British49698200001
    GODDARD, Simon John
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    British9733060001
    GOULDTHORP, Mark Aidan
    10 Olive Grove
    Burton Joyce
    NG14 5FG Nottingham
    Sekretär
    10 Olive Grove
    Burton Joyce
    NG14 5FG Nottingham
    British78952750002
    GRAHAM, Alan Norman
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    170918330001
    STUBBINS, Adam Joseph
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    316366040001
    TESSYMAN, Keith Francis
    18 Oak Tree Drive
    Gedling
    NG4 4DA Nottingham
    Sekretär
    18 Oak Tree Drive
    Gedling
    NG4 4DA Nottingham
    British24873820001
    WALKER, Timothy
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    British8803780003
    ANBEEK, Anthonie Hilbert
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch245587790001
    BLOK, Jeroen Maria Snijders
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch180302150001
    DARNTON, Phillip Leyland
    75 Limerston Street
    SW10 0BL London
    Geschäftsführer
    75 Limerston Street
    SW10 0BL London
    United KingdomBritish48864380001
    FATKIN, David Anthony
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British49698200001
    FEENEMA, Gerard Jacob
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch225902350001
    FILS-AIME, Reggie
    8 Gault Avenue
    Westport
    IRISH Connecticut
    Ct 06880
    Usa
    Geschäftsführer
    8 Gault Avenue
    Westport
    IRISH Connecticut
    Ct 06880
    Usa
    American65981880001
    FINDEN-CROFTS, Alan John
    Willowhayne House Tamarisk Way
    Willowhayne Estate East Preston
    BN16 2TE Little Hampton
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Willowhayne House Tamarisk Way
    Willowhayne Estate East Preston
    BN16 2TE Little Hampton
    West Sussex
    British1546980003
    GODDARD, Simon John
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish9733060001
    GOULDTHORP, Mark Aidan
    Main Street
    Oxton
    NG25 0SD Southwell
    Carrick House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Main Street
    Oxton
    NG25 0SD Southwell
    Carrick House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish78952750004
    HANCOCK, Michael William
    De Cortenaer
    Biesdelsalaan 1-A2
    FOREIGN 6881 Ca Velp (Gld)
    Netherlands
    Geschäftsführer
    De Cortenaer
    Biesdelsalaan 1-A2
    FOREIGN 6881 Ca Velp (Gld)
    Netherlands
    British17107510001
    HANDLEY, Christopher John
    9 Egerton Road
    Woodthorpe
    NG5 4FF Nottingham
    Nottinghsmshire
    Geschäftsführer
    9 Egerton Road
    Woodthorpe
    NG5 4FF Nottingham
    Nottinghsmshire
    British31694220002
    JONES, Mervyn Bernard
    Oak Tree Court
    Tollerton
    NG12 4HJ Nottingham
    Greenacres
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Oak Tree Court
    Tollerton
    NG12 4HJ Nottingham
    Greenacres
    United Kingdom
    United KingdomEnglish90496990003
    KIDGER, Lee Stephen
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish271948180002
    MACNAUGHTON, John Godfrey
    3 Kingston Hall
    NG11 0DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Kingston Hall
    NG11 0DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish90496950001
    REYNOLDS, Michael John
    24 Main Street
    LE14 4QW Saltby
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    24 Main Street
    LE14 4QW Saltby
    Leicestershire
    United KingdomBritish95504810001
    SYBESMA, Hielke Hayo
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch181817310001
    TAKENS, Rene Jan
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch180304610001
    THOMAS, Eric Robert
    252 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AG Nottingham
    Geschäftsführer
    252 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AG Nottingham
    British9733070001
    TODD, Mark James
    2 Esk Hause Close
    West Bridgford
    NG2 6SG Nottingham
    Geschäftsführer
    2 Esk Hause Close
    West Bridgford
    NG2 6SG Nottingham
    British54190140002
    WALKER, Timothy
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    British8803780003
    WIBBERLEY, Philippa
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish203202500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Raleigh Holdings Ltd
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    136
    England
    06. Apr. 2016
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    136
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer00076181
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A security agreement
    Erstellt am 28. Feb. 2013
    Geliefert am 12. März 2013
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all the right title and interest from time to time in under and to all inventory together with all related rights and by way of floating charge all present and future trade receivables and inventory see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transaktionen
    • 12. März 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 30. Juli 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Feb. 2010
    Geliefert am 26. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Mai 1998
    Geliefert am 22. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the secured beneficiaries) or any of the other secured beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital intellectual property rights buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 22. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordination agreement
    Erstellt am 06. März 1997
    Geliefert am 21. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by derby holding B.V. (the "borrower") to the chargee under or in connection with the senior credit agreement, the subordination agreement, each inter-group guarantee, the fee letter, novation certificate, deed of accession or any other document designated as a finance document by banque nationale de paris (the "agent") and the borrower, (each such document being a "finance document") together with all such sums being referred to as the "senior debt"
    Kurze Angaben
    All present and future liabilities of the borrower to the company the "junior debt".
    Berechtigte Personen
    • The "Senior Creditors" as Defined Therein
    Transaktionen
    • 21. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. März 1992
    Geliefert am 04. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 04. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture & guarantee
    Erstellt am 03. Apr. 1987
    Geliefert am 23. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company derby international corporation S.A. and/or raleigh ireland limited under or in respect of the "secured liabilities" as defined in the charge.
    Kurze Angaben
    For full details see form 395 and continuation sheet relevant to this charge.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Ireland Limited.
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    A debenture & guarantee
    Erstellt am 03. Apr. 1987
    Geliefert am 14. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all moneys due or to become due from raleigh international limited and/or derby international corporation S.A. and/or raleigh industries limited and/or sturmey-archer limited to the chargee under the terms of two facility letters dated 3RD april '87
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 26. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0