CNC MILBURN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCNC MILBURN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00086532
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CNC MILBURN LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich CNC MILBURN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Great Central House
    Great Central Avenue
    HA4 6TS South Ruislip
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CNC MILBURN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MILBURN ESTATES LIMITED(THE)20. Nov. 190520. Nov. 1905

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CNC MILBURN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für CNC MILBURN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Apr. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Apr. 2009

    5 Seiten4.68

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    7 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Apr. 2008

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten287

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    9 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    15 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    15 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    14 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von CNC MILBURN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AVIS, Marie Annick
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    Sekretär
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    British91430630002
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Geschäftsführer
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    BACKHOUSE, Edward Stuart
    2 Lindisfarne
    High Shincliffe
    DH1 2PH Durham
    County Durham
    Sekretär
    2 Lindisfarne
    High Shincliffe
    DH1 2PH Durham
    County Durham
    British14320160001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Sekretär
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Geschäftsführer
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    MILBURN, Anthony Rupert, Sir
    Guyzance Hall
    Acklington
    NE65 9AG Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Guyzance Hall
    Acklington
    NE65 9AG Morpeth
    Northumberland
    British14320200001
    REED, Gavin Barras
    Whitehill
    KY3 0RW Aberdour
    Fife
    Geschäftsführer
    Whitehill
    KY3 0RW Aberdour
    Fife
    British7790001
    SISSON, Henry John Hancock
    18 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    18 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British14320180001
    SISSON, Richard Henry Westcott
    7 Hawarden Hill
    NW2 7BR London
    Geschäftsführer
    7 Hawarden Hill
    NW2 7BR London
    EnglandBritish14320190001
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002
    WHATELY, Julian Richard
    The Manor House Church Lane
    Holybourne
    GU34 4HD Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Manor House Church Lane
    Holybourne
    GU34 4HD Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish2960780004

    Hat CNC MILBURN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 22. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 26. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the senior finance documents (or any of them) to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent)
    Transaktionen
    • 26. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 1998
    Geliefert am 18. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a newe house pilgrim street newcastle upon tyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 1998
    Geliefert am 18. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property on the north side of northumberland road newcastle upon tyne t/no.TY77919. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rents assignment
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest present and future to and in the assigned property which means all rents and other income and all other monies in respect of the property (including under the leases and the future leases and any of them). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a dean court 22-28 dean street newcastle upon tyne t/no.TY238951 and all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of securities
    Erstellt am 26. Juni 1997
    Geliefert am 02. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any stocks shares or bonds warrants or other securities from time to time (1) named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank by reference to the charge of securities in cluding all and any of the shares or securities in the capital of regis & regis limited beneficially held by the company or (2) in respect of which title or the relative account entries is/are held in the name of the bank or its nominee or (3) in respect of which the relative certificates or othere title documents are deposited with or held to the order of the bank or its nominee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juni 1997
    Geliefert am 02. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property land and buildings k/a cathedral buildings deam street newcastle upon tyne and the plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings tools and equipment the present and future goodwill and the proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juni 1997
    Geliefert am 02. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a milburn house dean street necastle upon tyne and the plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels the present and future goodwill and the proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Juni 1997
    Geliefert am 20. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at dean court 22-28 dean street newcastle upon tyne. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Juni 1997
    Geliefert am 20. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at the newe house 10/12 pilgrim street newcastle upon tyne. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 1987
    Geliefert am 31. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a milburn house bounded by dean street the side and st. Nicholas church yard newcastle upon tyne.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 18. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CNC MILBURN LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Jan. 2011Aufgelöst am
    30. Apr. 2008Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Solomon Cohen
    Pitman Cohen Recoveries Llp
    Great Central House
    HA4 6TS Great Central Avenue
    South Ruislip Middlesex
    Praktiker
    Pitman Cohen Recoveries Llp
    Great Central House
    HA4 6TS Great Central Avenue
    South Ruislip Middlesex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0