INTERSERVE PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINTERSERVE PLC
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00088456
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INTERSERVE PLC?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich INTERSERVE PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ernst & Young Llp 1
    More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INTERSERVE PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TILBURY DOUGLAS PLC22. Okt. 199122. Okt. 1991
    TILBURY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY31. Dez. 198131. Dez. 1981
    TILBURY CONTRACTING GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY19. Apr. 190619. Apr. 1906

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTERSERVE PLC?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2019
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2020
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für INTERSERVE PLC?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Juni 2019
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung05. Juli 2019
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Juni 2018
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für INTERSERVE PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    13 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    13 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    14 SeitenWU07

    Ernennung eines Liquidators

    3 SeitenWU04

    Mitteilung über die Entfernung des Liquidators durch das Gericht

    13 SeitenWU14

    Ernennung eines Liquidators

    7 SeitenWU04

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    4 SeitenCOCOMP

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    15 SeitenAM25

    Überarbeitung der Vorschläge des Verwalters

    14 SeitenAM08

    Überarbeiteter Vorschlag des Verwalters

    7 SeitenAM09

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    14 SeitenAM10

    Beendigung der Bestellung von Andrew John Mcdonald als Sekretär am 01. März 2021

    2 SeitenTM02

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    17 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    17 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    18 SeitenAM10

    Gerichtsbeschluss

    S1096 Court Order to Rectify
    2 SeitenOC

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Beendigung der Bestellung von Russell John King als Geschäftsführer am 09. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Debra Jayne White als Geschäftsführer am 31. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    19 SeitenAM10

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Robin Salmon als Geschäftsführer am 09. Okt. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charles Nicholas Pollard als Geschäftsführer am 07. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anne Kathleen Fahy als Geschäftsführer am 01. Okt. 2019

    1 SeitenTM01

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    68 SeitenAM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF zum Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF am 10. Mai 2019

    2 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von INTERSERVE PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARKER, Glyn Anthony
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    United KingdomBritish203881750001
    EDWARDS, Gareth Maitland
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    EnglandBritish223767140001
    WHITELING, Mark Argent
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    EnglandBritish101297630001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Sekretär
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    British47884750003
    BUSH, Daniel
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Sekretär
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    241506270001
    MCDONALD, Andrew John
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    Sekretär
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    247239780001
    RICHARDSON, Lyn
    46 Strawberry Fields
    Bramley
    RG26 5QF Tadley
    Hampshire
    Sekretär
    46 Strawberry Fields
    Bramley
    RG26 5QF Tadley
    Hampshire
    British21865010001
    SEDGWICK, Christopher Edward
    The Cedars 20 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Sekretär
    The Cedars 20 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British5127580001
    BALFOUR, George Patrick
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish4867010002
    BECKER, Hermann
    C/O Phillip Holzmann Ag
    Taunusanlagei 6000
    Frankfort/Main
    Germany
    Geschäftsführer
    C/O Phillip Holzmann Ag
    Taunusanlagei 6000
    Frankfort/Main
    Germany
    German12076030001
    BLACKWELL, Norman Roy, Lord
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish70686340001
    BOTTJER, Michael Colin
    Larchlands
    Larch Avenue
    SL5 0AP Sunninghill
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Larchlands
    Larch Avenue
    SL5 0AP Sunninghill
    Berkshire
    British66295720001
    BRAND, Cedric
    13 Royal Crescent
    BN2 1AL Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    13 Royal Crescent
    BN2 1AL Brighton
    East Sussex
    British4473260001
    CARR, Michael Lewis
    Flat 7
    46 Elm Park Road
    SW3 6AX London
    Geschäftsführer
    Flat 7
    46 Elm Park Road
    SW3 6AX London
    British36816040001
    CULLEN, Leslie Gray
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish15782290001
    DANCE, Steven Louis
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    EnglandBritish127172680001
    DOUGLAS, John Robert Tomkys
    Mary Tudor Cottage
    BH15 1NF 8 Market Street Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    Mary Tudor Cottage
    BH15 1NF 8 Market Street Poole
    Dorset
    British50903780002
    FAHY, Anne Kathleen
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    EnglandIrish174845290001
    GROOM, Clive Jeremy
    6 Fulmar Court
    Arundel Way Highcliffe
    BH23 5DX Christchurch
    Geschäftsführer
    6 Fulmar Court
    Arundel Way Highcliffe
    BH23 5DX Christchurch
    British95142990001
    HAGERTY, Stewart
    The Chapel
    Bayham Estate
    TN3 8BG Lamberhurst
    Kent
    Geschäftsführer
    The Chapel
    Bayham Estate
    TN3 8BG Lamberhurst
    Kent
    British123581750001
    HANNAH, Allan Richardson
    3 Lowes Close
    Lower Shiplake
    RG9 3NG Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    3 Lowes Close
    Lower Shiplake
    RG9 3NG Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish34942410007
    HAYWOOD, Timothy Paul
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    EnglandBritish252141390002
    JOHNSTON, Norman Gill
    41 Ashdale Park
    Lower Wokingham Road
    RG11 3QS Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    41 Ashdale Park
    Lower Wokingham Road
    RG11 3QS Wokingham
    Berkshire
    British11823100001
    JONES, Timothy Charles
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    EnglandBritish81110720001
    KEEGAN, Nicholas Francis
    Alderminster Lodge
    Alderminster
    CV37 8NY Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Alderminster Lodge
    Alderminster
    CV37 8NY Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish103638150001
    KEYS, David Chaloner
    Tower Hill House
    Tower Hill
    RH4 2AP Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tower Hill House
    Tower Hill
    RH4 2AP Dorking
    Surrey
    British13890050001
    KING, Russell John
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    EnglandBritish276500910001
    LEE, Malcolm Stuart
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    British12264540006
    LOGTERS, Gerhard, Dr-Ing
    Lerchesbergring 83 Frankfurt/Main
    60598 Hessen
    FOREIGN Germany
    Geschäftsführer
    Lerchesbergring 83 Frankfurt/Main
    60598 Hessen
    FOREIGN Germany
    German49331560001
    LUDEMAN, Keith Lawrence
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    EnglandBritish157014200001
    MELIZAN, Bruce Anthony
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Interserve House
    Ruscombe Park
    RG10 9JU Twyford Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish,Trinidadian92905500001
    PADOVAN, John Mario Faskally
    15 Lord North Street
    Westminster
    SW1P 3LD London
    Geschäftsführer
    15 Lord North Street
    Westminster
    SW1P 3LD London
    British7814570003
    PAINE, Robert Arthur
    Beechfield Yealand Conyers
    Lancaster
    LA5 9SG Lancashire
    Geschäftsführer
    Beechfield Yealand Conyers
    Lancaster
    LA5 9SG Lancashire
    EnglandBritish53861730001
    PATERSON, David John
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Geschäftsführer
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    EnglandBritish55601200002
    POLLARD, Charles Nicholas
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp 1
    EnglandBritish248026940001

    Hat INTERSERVE PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 16. Mai 2018
    Geliefert am 21. Mai 2018
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 21. Mai 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 03. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Mai 2018
    Geliefert am 23. Mai 2018
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 23. Mai 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 03. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Mai 2018
    Geliefert am 04. Mai 2018
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent & Trustee for Secured Parties)
    Transaktionen
    • 04. Mai 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 03. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Mai 2018
    Geliefert am 04. Mai 2018
    Teilweise erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land and buildings on the west side of brickyard road, aldridge (registered at the land registry under title number WM8842) and those other plots of land listed in part 4 of schedule 2 to the instrument. For more details, please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent & Trustee for Secured Parties)
    Transaktionen
    • 04. Mai 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 03. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 14. Dez. 2017
    Geliefert am 18. Dez. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    N/A.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Dez. 2017
    Geliefert am 19. Dez. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Dez. 2017
    Geliefert am 18. Dez. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    N/A.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 15. Dez. 1999
    Geliefert am 23. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Feb. 1987
    Geliefert am 11. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All those pieces or parcels of f/h land situated at mill road, radstock somerset together with the buildings erected thereon & now known as tilbury house, mill road.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1987Registrierung einer Belastung
    • 25. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Sept. 1985
    Geliefert am 30. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & premises erected thereon at 16 woodford road, forest gate, newham, london t/n ln 252264 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Sept. 1985
    Geliefert am 30. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & premises erected thereon at 18 woodford road, forest gate, newham, london t/n egl 46075 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 1985
    Geliefert am 23. Aug. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property lying to the south of ruscombe road, twyford, berkshire together with the buildings from time to time erected thereon or on part thereof t/nos bk 58788 & bk 69068 together all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Mai 1985
    Geliefert am 30. Mai 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 280 munster road, fulham together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1982Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 1985
    Geliefert am 01. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H piece or parcel of land with buildings thereon known as farthing green house, london, norfolk together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 1985
    Geliefert am 01. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & building on the south side of new cut lane, woolston, warrington, cheshire. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 1985
    Geliefert am 01. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south side of southend arterial road, lethe warley brentwood, essex together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1985
    Geliefert am 11. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hamilton star sawmills kit lane, ipsder oxfordshire t/n p 180167 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1985
    Geliefert am 11. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the south of armstrong road, maidstone, kent together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1985
    Geliefert am 11. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south-west of ruscombe road, near twyford, berkshire t/n bk 69068 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1985
    Geliefert am 11. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the north-east of springfield road, ruscombe, berkshire t/n bk 58788 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1985
    Geliefert am 11. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All those pieces or parcels of land situate in the parish of ruscombe and twyford in the county of berkshire containing 19 acres 1 rood & 28 perches together with buildings together with all fixtures whatsoever now or at any time herafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sal e act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1985Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Okt. 1984
    Geliefert am 19. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the western side of hermitage lane mansfield, notts together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1982
    Geliefert am 13. Mai 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land situate in the parish of wymondham, norfolk.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 1981
    Geliefert am 17. Dez. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Parcel of land situate adjoining conman road, heathfield, boley, tealy together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1981Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 1981
    Geliefert am 17. Dez. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/hold land and buildings on the north west side ringwood road, poole, dorset title no dt 22817 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank LTD
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1981Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat INTERSERVE PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. März 2019Beginn der Verwaltung
    21. Jan. 2022Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Alan Michael Hudson
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    2
    DatumTyp
    20. Dez. 2021Antragsdatum
    21. Jan. 2022Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Alan Michael Hudson
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    The Official Receiver Or Brighton
    5th Floor Crown House, 11 Regent Hill
    BN1 3ED Brighton
    East Sussex
    Praktiker
    5th Floor Crown House, 11 Regent Hill
    BN1 3ED Brighton
    East Sussex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0