CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00106869 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o C/O BUREAU VERITAS Brandon House 180 Borough High Street SE1 1LB London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CASELLA LONDON LIMITED | 29. Nov. 1993 | 29. Nov. 1993 |
NEATNEON LIMITED | 15. Dez. 1984 | 15. Dez. 1984 |
C.F.CASELLA & CO.,LIMITED | 06. Jan. 1910 | 06. Jan. 1910 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 01. Okt. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Brian Reynolds als Sekretär am 16. Jan. 2012 | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Brian Reynolds als Direktor am 16. Jan. 2012 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Crompton als Sekretär am 11. Jan. 2012 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Paul Crompton als Geschäftsführer am 11. Jan. 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Great Guildford House 30 Great Guildford Street London SE1 0ES am 14. Nov. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Paul Barry als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von James Paul Crompton als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Wirotius als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Laurent Bermejo als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Derrick als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Paul Crompton als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REYNOLDS, Brian | Sekretär | Wilmslow Road Didsbury M20 2RE Manchester Parklands 825a United Kingdom | British | 166534810001 | ||||||
BARRY, Paul | Geschäftsführer | Wilmslow Road M20 2RE Manchester Parklands 825a Didsbury | England | British | None | 149341540001 | ||||
REYNOLDS, Brian | Geschäftsführer | Wilmslow Road M20 2RE Didsbury Parklands 825a Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | None | 122348410001 | ||||
ABLETHORPE, Gayle Kathleen | Sekretär | 28 The Poplars Brayton YO8 9HF Selby North Yorkshire | British | Admin. Manager/Company Sec. | 36075740001 | |||||
CROMPTON, Paul | Sekretär | Wilmslow Road Didsbury M20 2RE Manchester Parklands 825a | British | 147686120001 | ||||||
DERRICK, David John | Sekretär | 10 Kingsbury Drive SK9 2GU Wilmslow Cheshire | British | Company Director | 115578500001 | |||||
JONES, Jeffrey Mark | Sekretär | Southfield House 4 Southfield Avenue Moreton LS17 6RN Leeds West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 60890490001 | |||||
MONAHAN, Paul James | Sekretär | 38 Parkwood Road TW7 5HA Isleworth Middlesex | British | 37072670001 | ||||||
POPE, William, Prof | Sekretär | Home Farm Cottage Main Street Woodend NN12 8RX Towcester Northamptonshire | British | 61080320001 | ||||||
QUIGLEY, Andrew Christopher | Sekretär | 17 Beech Road Hale WA15 9HX Altrincham Cheshire | British | 127552650001 | ||||||
ROBSON, Paul Anthony | Sekretär | 66 Thrupp Close MK19 7PL Castlethorpe Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 103387080001 | |||||
SHEPHERD, Andrew Norman | Sekretär | 39 Oulder Hill Drive OL11 5LB Rochdale Lancashire | British | Finance Director | 103408270001 | |||||
TABERNER, Robert John | Sekretär | 29 Borough Road TW7 5DT Isleworth Middlesex | British | 17766700001 | ||||||
SHOOSMITHS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Exchange House 482 Midsummer Boulevard MK9 2SH Milton Keynes Buckinghamshire | 76282680012 | |||||||
THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Corn Exchange Baffins Lane PO19 1GE Chichester West Sussex | 37896530011 | |||||||
ABRAHAM, Anthony Michael Morrison | Geschäftsführer | Down Farm Elsenham Road CM24 8ST Stansted Essex | British | Director | 17766710001 | |||||
BELFORD, David Sheridan | Geschäftsführer | West Croft Wakefield Road WF8 4HB Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 18821170001 | ||||
BERMEJO, Laurent Philippe | Geschäftsführer | Queen's Gate Place Mews SW7 5BG London 7 | United Kingdom | French | Chief Executive | 127782250002 | ||||
CREED, Stephen Gordon | Geschäftsführer | 10 Bonington Crescent Castlefields ST16 1AY Stafford | British | Company Director | 78458770001 | |||||
CROMPTON, James Paul | Geschäftsführer | Wilmslow Road M20 2RE Manchester Parklands 825a Didsbury | Uk | British | None | 149341690001 | ||||
GUIZE, Olivier Jaques | Geschäftsführer | 37 Smith Terrace SW3 4DH London | French | Director | 93601950001 | |||||
JONES, Jeffrey Mark | Geschäftsführer | Southfield House 4 Southfield Avenue Moreton LS17 6RN Leeds West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 60890490001 | |||||
LAWLESS, Patrick | Geschäftsführer | 24 Eisenhower Drive TN37 7TQ St Leonards On Sea East Sussex | England | British | Company Director | 160351860001 | ||||
MONAHAN, Paul James | Geschäftsführer | 38 Parkwood Road TW7 5HA Isleworth Middlesex | England | British | Financial Director | 37072670001 | ||||
MONAHAN, Paul James | Geschäftsführer | 38 Parkwood Road TW7 5HA Isleworth Middlesex | England | British | Company Director | 37072670001 | ||||
MURPHY, James Robert | Geschäftsführer | Eversley Road Arborfield Cross RG2 9PG Reading The Old Forge Berkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 130968740001 | ||||
PEACOCK, Neil Anthony | Geschäftsführer | Orion Tye Common Road CM12 9PZ Billericay Essex | England | British | Director | 72143550001 | ||||
POPE, William, Prof | Geschäftsführer | Home Farm Cottage Main Street Woodend NN12 8RX Towcester Northamptonshire | England | British | Scientist | 61080320001 | ||||
ROBSON, Paul Anthony | Geschäftsführer | 66 Thrupp Close MK19 7PL Castlethorpe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 103387080001 | ||||
SHEPHERD, Andrew Norman | Geschäftsführer | 39 Oulder Hill Drive OL11 5LB Rochdale Lancashire | England | British | Finance Director | 103408270001 | ||||
SIMPSON, Ian William | Geschäftsführer | The Cottage Sparepenny Lane DA4 0JJ Eynsford Kent | England | British | Director | 26350920003 | ||||
TABERNER, Robert John | Geschäftsführer | 30 Ridgeway Road TW7 5LA Isleworth Middlesex | United Kingdom | British | Director/Chartered Accountant | 17766700002 | ||||
WHELAN, Henry Michael | Geschäftsführer | 28 Tawny Crescent Hartford PE29 1LG Huntingdon Cambridgeshire | British | Director | 96595690001 | |||||
WIROTIUS, Patrick | Geschäftsführer | 8 Rue Du Pont De Pierre Orsay 91400 France | France | French | Company Director | 127731290001 |
Hat CASELLA SCIENCE AND ENVIRONMENT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A deed of variation to a composite guarantee and debenture dated 17 september 2003 | Erstellt am 04. Feb. 2004 Geliefert am 20. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to any security beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 02. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to any security beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charges over all property & assets present & future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 02. Sept. 1996 Geliefert am 17. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of guarantee and debenture | Erstellt am 14. Dez. 1995 Geliefert am 22. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of guarantee and debenture | Erstellt am 18. Juli 1994 Geliefert am 29. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees pursuant to the deed of guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Juli 1993 Geliefert am 22. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of guarantee and debenture | Erstellt am 12. Juli 1993 Geliefert am 19. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of this deed of guarantee and debenture | |
Kurze Angaben See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 16. März 1961 Geliefert am 24. März 1961 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben Regent house, fitgray square, london, N.W. 1. title no. 122586. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0