SUTER ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUTER ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00107150 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUTER ESTATES LIMITED?
- (7020) /
Wo befindet sich SUTER ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Olympia House Armitage Road NW11 8RQ London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUTER ESTATES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HERMETIC SECURITIES LIMITED | 26. Jan. 1910 | 26. Jan. 1910 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUTER ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUTER ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 2 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE am 08. März 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vinod Bachulal Vaghela als Geschäftsführer am 21. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Warner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUTER ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCHESTER, David James | Sekretär | 1 Holly Close IG9 6HT Buckhurst Hill Essex | British | 7014460002 | ||||||
| GAME, Robert William | Geschäftsführer | Newbury Lane Cousley Wood TN5 6HD Wadhurst Rosemary Cottage East Sussex | United Kingdom | English | 139555050001 | |||||
| KEOGH, Mark William | Geschäftsführer | Norfolk House 28 Kidmore Road Caversham RG4 7LU Reading | England | Irish | 62140690001 | |||||
| BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin | Sekretär | Top Farm High Street PE19 6RX Toseland Cambs | British | 63851130001 | ||||||
| FOLGER, Susan | Sekretär | 12 Court Lane Gardens Dulwich SE21 7DZ London | British | 36525980001 | ||||||
| HENSON, Mark Richard | Sekretär | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||
| LOWES, Richard Phillip | Sekretär | 2 Westcott Keep RH6 9US Horley Surrey | British | 5785520001 | ||||||
| PATON WALSH, Antony Edmund | Sekretär | 60 Mount Ararat Road TW10 6PJ Richmond Surrey | British | 43425770001 | ||||||
| WILLIAMS, John Benedict Alan | Sekretär | 16 Oakwood Road Golders Green NW11 6QY London | British | 79419360001 | ||||||
| ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Heathrow Boulevard 284 Bath Road UB7 0DQ West Drayton Middlesex | 69324550001 | |||||||
| ABELL, John David | Geschäftsführer | The Old Rectory Main Street Branston By Belvoir NG32 1RU Grantham Lincolnshire | United Kingdom | British | 71975220001 | |||||
| COLLINS, Peter William | Geschäftsführer | The Oaks 23 Croft Road RG40 3HX Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 26086560001 | |||||
| EDWARDS, John Nigel | Geschäftsführer | 8b Avery Row Mayfair W1K 4AL London | United Kingdom | British | 37742270003 | |||||
| EDWARDS, John Nigel | Geschäftsführer | 976b Garratt Lane SW17 0ND London | British | 37742270001 | ||||||
| FERGUSON, Daniel | Geschäftsführer | 33 The Avenue EN6 1EG Potters Bar Hertfordshire | United Kingdom | British | 29071630001 | |||||
| FIRTH, Arthur Gregory | Geschäftsführer | Westridge House Belvoir Close Colsterworth Lincolnshire | British | 17118450001 | ||||||
| FOLGER, Susan | Geschäftsführer | 12 Court Lane Gardens Dulwich SE21 7DZ London | British | 36525980001 | ||||||
| GRANT, John Albert Martin | Geschäftsführer | The Malthouse Manor Lane Claverdon CV35 8NH Warwick Warwickshire | England | British | 55161940001 | |||||
| HEATHWOOD, Derek Kevin | Geschäftsführer | 47 Fullarton Crescent KA10 6LL Troon South Ayrshire | British | 85468580002 | ||||||
| HEWITT, Alan | Geschäftsführer | The White House Casthorpe Road Barrowby NG32 1DW Grantham Lincolnshire | British | 572100002 | ||||||
| HOARE, Brian David | Geschäftsführer | The Old Barn 32 High Street LE14 4AH Waltham On The Wolds Leicestershire | British | 28340230001 | ||||||
| JONES, Morgan Lewis | Geschäftsführer | 4 Camden Close BR7 5PH Chislehurst Kent | England | British | 10146340003 | |||||
| MEADE, Karl Robert | Geschäftsführer | Holly Mount Penn Road HP9 2TS Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 118074370001 | |||||
| MOORE, Richard | Geschäftsführer | 88 Alzey Gardens AL5 5SZ Harpenden Hertfordshire | British | 73793650001 | ||||||
| REYNOLDS, Malcolm Stanley | Geschäftsführer | 74 Scatterdells Lane Chipperfield WD4 9EX Kings Langley Hertfordshire | British | 10865710001 | ||||||
| RIDER, Stuart Granville | Geschäftsführer | 3 Kesteven Court North Parade NG31 8FP Grantham Lincolnshire | British | 36675890002 | ||||||
| RILEY, Michael James | Geschäftsführer | 16 Ladbroke Road W11 3NJ London | British | 3055390001 | ||||||
| STEVENS, Michael John | Geschäftsführer | 32 Woodfield Park HP6 5QH Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 60348780002 | |||||
| VAGHELA, Vinod Bachulal | Geschäftsführer | 99 Cathles Road Balham SW12 9LF London | England | British | 5689250001 | |||||
| VINCENT, Michael | Geschäftsführer | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | 99258270001 | |||||
| WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir | Geschäftsführer | Marden Grange Marden SN10 3RQ Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 7356840001 | |||||
| WATSON, Ian Richard | Geschäftsführer | Old Dove House Annables Lane AL5 3PR Harpenden Hertfordshire | England | British | 68256540001 | |||||
| WILLIAMS, John Benedict Alan | Geschäftsführer | 16 Oakwood Road Golders Green NW11 6QY London | British | 79419360001 | ||||||
| ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED | Geschäftsführer | 2 Heathrow Boulevard 284 Bath Road UB7 0DQ West Drayton Middlesex | 67372750003 |
Hat SUTER ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 22. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzanine security agreement | Erstellt am 22. Juli 2005 Geliefert am 01. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all estates or interest in any f/h or l/h property now or subsequently owned by it, by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of debenture | Erstellt am 16. Juli 2003 Geliefert am 21. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property 2/22 yorkshire street, burnley t/n LA809118. F/h property the new inn roundabout, pontypool t/n WA583381, f/h property 15 fir tree road hastings t/n HT18815. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Dez. 1998 Geliefert am 07. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission | Erstellt am 23. März 1995 Geliefert am 10. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus debenture | Erstellt am 25. Mai 1994 Geliefert am 01. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1982 Geliefert am 05. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floaitng charges over undertaking and all property including property listed in schedule attached to doc M139 and assets present and future inlcuding uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set-off | Erstellt am 21. Mai 1981 Geliefert am 28. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Special omnibus letter of set off | Erstellt am 30. Juni 1980 Geliefert am 08. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum of sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Special omnibus letter of set off | Erstellt am 01. Jan. 1979 Geliefert am 08. Jan. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SUTER ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0