SUTER ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSUTER ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00107150
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SUTER ESTATES LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich SUTER ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SUTER ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HERMETIC SECURITIES LIMITED26. Jan. 191026. Jan. 1910

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUTER ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für SUTER ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    2 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE am 08. März 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. Feb. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beendigung der Bestellung von Vinod Bachulal Vaghela als Geschäftsführer am 21. Dez. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 03. Mai 2011

    • Kapital: GBP 100,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    11 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Philip Warner als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    11 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    13 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    17 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SUTER ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Sekretär
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglish139555050001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Geschäftsführer
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Sekretär
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Sekretär
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Sekretär
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Sekretär
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    PATON WALSH, Antony Edmund
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    Sekretär
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    British43425770001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Sekretär
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Sekretär
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    69324550001
    ABELL, John David
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    United KingdomBritish71975220001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    EDWARDS, John Nigel
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    Geschäftsführer
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    United KingdomBritish37742270003
    EDWARDS, John Nigel
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    Geschäftsführer
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    British37742270001
    FERGUSON, Daniel
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish29071630001
    FIRTH, Arthur Gregory
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    British17118450001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Geschäftsführer
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    Geschäftsführer
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HEWITT, Alan
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    British572100002
    HOARE, Brian David
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    British28340230001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    REYNOLDS, Malcolm Stanley
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    British10865710001
    RIDER, Stuart Granville
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    British36675890002
    RILEY, Michael James
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    Geschäftsführer
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    British3055390001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Geschäftsführer
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Geschäftsführer
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Geschäftsführer
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    67372750003

    Hat SUTER ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 22. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mezzanine security agreement
    Erstellt am 22. Juli 2005
    Geliefert am 01. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all estates or interest in any f/h or l/h property now or subsequently owned by it, by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Warner Estate, Limited
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of debenture
    Erstellt am 16. Juli 2003
    Geliefert am 21. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property 2/22 yorkshire street, burnley t/n LA809118. F/h property the new inn roundabout, pontypool t/n WA583381, f/h property 15 fir tree road hastings t/n HT18815.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 19. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1998
    Geliefert am 07. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of admission
    Erstellt am 23. März 1995
    Geliefert am 10. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Omnibus debenture
    Erstellt am 25. Mai 1994
    Geliefert am 01. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 25. Feb. 1982
    Geliefert am 05. März 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floaitng charges over undertaking and all property including property listed in schedule attached to doc M139 and assets present and future inlcuding uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 1982Registrierung einer Belastung
    • 25. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 21. Mai 1981
    Geliefert am 28. Mai 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1981Registrierung einer Belastung
    Special omnibus letter of set off
    Erstellt am 30. Juni 1980
    Geliefert am 08. Juli 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum of sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1980Registrierung einer Belastung
    Special omnibus letter of set off
    Erstellt am 01. Jan. 1979
    Geliefert am 08. Jan. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1979Registrierung einer Belastung
    • 24. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SUTER ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2012Aufgelöst am
    28. Feb. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Praktiker
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0