FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00116776 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1st Floor 30 Cannon Street EC4M 6YN London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AMICUS HEALTHCARE LIMITED | 10. Juni 1996 | 10. Juni 1996 |
| COMPASS HEALTHCARE LIMITED | 18. Sept. 1987 | 18. Sept. 1987 |
| G M HEALTH CARE LIMITED | 19. Sept. 1983 | 19. Sept. 1983 |
| WEST SUSSEX CLINIC LIMITED | 06. Sept. 1982 | 06. Sept. 1982 |
| LEVY & FRANKS LIMITED | 12. Juli 1911 | 12. Juli 1911 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd zum 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN am 31. Mai 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. März 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Sekretär am 30. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Karen Anita Prins am 09. Nov. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Geschäftsführer am 30. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. März 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Karen Anita Prins am 14. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Dr Karen Anita Prins als Direktor am 01. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jill Margaret Watts als Geschäftsführer am 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Henry Jonathan Davies als Direktor am 01. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Ms Catherine Mary Jane Vickery als Direktor am 01. Mai 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Henry Jonathan | Geschäftsführer | 30 Cannon Street EC4M 6YN London 1st Floor England | England | British | 201206200001 | |||||
| PRINS, Karen Anita, Dr | Geschäftsführer | 30 Cannon Street EC4M 6YN London 1st Floor England | England | South African | 238969330004 | |||||
| COLLIER, Stephen John | Sekretär | 180 Kennington Park Road Kennington SE11 4BT London | British | 18350160001 | ||||||
| HAYES, Eugene Gerard | Sekretär | Flat 3 19 Maresfield Gardens NW3 5SN London | Irish | 2464310002 | ||||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Sekretär | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | British | 102009810002 | ||||||
| AULD, Charles Cairns | Geschäftsführer | 2 Cheyne Row SW3 5HL London | United Kingdom | British | 23257420003 | |||||
| CLAKE, Nigel Brian | Geschäftsführer | 11 Old Lands Hill Warfield RG12 2QX Bracknell Berkshire | British | 45810110001 | ||||||
| COLLIER, Stephen John | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | United Kingdom | British | 18350160001 | |||||
| FERBUYT, Michael Alois | Geschäftsführer | The Firs Hawkers Hill GL7 5NH Bibury Gloucestershire | British | 58371290001 | ||||||
| GREENWOOD, John Robert | Geschäftsführer | 84 Shortlands Road BR2 0JP Bromley Kent | British | 71403830001 | ||||||
| HARRIS, Nigel Robert | Geschäftsführer | 1 Sunnyside Villas Crookham Village GU13 0SJ Fleet Hampshire | British | 16250270001 | ||||||
| HAYES, Eugene Gerard | Geschäftsführer | 42 West Heath Drive NW11 7QH London | Irish | 2464310004 | ||||||
| KOYCHEV, Anne | Geschäftsführer | 62a Sidney Road TW1 1JR Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 87321370001 | |||||
| LOVELACE, Craig Barry | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | England | British | 160937260001 | |||||
| MACKAY, Francis Henry, Sir | Geschäftsführer | Rusthall House Langton Road, Langton Green TN3 0BB Tunbridge Wells Kent | England | British | 146047710001 | |||||
| MAIN, Iain James Robert | Geschäftsführer | Cherry Mount Whitchurch Hill RG8 7PA Pangbourne South Oxfordshire | British | 43800760002 | ||||||
| MATTHEWS, Roger John | Geschäftsführer | Ridgewood House Ridgemead Road, Englefield Green TW20 0YD Egham Surrey | United Kingdom | British | 133414230001 | |||||
| PRESTON, Paul Richard, Dr | Geschäftsführer | Foxholm 65 Lubbock Road BR7 5JG Chislehurst Kent | British | 51034310002 | ||||||
| ROBINSON, Gerard Jude | Geschäftsführer | 77 Addison Road Holland Park Kensington W14 8EB London | British | 2464330001 | ||||||
| SIMPSON DENT, Jonathan | Geschäftsführer | Carisbrook 19 Briar Walk Putney SW15 6UD London | United Kingdom | British | 110396210002 | |||||
| TAYLOR, John | Geschäftsführer | 50 St Georges Road BN11 2DR Worthing West Sussex | Englandengland | British | 16250280001 | |||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | United Kingdom | British | 102009810003 | |||||
| WATTS, Jill Margaret | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | England | British | 187252950001 | |||||
| WIELAND, Phil | Geschäftsführer | 4 Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford Middlesex | England | British | 119448000002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghg Intermediate Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental borrower deed of charge amending and supplementing a borrower deed of charge dated 31 july 2001, | Erstellt am 07. Okt. 2004 Geliefert am 21. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligors to the borrower security trustee (whether for its own account or as trustee for the borrower secured creditors) or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the north west side of calverton road arnold nottinghamshire t/no NT178548, f/h land on the north west side of calverton road arnold nottinghamshire t/no NT261554, f/h land lying to the north west of calverton road arnold nottinghamshire t/no NT178547. For details of further properties charged please refer to form 395. all shares stock debentures and other securities, all contractual rights, insurance and intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Borrower deed of charge (as defined) | Erstellt am 31. Juli 2001 Geliefert am 17. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities whatsoever due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors under or in respect of the issuer/borrowers facility agreement,the working capital facility agreement,the tax deed of covenant,the borrower bank account agreement,the borrower deed of charge or any other transaction document to which any obligor is a party and all other obligations and liabilities under the issuer/borrowers facility agreement,the working capital facility agreemen,the tax deed of covenant,the borrower bank account agreement,the borrower deed of charge and/or any other transaction document | |
Kurze Angaben (I) f/hold land/blds on south side of mill lane and the west side of manchester rd,cheadle; gm 457473; (ii) f/hold land and buildings on south west side of manchester rd,cheadle; gm 31452; (iii) f/hold and at the back of the alexandra hospital,mill lane,cheadle; t/no gm 808975 plus various other properties listed; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 01. Sept. 2000 Geliefert am 14. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the obligors (as defined) to the chargee under each transaction document (as defined) | |
Kurze Angaben All group shares and all related rights accruing to the group shares.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 1997 Geliefert am 09. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or owing by the obligors (as therein defined) to the chargee as security agent (as therein defined) under the finance documents (as defined) or any of them whether present or future actual or contingent | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Dez. 1995 Geliefert am 27. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or each obligor and/or chargor to the chargee under each or any of the senior finance documents,the vendor documents or any other documents as defined in the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Okt. 1991 Geliefert am 21. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to 3I PLC and the lenders under all or any of the loan agreement, this security and any after document entered into pursuant to the terms of the loan agreement. | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 24. Feb. 1989 Geliefert am 15. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each of the facility letter, as defined in and under the guarantee & debenture. | |
Kurze Angaben (See doc M395- reference m 601C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 24. Feb. 1989 Geliefert am 15. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for itself and the londers as defined in and under the terms of the this guarantee & debenture | |
Kurze Angaben The company as beneficial owner charges by way of first legal mortgage all estates & interests in the f/h property k/a the sakon chnie, saxon street, eaglestone milton keynes bucks, comprised in a conveyance dated 12.9.86. various properties listed on 395 (see doc for full details) & proceeds of sale (see doc M367 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Juli 1987 Geliefert am 13. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become deu from chrefrule "the borrower" and/or the company and/or the charging companies (including each or any one or more of them severally) to international westminster bank PLC as agent and trustees for itself & the banks (asdefined) unde or in respect of "the secured obligations" as defined in claude 2 of the deed) | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a the west sussex clinic, saxon street eaglestone, milton reynes, buckingham (please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Juli 1987 Geliefert am 18. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or the charging companies to national westminster bank PLC under the terms of a facility lettr d/d 24.7.87 & a loan agreement d/d 24.7.87. | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a the west sussex clinic, saxon street eaglestare, rulran reynes buckingham. (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture. | Erstellt am 31. Juli 1987 Geliefert am 05. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from chietrule limited to the chargee and other lenders under end of the financing documents. | |
Kurze Angaben (See form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0