FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED

FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00116776
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1st Floor 30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AMICUS HEALTHCARE LIMITED10. Juni 199610. Juni 1996
    COMPASS HEALTHCARE LIMITED18. Sept. 198718. Sept. 1987
    G M HEALTH CARE LIMITED19. Sept. 198319. Sept. 1983
    WEST SUSSEX CLINIC LIMITED06. Sept. 198206. Sept. 1982
    LEVY & FRANKS LIMITED12. Juli 191112. Juli 1911

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd zum 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN am 31. Mai 2019

    1 SeitenAD01

    Kapitalaufstellung am 28. März 2019

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduction of share premium account 28/03/2019
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Sekretär am 30. Nov. 2018

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Direktors für Dr Karen Anita Prins am 09. Nov. 2018

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Geschäftsführer am 30. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. März 2018

    1 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Dr Karen Anita Prins am 14. März 2018

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Dr Karen Anita Prins als Direktor am 01. Okt. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jill Margaret Watts als Geschäftsführer am 30. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    4 SeitenAA

    Ernennung von Henry Jonathan Davies als Direktor am 01. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 2,679,166.75
    • Kapital: USD 1
    SH01

    Ernennung von Ms Catherine Mary Jane Vickery als Direktor am 01. Mai 2015

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, Henry Jonathan
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Geschäftsführer
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish201206200001
    PRINS, Karen Anita, Dr
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Geschäftsführer
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandSouth African238969330004
    COLLIER, Stephen John
    180 Kennington Park Road
    Kennington
    SE11 4BT London
    Sekretär
    180 Kennington Park Road
    Kennington
    SE11 4BT London
    British18350160001
    HAYES, Eugene Gerard
    Flat 3
    19 Maresfield Gardens
    NW3 5SN London
    Sekretär
    Flat 3
    19 Maresfield Gardens
    NW3 5SN London
    Irish2464310002
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Sekretär
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    British102009810002
    AULD, Charles Cairns
    2 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    Geschäftsführer
    2 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    United KingdomBritish23257420003
    CLAKE, Nigel Brian
    11 Old Lands Hill
    Warfield
    RG12 2QX Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    11 Old Lands Hill
    Warfield
    RG12 2QX Bracknell
    Berkshire
    British45810110001
    COLLIER, Stephen John
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    United KingdomBritish18350160001
    FERBUYT, Michael Alois
    The Firs Hawkers Hill
    GL7 5NH Bibury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Firs Hawkers Hill
    GL7 5NH Bibury
    Gloucestershire
    British58371290001
    GREENWOOD, John Robert
    84 Shortlands Road
    BR2 0JP Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    84 Shortlands Road
    BR2 0JP Bromley
    Kent
    British71403830001
    HARRIS, Nigel Robert
    1 Sunnyside Villas
    Crookham Village
    GU13 0SJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    1 Sunnyside Villas
    Crookham Village
    GU13 0SJ Fleet
    Hampshire
    British16250270001
    HAYES, Eugene Gerard
    42 West Heath Drive
    NW11 7QH London
    Geschäftsführer
    42 West Heath Drive
    NW11 7QH London
    Irish2464310004
    KOYCHEV, Anne
    62a Sidney Road
    TW1 1JR Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    62a Sidney Road
    TW1 1JR Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish87321370001
    LOVELACE, Craig Barry
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    EnglandBritish160937260001
    MACKAY, Francis Henry, Sir
    Rusthall House
    Langton Road, Langton Green
    TN3 0BB Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Rusthall House
    Langton Road, Langton Green
    TN3 0BB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish146047710001
    MAIN, Iain James Robert
    Cherry Mount
    Whitchurch Hill
    RG8 7PA Pangbourne
    South Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Cherry Mount
    Whitchurch Hill
    RG8 7PA Pangbourne
    South Oxfordshire
    British43800760002
    MATTHEWS, Roger John
    Ridgewood House
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Ridgewood House
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    United KingdomBritish133414230001
    PRESTON, Paul Richard, Dr
    Foxholm
    65 Lubbock Road
    BR7 5JG Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Foxholm
    65 Lubbock Road
    BR7 5JG Chislehurst
    Kent
    British51034310002
    ROBINSON, Gerard Jude
    77 Addison Road
    Holland Park Kensington
    W14 8EB London
    Geschäftsführer
    77 Addison Road
    Holland Park Kensington
    W14 8EB London
    British2464330001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    Geschäftsführer
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    United KingdomBritish110396210002
    TAYLOR, John
    50 St Georges Road
    BN11 2DR Worthing
    West Sussex
    Geschäftsführer
    50 St Georges Road
    BN11 2DR Worthing
    West Sussex
    EnglandenglandBritish16250280001
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United KingdomBritish102009810003
    WATTS, Jill Margaret
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    EnglandBritish187252950001
    WIELAND, Phil
    4 Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    Middlesex
    EnglandBritish119448000002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ghg Intermediate Holdings Limited
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer04210585
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat FORMER AMICUS HEALTHCARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental borrower deed of charge amending and supplementing a borrower deed of charge dated 31 july 2001,
    Erstellt am 07. Okt. 2004
    Geliefert am 21. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligors to the borrower security trustee (whether for its own account or as trustee for the borrower secured creditors) or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the north west side of calverton road arnold nottinghamshire t/no NT178548, f/h land on the north west side of calverton road arnold nottinghamshire t/no NT261554, f/h land lying to the north west of calverton road arnold nottinghamshire t/no NT178547. For details of further properties charged please refer to form 395. all shares stock debentures and other securities, all contractual rights, insurance and intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Borrower deed of charge (as defined)
    Erstellt am 31. Juli 2001
    Geliefert am 17. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities whatsoever due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors under or in respect of the issuer/borrowers facility agreement,the working capital facility agreement,the tax deed of covenant,the borrower bank account agreement,the borrower deed of charge or any other transaction document to which any obligor is a party and all other obligations and liabilities under the issuer/borrowers facility agreement,the working capital facility agreemen,the tax deed of covenant,the borrower bank account agreement,the borrower deed of charge and/or any other transaction document
    Kurze Angaben
    (I) f/hold land/blds on south side of mill lane and the west side of manchester rd,cheadle; gm 457473; (ii) f/hold land and buildings on south west side of manchester rd,cheadle; gm 31452; (iii) f/hold and at the back of the alexandra hospital,mill lane,cheadle; t/no gm 808975 plus various other properties listed; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security agreement
    Erstellt am 01. Sept. 2000
    Geliefert am 14. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the obligors (as defined) to the chargee under each transaction document (as defined)
    Kurze Angaben
    All group shares and all related rights accruing to the group shares.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited as Agent and Trustee for the Transaction Parties
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 1997
    Geliefert am 09. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or owing by the obligors (as therein defined) to the chargee as security agent (as therein defined) under the finance documents (as defined) or any of them whether present or future actual or contingent
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Dez. 1995
    Geliefert am 27. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or each obligor and/or chargor to the chargee under each or any of the senior finance documents,the vendor documents or any other documents as defined in the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited(The "Security Agent") as Agent and Trustee Foritself and Each of the Lenders and the Vendor (as Defined)
    Transaktionen
    • 27. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Okt. 1991
    Geliefert am 21. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to 3I PLC and the lenders under all or any of the loan agreement, this security and any after document entered into pursuant to the terms of the loan agreement.
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Plcas Agent and Trustee for the Lenders (As Defined in the Mezzanine Loan Agreement Dated 5/6/87 the "Loan Agreement")
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 31. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 24. Feb. 1989
    Geliefert am 15. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each of the facility letter, as defined in and under the guarantee & debenture.
    Kurze Angaben
    (See doc M395- reference m 601C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 24. Feb. 1989
    Geliefert am 15. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for itself and the londers as defined in and under the terms of the this guarantee & debenture
    Kurze Angaben
    The company as beneficial owner charges by way of first legal mortgage all estates & interests in the f/h property k/a the sakon chnie, saxon street, eaglestone milton keynes bucks, comprised in a conveyance dated 12.9.86. various properties listed on 395 (see doc for full details) & proceeds of sale (see doc M367 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Transaktionen
    • 15. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. Juli 1987
    Geliefert am 13. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become deu from chrefrule "the borrower" and/or the company and/or the charging companies (including each or any one or more of them severally) to international westminster bank PLC as agent and trustees for itself & the banks (asdefined) unde or in respect of "the secured obligations" as defined in claude 2 of the deed)
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a the west sussex clinic, saxon street eaglestone, milton reynes, buckingham (please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • International Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. Juli 1987
    Geliefert am 18. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or the charging companies to national westminster bank PLC under the terms of a facility lettr d/d 24.7.87 & a loan agreement d/d 24.7.87.
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a the west sussex clinic, saxon street eaglestare, rulran reynes buckingham. (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture.
    Erstellt am 31. Juli 1987
    Geliefert am 05. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from chietrule limited to the chargee and other lenders under end of the financing documents.
    Kurze Angaben
    (See form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 05. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    • 31. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0