LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00119285 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED?
- Zeitungsverlag (58130) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unex House - Suite B Bourges Boulevard PE1 1NG Peterborough Cambridgeshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John King am 01. Juli 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ashley Gilroy Mark Highfield am 01. Juli 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Mccall am 01. Juli 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Oundle Road Woodston Peterborough PE2 9QR zum Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG am 24. Juli 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Dez. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David John King als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Grant Murray als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ashley Gilroy Mark Highfield als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Cammiade als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Fry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Media House Peterborough Webb Estate Oundle Road Peterborough PE2 9QR* am 10. Okt. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Jan. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Grant Murray als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Daniel Cammiade als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCALL, Peter | Sekretär | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 147013750001 | |||||||
HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Geschäftsführer | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 164400440001 | ||||
KING, David John | Geschäftsführer | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 179020430001 | ||||
BELL, Anita Marie | Sekretär | Kelso House Staple Road Wingham CT3 1AL Canterbury Kent | British | 50687450002 | ||||||
CHEVIN-HALL, Nigel Clive | Sekretär | Longridge House Church Lane Church Brampton NN6 8AT Northampton Northamptonshire | British | 60595360001 | ||||||
CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio | Sekretär | 21 Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh | British | Newspaper Director | 474360001 | |||||
COMYN, Paul Fergus | Sekretär | 23 St James Avenue TW12 1HH Hampton Hill Middlesex | Irish | Accountant | 3889300001 | |||||
COOPER, Philip Richard | Sekretär | Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow 14 West Lothian United Kingdom | British | 131295290001 | ||||||
BOWDLER, Timothy John | Geschäftsführer | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | Newspaper Director | 37521870002 | ||||
BROADLEY, Robert | Geschäftsführer | Abbeydale 48 Chiselhurst Road BR7 5LD Chiselhurst Kent | British | Finance Director | 13726050001 | |||||
CAMMIADE, Danny | Geschäftsführer | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | Chief Operating Officer | 251394160001 | ||||
CHEVIN-HALL, Nigel Clive | Geschäftsführer | Longridge House Church Lane Church Brampton NN6 8AT Northampton Northamptonshire | England | British | Finance Director | 60595360001 | ||||
CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio | Geschäftsführer | 21 Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh | Scotland | British | Newspaper Director | 474360001 | ||||
CLARK, Gareth Peter Andrew | Geschäftsführer | Burdenshot House Burdenshott Hill, Worplesdon GU3 3RL Guildford Surrey | British | Accountant | 69163560001 | |||||
COMYN, Paul Fergus | Geschäftsführer | 23 St James Avenue TW12 1HH Hampton Hill Middlesex | Irish | Accountant | 3889300001 | |||||
DEVOTO, David Moore | Geschäftsführer | 15 Narvik Close CM9 6UX Maldon Essex | United Kingdom | British | Company Director | 18165180001 | ||||
FORDHAM, David Sidney | Geschäftsführer | Copper Beeches Leckhampstead Road MK18 5HG Akeley Buckingham | United Kingdom | British,German | Company Director | 84247970002 | ||||
FRY, John Anthony | Geschäftsführer | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | Chief Executive | 136914890001 | ||||
HOLDEN, Barrie Leslie | Geschäftsführer | Brick Hill Farm Brickhill Lane Newborough DE13 8SW Burton On Trent Staffordshire | British | Publisher | 54528020004 | |||||
KHANGURA, Gurmeet Singh | Geschäftsführer | 1 Haverley 85 Worple Road SW19 4JH London | British | Director | 82822740002 | |||||
LAMBERT, Harry Paul | Geschäftsführer | Le Park Palace E534 Impasse De La Fontaine Mc98000 Monaco | British | Company Director | 2359770006 | |||||
LUSBY, Martin Alan | Geschäftsführer | Broad Meadows Barford Hill, Barford CV35 8BZ Warwick Warwickshire | England | British | Publisher | 64847950001 | ||||
MCNAB, Iain Barry | Geschäftsführer | Satis, 6 The Pines Boston Road NG34 7DN Sleaford Lincolnshire | British | Publishing Director | 46894910005 | |||||
MURRAY, Grant | Geschäftsführer | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 159877110001 | ||||
PATERSON, Stuart Randall | Geschäftsführer | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Company Director | 64281400001 | ||||
REVELL, Norman Armstrong | Geschäftsführer | Colcombe Main Road Leverton PE22 0BB Boston Lincolnshire | British | Non Execut Director | 31179020001 | |||||
VINCENT, Brenda Joyce Ruth | Geschäftsführer | Sunburst First Avenue Kingsgate CT10 3LP Broadstairs Kent | British | Administration Director | 2366420001 |
Hat LINCOLNSHIRE STANDARD GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed to a debenture | Erstellt am 11. Okt. 1999 Geliefert am 26. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them and/or the security agent under or pursuant to any finance document (including the debenture) | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a the newspaper centre restone industrial estate boston t/n-LL71938. F/h land and buildings k/a 5 and 7 market place gainsborough lincolnshire t/n-LL114833. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 31. Okt. 1994 Geliefert am 04. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property known as newspaper house redstone road boston lincolnshire t/n LL71938. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Aug. 1991 Geliefert am 19. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/a plots 12 to 16 (incl). Redstone industrial estate, boston, lincs. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Sept. 1988 Geliefert am 22. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Sept. 1987 Geliefert am 24. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 58-60 lumley rd, skegness, lincs goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 20. Juli 1987 Geliefert am 10. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 27 southgate sleaford lincs togther with all buildings fixtures & fittings & goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 18. Sept. 1986 Geliefert am 27. Sept. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold, 17 king street, winterton, humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1986 Geliefert am 12. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property, 109 lea road, gainborough lincolnshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1986 Geliefert am 24. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 8 wrawby street brigg humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1986 Geliefert am 24. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 90 trinity street gainsborough lincs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1986 Geliefert am 24. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 53/55 carolgate retford notts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1986 Geliefert am 24. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 88 high street crowle lincs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1986 Geliefert am 24. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 168 trinity street gainsborough lincs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Juni 1986 Geliefert am 03. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property 3 corn-market louth lincs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Juli 1985 Geliefert am 09. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H shop & kiosk situate nr sincil st, lincoln title no:ll 15246. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Okt. 1982 Geliefert am 26. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H shop 109 lea road, gainsborough lincolnshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Okt. 1982 Geliefert am 26. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H shop 10 wide bargate boston lincolnshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Okt. 1982 Geliefert am 26. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H shop 88 high street crowle, humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Okt. 1982 Geliefert am 26. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H slop 22/22 spital terrace gainsborough lincolndhire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Okt. 1982 Geliefert am 15. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H morris house, st. Mary's street lincoln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. Mai 1975 Erworben am 27. Juni 1980 Geliefert am 06. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £169,000 | |
Kurze Angaben 117/121 portland street lincoln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Apr. 1973 Erworben am 27. Juni 1980 Geliefert am 06. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £169,000 | |
Kurze Angaben 124 trinity street gainsborough lincolnshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0