LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED

LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00129865
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED?

    • (5530) /

    Wo befindet sich LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Rifsons House
    63-64 Charles Lane
    NW8 7SB St Johns Wood
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    E.J.ROSE & COMPANY,LIMITED01. Juli 191301. Juli 1913

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2000

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Verschiedenes

    Statement of affairs
    6 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    4 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2000

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    6 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return20. März 2001

    legacy

    363(288)
    annual-return20. März 2001

    legacy

    363(287)

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 1999

    13 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 1998

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    6 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SINGH, Sarvindra
    5 Somerset Gardens
    Highgate Gardens
    N6 5EQ London
    Sekretär
    5 Somerset Gardens
    Highgate Gardens
    N6 5EQ London
    British43283210001
    SINGH, Sarvindra
    36 Upper Brook Street
    W1K 7QJ London
    Geschäftsführer
    36 Upper Brook Street
    W1K 7QJ London
    British43283210002
    SNOWVILLE UK LIMITED
    36 Upper Brook Street
    W1K 7QJ London
    Geschäftsführer
    36 Upper Brook Street
    W1K 7QJ London
    61252940002
    ENGLAND, Shane Vincent
    62 Pondtail Road
    GU51 3JF Fleet
    Hampshire
    Sekretär
    62 Pondtail Road
    GU51 3JF Fleet
    Hampshire
    English46763300001
    REECE, Dennis Paul
    New Brake House 70 Cow Lane
    Bramcote
    NG9 3BB Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    New Brake House 70 Cow Lane
    Bramcote
    NG9 3BB Nottingham
    Nottinghamshire
    British694470001
    C I LAW SERVICES LIMITED
    PO BOX 302 Westway Chambers
    39 Don Street St Helier
    JE4 8UA Jersey
    Sekretär
    PO BOX 302 Westway Chambers
    39 Don Street St Helier
    JE4 8UA Jersey
    61252740001
    ACKERMAN, Royston Kenneth, Dr
    35 Tadema Road
    SW10 0PZ London
    Geschäftsführer
    35 Tadema Road
    SW10 0PZ London
    EnglandBritish46368750001
    ATKINSON, Richard Westaway
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish111861370001
    BADDELEY, Robert Gregory
    52 Eyebrook Road
    Bowdon
    WA14 3LP Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    52 Eyebrook Road
    Bowdon
    WA14 3LP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish28024220002
    BATT, Alan Richard Crompton
    9 Queen Alexandra
    Mansions Grape Street
    WC2 London
    Geschäftsführer
    9 Queen Alexandra
    Mansions Grape Street
    WC2 London
    British26732150001
    CARMICHAEL, Robert Neil Bruce
    82 Stanhope Mews East
    SW7 5QT London
    Geschäftsführer
    82 Stanhope Mews East
    SW7 5QT London
    United KingdomBritish65088590001
    GLOVER, John Thomas Haig
    Dumble Lodge 127 Lambley Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BN Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Dumble Lodge 127 Lambley Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BN Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish1366430001
    LANDAU, David Aaron
    38 North Audley Street
    Mayfair
    W1K 6ZN London
    Geschäftsführer
    38 North Audley Street
    Mayfair
    W1K 6ZN London
    United KingdomBritish10648180003
    REECE, Dennis Paul
    New Brake House 70 Cow Lane
    Bramcote
    NG9 3BB Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Brake House 70 Cow Lane
    Bramcote
    NG9 3BB Nottingham
    Nottinghamshire
    British694470001

    Hat LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 19. Sept. 2000
    Geliefert am 26. Sept. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2002Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 1
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Mai 1992
    Geliefert am 19. Mai 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M579C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Apr. 1992
    Geliefert am 27. Apr. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Parts of the sub basement, basement, ground first & second floors of 4 and 5 castle court & 38 1/2 cornhill l/b of city of london t/no ngl 358259.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Dez. 1986
    Geliefert am 04. Dez. 1986
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £100,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee including moneys due for goods sold and delivered under the terms of a facility letter dated 1/10/86
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the three crowns public house fore st edmonton l/b of enfield tog with all fixtures & fittings whatsoever & tog with the goodwill of the business.
    Berechtigte Personen
    • Charrington & Company Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge
    Erstellt am 19. März 1986
    Geliefert am 20. März 1986
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £10,666.67 and any other monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the lamb public house, 512 kingsland road, london borough of hackney title no: 219159.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transaktionen
    • 20. März 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 08. Jan. 1986
    Geliefert am 09. Jan. 1986
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £30,000 and any other moneys that may become owing by the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the three crowns public house fore street edmonton l/b of enfield tog with fixtures & fittings whether tenants or otherwise tog with goodwill of the business.
    Berechtigte Personen
    • Charrington and Company Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 1985
    Geliefert am 18. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £30,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee including moneys due for goods sold & delivered under the terms of a facility letter dated 18.10.84
    Kurze Angaben
    F/H properties k/a clive stores 70 clive road SE21 and camden stores 69 camden road camden london & goodwill.
    Berechtigte Personen
    • Charrington and Company Limited
    Transaktionen
    • 18. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 21. Jan. 1983
    Geliefert am 22. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £10,000 and any other monies due or to become due from the company to the chargee on any account current or stated for goods supplied or otherwise
    Kurze Angaben
    F/H 40 anerley upper norwood l/b of bromley title no sgl 25138 tog with furnishings trade fixtures & fittings & stock goodwill & benefit of all licences held.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1981
    Geliefert am 16. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The bedford stores, 82 whellock rd acton W4 title no:- ngl 31673. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1981
    Geliefert am 16. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The garing stores, goring road, london borough of ealing title no mx 441785. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1982Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 13. Sept. 1979
    Geliefert am 02. Okt. 1979
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £15,000
    Kurze Angaben
    L/H premises forming part of 4/5 castle court & 38 1/2 cornhill in the city of london known as "simpsons".
    Berechtigte Personen
    • Union Discount Company of London LTD
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1979Registrierung einer Belastung
    Agreement to create a mortgage
    Erstellt am 07. Feb. 1978
    Geliefert am 24. Feb. 1978
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £15,000
    Kurze Angaben
    L/Hold premises forming part of 4/5 castle court and 38 1/2 cornhill, city of london charge over agreement relating to above property.
    Berechtigte Personen
    • Union Discount Company of London Limited
    Transaktionen
    • 24. Feb. 1978Registrierung einer Belastung
    Charge of whole
    Erstellt am 14. Apr. 1964
    Geliefert am 29. Apr. 1964
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold public house and yard known as the guy earl of warwick, 5 chrisp street, poplar, london.
    Berechtigte Personen
    • Westminster Bank Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1964Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 29. Juli 1963
    Geliefert am 07. Aug. 1963
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,000 and any other sums which may be advanced to the company by the chargee
    Kurze Angaben
    "The bell" 617 forest road, walthamstow, essex the goodwill of the business thereon and the benefit of all licences (see doc 126 for details).
    Berechtigte Personen
    • Mann Crossman & Paulin Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1963Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 25. Mai 1962
    Geliefert am 05. Juni 1962
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    "The beaconsfield hotel" 24, blyth road, west kensington, london.
    Berechtigte Personen
    • Westminster Bank Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 1962Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 21. Apr. 1959
    Geliefert am 24. Apr. 1959
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £3,073 and any other money which may become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    'The bell' 617 forest road, walthamstow and adjoining off-licence shop the goodwill of the business and benefit of all licences (see doc 111 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Mann Crossman & Paulin Limited
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1959Registrierung einer Belastung
    Charge of whole
    Erstellt am 10. März 1959
    Geliefert am 10. März 1959
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £18,000
    Kurze Angaben
    The prince albert 49 hare street, woolwich land and buildings in dog yark at the back of the prince albert land and buildings at the rear of 120 woolwich high street, woolwich, the coopers arms, high street, woolwich.
    Berechtigte Personen
    • Reginald Hugo Cave and Constance Margaret Rich
    Transaktionen
    • 10. März 1959Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 16. Apr. 1951
    Geliefert am 01. Mai 1951
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bedford house, quaker street, shoreditch E1 title no ln 56850.
    Berechtigte Personen
    • Westminster Bank Limited
    Transaktionen
    • 01. Mai 1951Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juli 1931
    Geliefert am 20. Juli 1931
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £2,200 and any further moneys not exceeding therewith £3,200
    Kurze Angaben
    L/Hold public house known as the "the apollo" 18 all saints road, kensington all trade and other fixtures and fittings the goodwill of the business and benefit of all future or present licences (see doc 47).
    Berechtigte Personen
    • Whitbread & Company Limited
    Transaktionen
    • 20. Juli 1931Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 19. Feb. 1925
    Geliefert am 23. Feb. 1925
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £2,500 and further advances
    Kurze Angaben
    L/Hold public house known as the dun cow, 279 old kent road, london.
    Berechtigte Personen
    • Truman, Hanbury Buxton & Company Limited
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1925Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 26. Juni 1924
    Geliefert am 02. Juli 1924
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £675 and further advances
    Kurze Angaben
    Land and premises known as the harpers arms public house, 112 theobalds road, in the parish of st george the martyr, holborn middlesex with the appurtenances erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Wenlock Brewery Company Limited
    Transaktionen
    • 02. Juli 1924Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 28. Jan. 1919
    Geliefert am 04. Feb. 1919
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,500 and further advances
    Kurze Angaben
    Public house known as the 'the rochester castle' high street, stoke newington, middlesex.
    Berechtigte Personen
    • The Wenlock Brewery Co Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1919Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 28. Jan. 1919
    Geliefert am 04. Feb. 1919
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,500 and further advances
    Kurze Angaben
    Public house, known as the 'roman arms' roman road, old ford, middlesex.
    Berechtigte Personen
    • The Wenlock Brewery Co Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1919Registrierung einer Belastung

    Hat LUCANIA SNOOKER CLUBS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Sept. 2000Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Arif Anwar
    Rifsons
    Rifsons House
    NW8 7SB 63-64 Charles Lane
    St John'S Wood London
    Praktiker
    Rifsons
    Rifsons House
    NW8 7SB 63-64 Charles Lane
    St John'S Wood London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0