ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)
Überblick
Unternehmensname | ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE) |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 00134025 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)?
- Tätigkeit von Sportvereinen (93120) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Nov. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Aug. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 16. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 30. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 16. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mr John Hunter als Direktor am 01. Nov. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Hodson als Geschäftsführer am 01. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sam Grcar als Geschäftsführer am 01. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Cooney als Geschäftsführer am 30. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Kimberley Hearn als Direktor am 30. Juli 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2023 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sam Grcar als Direktor am 22. Apr. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Roger William Maycock als Direktor am 04. Apr. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bryan Knowles als Geschäftsführer am 01. Jan. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 9 Seiten | MA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Nash als Geschäftsführer am 01. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2022 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Ellen Jayne Boyd als Sekretär am 16. März 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Hodson als Direktor am 16. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Deborah Nash als Direktor am 13. Juni 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Hodson als Geschäftsführer am 15. Mai 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Gerrard Ormerod als Geschäftsführer am 11. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher John Nicholls als Geschäftsführer am 11. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Cooney als Direktor am 24. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2021 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gerard Stephen Taylor als Geschäftsführer am 25. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYD, Ellen Jayne | Sekretär | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | 306967230001 | |||||||
BROWN, Barry Peter | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Consultant | 104155490001 | ||||
HEARN, Kimberley | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Director Of House | 325638130001 | ||||
HUNTER, John | Geschäftsführer | Caldy Drive Holcombe Brook BL0 9TU Bury 15 England | England | British | Retired | 329058570001 | ||||
KERFOOT, Colin | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | United Kingdom | British | Director | 27937300001 | ||||
MAYCOCK, Roger William | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Director Of Membership | 206118950001 | ||||
READETT, Neil Clive | Sekretär | 85 Columbia Way Lammack BB2 7DT Blackburn Lancashire | British | 38786240001 | ||||||
ROGERS, Frank Clifton | Sekretär | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | 173461710001 | |||||||
SWAIN, Joseph Roy | Sekretär | 48 Hurst Lane BB4 7RE Rawtenstall Lancashire | British | Retired | 82027030001 | |||||
SWAIN, Joseph Roy | Sekretär | 48 Hurst Lane BB4 7RE Rawtenstall Lancashire | British | Retired | 82027030001 | |||||
TOWNSEND, Arthur Vincent | Sekretär | Dowry House Brandlesholme Road Greenmount BL8 4DZ Bury Lancashire | British | 16935670001 | ||||||
WHITTAKER, Wilman Parker | Sekretär | 19 Heightside Avenue Newchurch BB4 9HA Rossendale Lancashire | British | 8066600001 | ||||||
WILSON, Kenneth | Sekretär | 43 Sandown Road Haslingden BB4 6PL Rossendale Lancashire | British | Retired | 60031750001 | |||||
ANDERTON, Alan | Geschäftsführer | 39 Brooklands Avenue Helmshore BB4 4EU Rossendale Lancashire | British | Engineer | 8066610001 | |||||
ASHTON, Barrie | Geschäftsführer | 56-58 Bridge Street Ramsbottom BL0 9AQ Bury Lancashire | British | Technical Director | 19718380001 | |||||
ASHWORTH, Alan Geoffrey, Mr. | Geschäftsführer | Alderwood Grove Ramsbottom BL0 0HQ Bury 5 Lancashire England | England | British | Retired | 1449180001 | ||||
ASKEW, Barbara Joan | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Retired | 186507980001 | ||||
BANN, Michael | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Retired | 186505440001 | ||||
BANN, Susan | Geschäftsführer | Booth Road Waterfoot BB4 9BP Rossendale 79 Lancashire England | England | British | Dental Nurse | 158542000001 | ||||
BETTS, Michael John Arthur | Geschäftsführer | 2 Alpine Close Hoddlesden BB3 3LH Darwen Lancashire | British | Director | 3442730001 | |||||
BIRTWISTLE, Michael William Holden | Geschäftsführer | 23 Ascot Way BB5 2AH Accrington Lancashire | England | British | Retired | 120644430001 | ||||
BLAND, Brian | Geschäftsführer | 64 Hunstanton Drive BL8 1EG Bury Lancashire | British | Chartered Accountant | 34618790001 | |||||
BLUD, Terence | Geschäftsführer | 32 Oaklands Drive Rawtenstall BB4 6SA Rossendale Lancashire | British | Engineer | 8066620001 | |||||
BROWN, Barry Peter | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Consultant | 104155490001 | ||||
BROWN, George Ross | Geschäftsführer | 56 Woodhey Road Holcombe Brook BL0 9RB Bury Lancashire | British | Retired | 82484390001 | |||||
BUCKLEY, Garry | Geschäftsführer | Ewood Lane Haslingden BB4 6LH Rossendale Rossendale Golf Club England | United Kingdom | British | Company Director | 21063440001 | ||||
BUCKLEY, Garry | Geschäftsführer | Rossmere Avenue OL11 4BT Rochdale 3 Lancashire England | United Kingdom | British | Company Director | 21063440001 | ||||
BURKE, James | Geschäftsführer | Punch Bowl Longridge Rd BB7 9QW Clitheroe Lancashire | British | Engineer | 122390080001 | |||||
CAIRNS, Yvette | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | Great Britain | British | Lecturer | 150276390001 | ||||
CASSELL, James Robert | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Telecoms Manager | 256776510001 | ||||
CHAPMAN, David | Geschäftsführer | Ewood Lane Head Haslingden BB4 6LH Rossendale Lancs | England | British | Company Director | 196247950001 | ||||
CHILTON, John Colin | Geschäftsführer | 12 Broad Oak Road Bamford OL11 5JB Rochdale Lancashire | British | Writer | 41819080001 | |||||
CLAXTON, Kenneth Edward | Geschäftsführer | 120 Laneside Road Haslingden BB4 6PG Rossendale Lancashire | British | Retired | 105066210001 | |||||
CLAYTON, Philip Edward | Geschäftsführer | 1 Kendal Road Holcombe Brook BL0 9SP Bury Lancashire | British | Retired | 30042560002 | |||||
COAR, Arthur | Geschäftsführer | 5 Linley Grove Ramsbottom BL0 9TS Bury Lancashire | British | Retired Teacher | 8066630001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE)?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
16. Apr. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat ROSSENDALE GOLF CLUB LIMITED(THE) Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 12. Nov. 2012 Geliefert am 21. Nov. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 12. März 2009 Geliefert am 18. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a rossendale golf club, ewood lane head, haslingden, rossendale, lancs t/no LA859922 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Aug. 2001 Geliefert am 29. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Rossendale golf club, ewood lane head, haslingden, lancashire t/n LA859922. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Mai 2001 Geliefert am 01. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Dez. 1999 Geliefert am 07. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £556,400 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 1999 Geliefert am 07. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £556,400 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land and buildings comprising rossendale golf club limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Nov. 1989 Geliefert am 28. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H rossendove golf club ewood lane head farm ewood bridge nr haslingden rossendale lancs all the plant machinery fittings funiture equipment implementsand utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Aug. 1985 Geliefert am 14. Aug. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £25,000 and all other monies due or to become due from the company to thechargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The golf club & course at ewood lane, head helmshere rossendale, lancashire, land adjoining the grounds of helmshere house and farm land formerly k/a higher cockham farm helmshere (see doc M83 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further charge | Erstellt am 04. Juli 1983 Geliefert am 05. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,000 and all other monies due under the terms of the charge including moneys due for goods supplied. | |
Kurze Angaben Gold course and clubhouse at helmshore and haslinglen, lancaster as comprised in the principal deed dated 19.7.77. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further charge | Erstellt am 11. Feb. 1982 Geliefert am 13. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee including monies due for goods supplied | |
Kurze Angaben Golf course and clubhouse at rossendale in the county of lancaster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0