BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00134029 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED?
- (7012) /
Wo befindet sich BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Smith And Williamson Limited 25 Moorgate EC2R 6AY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| W.DARLINGTON & SONS LIMITED | 17. Feb. 1914 | 17. Feb. 1914 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 24. Apr. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Dez. 2011 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Sept. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. März 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 16 Decoy Road, Timberlaine Trading Estate, Worthing, West Sussex, BN14 8nd am 17. Mai 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 24. Apr. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Keith Dawes am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für William Edwin Musson am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Anthony Petts am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Robert Stewart am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael John Hayward am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Benet Otim Jacobs am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Terence Royston Crosswell am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Adrian Keith Dawes am 08. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Richard Woad am 08. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 25. Apr. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 27. Apr. 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWES, Adrian Keith | Sekretär | 28 Aldsworth Avenue Goring By Sea BN12 4XQ Worthing West Sussex | British | 47566670001 | ||||||
| CROSSWELL, Terence Royston | Geschäftsführer | 16 Trenches Road TN6 1ES Crowborough | United Kingdom | British | 47566760007 | |||||
| DAWES, Adrian Keith | Geschäftsführer | 28 Aldsworth Avenue Goring By Sea BN12 4XQ Worthing West Sussex | United Kingdom | British | 47566670001 | |||||
| HAYWARD, Michael John | Geschäftsführer | Gregory House Elms Road RG27 9JU Hook 17 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 47845000002 | |||||
| JACOBS, Jeremy Benet Otim | Geschäftsführer | Russets Spring Hill, Little Staughton MK44 2BS Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | 47844380003 | |||||
| MUSSON, William Edwin | Geschäftsführer | 37 Whitestone Drive Huntington YO31 9HY York | United Kingdom | British | 47844990005 | |||||
| PETTS, David Anthony | Geschäftsführer | 81 Singleton Crescent Goring By Sea BN12 5DQ Worthing West Sussex | United Kingdom | British | 47566560001 | |||||
| STEWART, James Robert | Geschäftsführer | Stocklands House Hilton DT11 0DE Blandford Forum Dorset | United Kingdom | British | 1784250004 | |||||
| WOAD, Peter Richard | Geschäftsführer | Easterhall Lagness Road PO20 6QA Runcton Chichester West Sussex | United Kingdom | British | 47566690002 | |||||
| COOK, Michael | Sekretär | 39 Wheeler Avenue Penn HP10 8EB High Wycombe Buckinghamshire | British | 1706720001 | ||||||
| DAWES, Adrian Keith | Sekretär | 28 Aldsworth Avenue Goring By Sea BN12 4XQ Worthing West Sussex | British | 47566670001 | ||||||
| WEBB, David | Sekretär | 53 Bolsover Road BN13 1NR Worthing West Sussex | British | 48680720001 | ||||||
| HINCH, John Frederick | Geschäftsführer | Waters Edge Camp Road SL9 7PE Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 1563050001 | ||||||
| MILLAR, Robert | Geschäftsführer | Brinmaur Crossacres Pyrford Woods GU22 8QS Woking Surrey | British | 1563060005 | ||||||
| RITCHIE, Alexander George Malcolm | Geschäftsführer | Croft Park 6 Stratton Road HP9 1HS Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 30265780002 | |||||
| STEWART, James Robert | Geschäftsführer | 3 Sandringham Road Birkdale PR8 2JZ Southport Merseyside | British | 1784250003 |
Hat BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 27. Sept. 2005 Geliefert am 29. Sept. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land at church lane burstow surrey t/no sy 305274, SY358976 and SY597323. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Mai 2001 Geliefert am 16. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and premises at poling farm arundel west sussex. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Apr. 1996 Geliefert am 15. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortage the propery being f/h land on the south side of tanhouse road oxted tandbridge surrey t/n SY463720, f/h heather farm horsell woking surrey t/n SY46729, f/h land to the north of church lane burstow tandbridge surrey t/n SY567323 and 6 other properties as defined. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Juli 1992 Geliefert am 08. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 | |
Kurze Angaben 18 & 18A frome rd.bradford on avon wilts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1967 Geliefert am 06. Apr. 1967 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,000 | |
Kurze Angaben Sparling mushroom farm, bunstow, M. horley. Surrey title no. Sx 345770 & land comprised in a conveyance dated 1ST april 1967. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BLUE PRINCE MUSHROOMS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0