LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00142234 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
- Einzelhandel per Versandhandel oder über das Internet (47910) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Holdsworth Street BD1 4AH Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LRUK (HOLDINGS) LIMITED | 06. Aug. 2015 | 06. Aug. 2015 |
| REDCATS 2013 LIMITED | 18. Apr. 2013 | 18. Apr. 2013 |
| VERT BAUDET (UK) LIMITED | 07. Aug. 1996 | 07. Aug. 1996 |
| EMPIRE DIRECT LIMITED | 05. Feb. 1990 | 05. Feb. 1990 |
| BRADFORD TEXTILE COMPANY LIMITED(THE) | 25. Nov. 1915 | 25. Nov. 1915 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Beendigung der Bestellung von Michael Paul Truluck als Geschäftsführer am 06. Juli 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Truluck am 14. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Notification of Ginette Moulin as a person with significant control on 10. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of Eric Yvon Courteille as a person with significant control on 10. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Cessation of Nathalie Catherine Balla as a person with significant control on 10. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 11 Seiten | AA | ||
Change of details for Lruk (Holdings) Limited as a person with significant control on 07. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Notification of Nathalie Catherine Balla as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Notification of Eric Yvon Courteille as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 10 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKE, Richard | Geschäftsführer | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 197432680001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Ellen | Sekretär | 6 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | British | 125588610001 | ||||||
| OAKES, Frederick William, Mr. | Sekretär | Tithe House Way HD2 1RD Huddersfield 18 West Yorkshire | British | 2304400001 | ||||||
| ATKINSON, Neil Gareth | Geschäftsführer | The Old Chapel Knaresborough Road Follifoot HG3 1DT Harrogate North Yorkshire | British | 72405410002 | ||||||
| BALLA, Nathalie Catherine | Geschäftsführer | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 179486450001 | |||||
| BAZIN, Pascal | Geschäftsführer | 43 Bis, Avenue De La Marne Tourcoing 59200 France | French | 79523170001 | ||||||
| BOTT, Richard | Geschäftsführer | 49 Henley Avenue WF12 0LN Dewsbury West Yorkshire | British | 49293190001 | ||||||
| CAMPBELL, William James | Geschäftsführer | 2 Heather Gardens Scarcroft LS14 3HU Leeds West Yorkshire | British | 2303760001 | ||||||
| CHESHIRE, Mark | Geschäftsführer | Crossroads Farm Barton Le Willows YO60 7PD York North Yorkshire | United Kingdom | British | 149554830001 | |||||
| DEVE, Francoise Suzanne Marcelle | Geschäftsführer | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 164987810001 | |||||
| FAINTRENY, Eric Robert | Geschäftsführer | 40 Woodvale Crescent BD16 4AL Bingley West Yorkshire | French | 46646970001 | ||||||
| GREEN, Marianne Mckenzie | Geschäftsführer | The Owl House 19 Eagle Row WA13 0PY Lymm Cheshire | British | 118854820001 | ||||||
| HARRIS, Michael John Charles | Geschäftsführer | The Deri Bramhope Manor Moor Road Bramhope LS16 9HJ Leeds West Yorkshire | British | 2307700001 | ||||||
| HAWKER, Michael Leslie | Geschäftsführer | Monkshorn East Boldre SO42 7WT Brockenhurst Hampshire | United Kingdom | British | 114261580001 | |||||
| HEAVISIDES, Henry John | Geschäftsführer | High Clere Villas 20 Margerison Road Ben Rhydding LS29 8QU Ilkley West Yorkshire | British | 57422610004 | ||||||
| HILL, Andrew Ratcliffe | Geschäftsführer | 43 Park Lane Roundhay LS8 2EH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 69640030001 | |||||
| IZARD, Olivier Jacques Georges | Geschäftsführer | Creskeld House Creskeld Lane Arthington LS21 1NU Otley West Yorkshire | French | 87658610002 | ||||||
| JONES, Robert Glyn | Geschäftsführer | 17 Wellington Lodge North Street Winkfield SL4 4TA Windsor Berkshire | British | 116871110002 | ||||||
| JONVILLE, Jean-Luc | Geschäftsführer | 594 Bois D'Achelles Bondues 59910 France | French | 65053520001 | ||||||
| MADELEY, Jane Elisabeth | Geschäftsführer | 102 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | England | British | 105516350002 | |||||
| MCAULAY, Janet | Geschäftsführer | Pavilion House Coldbath Road HG2 0PB Harrogate North Yorkshire | British | 87365970001 | ||||||
| OHLSSON, Hans | Geschäftsführer | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Swedish | 133656790001 | |||||
| PALICH, Peter | Geschäftsführer | 33 Borrowdale Drive BB10 2SG Burnley Lancashire | British | 58037440001 | ||||||
| ROBERTS, Andrew William | Geschäftsführer | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 68177770002 | |||||
| ROCHE, Stephane Marie Marcel | Geschäftsführer | Hilly Ridge Grosvenor Road Headingley Leeds West Yorkshire | French | 116192560002 | ||||||
| SKELSEY, Alistair James | Geschäftsführer | Bluebill Lodge 79 Lower Mill Bank Triangle HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax West Yorkshire | British | 74013420001 | ||||||
| SMITH, Peter James | Geschäftsführer | Melville Margaret Avenue Bardsey LS17 9AT Leeds West Yorkshire | England | British | 17125140001 | |||||
| THOMSON, Alan | Geschäftsführer | Flat 3 Hamilton House, 4 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | United Kingdom | British | 122421940001 | |||||
| TRULUCK, Michael Paul | Geschäftsführer | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 153010590002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Ginette Moulin | 10. Apr. 2018 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Nein | ||||||||||
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: France | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Monsieur Eric Yvon Courteille | 06. Apr. 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: France | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Madame Nathalie Catherine Balla | 06. Apr. 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: Belgium | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Lruk (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Northern ireland deed of charge and assignment | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 12. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the applicable charged monies and to the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and assignment | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 12. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the participant under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to the applicable charged monies; the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Nov. 1990 Geliefert am 11. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement and or facility letter both dated 27/11/90 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A fourth supplemental trust deed | Erstellt am 27. Nov. 1990 Geliefert am 06. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing 6 3/8 per cent debenture stock 1985 90, 8 3/4 per cent debenture stock 1991/96 and 9 1/4 per cent debenture stock 1994/99 created under the various trust deeds and all other moneys due or to become due form the company and/or all or any of the other companies named therein to royal exchange trust company limited as secured by this deed. | |
Kurze Angaben See doc M93 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental trust deed | Erstellt am 06. Juni 1972 Geliefert am 06. Juni 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £4,202,615 outstanding under and secured by a trust deed dated 5TH may 1965 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed for securing debenture stock | Erstellt am 29. Jan. 1969 Geliefert am 05. Feb. 1969 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £2,250,000 including £1,000,000 secured by a trust deed dated 5TH may 1965 | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 05. Mai 1965 Geliefert am 14. Mai 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge without instrument | Erstellt am 31. März 1965 Geliefert am 14. Apr. 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD. | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0