NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)
Überblick
Unternehmensname | NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE) |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00142816 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 150 Aldersgate Street EC1A 4AB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2012 ohne Mitgliederliste | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Jessop House Jessop Avenue Cheltenham Glos GL50 3WG am 13. Dez. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 95 the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1WG am 18. Juli 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2011 | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kevin Victor Mercury am 13. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Efg Secretaries Limited am 13. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sean Coughlan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von George Dunbar Kean als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Sean Andrew Coughlan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julie Collins als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von David John Campbell als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bruce Ferguson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Seaton Place JE4 8YJ St Helier No 1 Jersey Channel Islands |
| 39346320003 | ||||||||||||||
CAMPBELL, David John | Geschäftsführer | Seaton Place JE4 8YJ St Helier No.1 Jersey Channel Islands | Jersey C I | British | Director | 146880920001 | ||||||||||||
KEAN, George Dunbar | Geschäftsführer | Seaton Place JE4 8YJ St Helier No 1 Jersey Channel Islands | Jersey Channel Islands | British | Managing Director | 155930220001 | ||||||||||||
MERCURY, Kevin Victor | Geschäftsführer | Seaton Place JE4 8YJ St Helier No 1 Jersey Channel Islands | Jersey, Channel Islands | British | Trust Company Director | 126471330001 | ||||||||||||
PELICAN SECRETARIES LIMITED | Sekretär | PO BOX 641 1 Seaton Place JE4 8YJ St Helier Jersey | 8067620001 | |||||||||||||||
COLLINS, Julie | Geschäftsführer | 1 Featherstone Close Beaufort Square JE2 6PS St Clement Channel Islands C.I | British | Director | 92003140004 | |||||||||||||
COUGHLAN, Sean Andrew | Geschäftsführer | Seaton Place St Helier JE4 8YJ Jersey No 1 Channel Isles | Jersey Channel Islands | British | Director | 148633860001 | ||||||||||||
FERGUSON, Bruce James | Geschäftsführer | Beauchamp 2 Clos De La Mer La Grande Route Des Sablons JE3 8AL Grouville Jersey Channel Islands | Jersey | British | Director | 157460720001 | ||||||||||||
HARDMAN, Sally Ann | Geschäftsführer | Sentosa La Vieux Jardin Six Roads St Lawrence JE3 1GL Jersey | British | Director | 102582390005 | |||||||||||||
HAWSON, Nathan Daniel | Geschäftsführer | La Petite Route Des Mielles St Brelade JE3 8RB Jersey Ci No 3 Clos De Bosdet Channel Isles | British | Trust Company Director | 130079030001 | |||||||||||||
KREKE, Jorn, Dr | Geschäftsführer | Kabeler Strasse 4 FOREIGN 58 Hagen W Germany | German | Company Director | 24084440001 | |||||||||||||
LAMBERT, Ian | Geschäftsführer | PO BOX 641 1 Seaton Place JE4 8YJ St Helier Jersey | British | Chartered Accountant | 70315270002 | |||||||||||||
LE CHEVALIER, Jennifer | Geschäftsführer | 1 Homelea La Route De La Trinite JE2 4JN St Helier Channel Islands | Jersey | Irish | Director | 150426570001 | ||||||||||||
LE COCQ, Jean Paul | Geschäftsführer | Vimy Cottage La Rue Rouge Cul JE3 1GF St Lawrence Jersey Je3 1gf Ci | British | Director | 92003650001 | |||||||||||||
LORAINE, George Sharon | Geschäftsführer | La Bise La Rue Des Platons JE3 5AA Trinity Jersey | Channel Islands | British | Executive Director | 87869320001 | ||||||||||||
MAGOR, Philip | Geschäftsführer | North Standen House RG17 0QZ Hungerford Berkshire | British | Company Director | 2909540007 | |||||||||||||
MOCK, Arno Hubert | Geschäftsführer | Haus Rodehorst 4236 Hamminkeln 5 Wetherbruch W Germany | German | Company Director | 24084430001 | |||||||||||||
NEWBALD, Peter Edward Francis | Geschäftsführer | PO BOX 641 No 1 Seaton Place JE4 8YJ St Helier Jersey Channel Islands | British | Accountant | 69223300001 | |||||||||||||
PROSSER, Richard John Stobart | Geschäftsführer | 641 PO BOX No 1 Seaton Place JE4 8YJ Jersey Channel Islands | British | Chartered Accountant | 66462900001 | |||||||||||||
VAN DE GIESSEN, Maarten Willem | Geschäftsführer | Heemraadissingel 261 3023 C E Rotterdam Holland | Dutch | Company Director | 17856290002 | |||||||||||||
WEIR, Paul | Geschäftsführer | Le Pont Close Rue De St Clement St Clement JE2 6JL Jersey Rivendell Channel Islands | Jersey Channel Islands | British | Director | 140355000001 | ||||||||||||
WINEARLS, Dudley Nicholas Good | Geschäftsführer | Highland La Rue Du Sud St Ouen JE3 2BF Jersey Channel Islands | British | Director | 109802000001 |
Hat NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE) Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Share mortgage and assignment | Erstellt am 11. Juni 1997 Geliefert am 23. Juni 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each finance document and any hedging arrangement (as therein defined) | |
Kurze Angaben First fixed charge all right title and interest in all dividends paid or payable on all or any of the charged shares being: 1,243,450 shares in williamson financial services LTD the company being the registered holder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of confirmation | Erstellt am 23. Apr. 1990 Geliefert am 10. Mai 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the namdang tea company limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 16/11/87 as amended 17/11/89 and 29/1/90 or any documents referred to therein and this deed | |
Kurze Angaben Charge over a blocked account no 81043 (see doc M607C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of confirmation | Erstellt am 23. Apr. 1990 Geliefert am 10. Mai 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to beome due from the namdang tea company limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 16/11/87 as amended 17/11/89 and 29/1/90 or any documents referred to therein and this deed | |
Kurze Angaben All right title and interest in dividends in respect of shares, being 956,500 shares of 10 rupees each in namdang tea co (india) limited (see doc M608C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security assignment | Erstellt am 19. Nov. 1987 Geliefert am 01. Dez. 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All amounts which are or may become payable 9IN respect of principal interst or otherwise howsoever) by williamson maknam limited under a loan agreement (the "loan agreement") dated 16/11/1987 made between williamson maknam limited as borrower and the bank or under any of the documents referred to therein to which williamson maknam limited is a party. The loan agreement provides for the advance by the bank to williamson maknam limited of the us dollar equivalent of £20,700,000 in two instalmemnts. | |
Kurze Angaben All the company's right title & interest in and to all and dividends (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security assignment | Erstellt am 19. Nov. 1987 Geliefert am 01. Dez. 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All amounts which are or may become payable (inrespect of principal, interest or otherwise howsoever) by williamson maknam limited under a loan agreement (the "loan agreement") dated 16 november 1987 made between williamson maknam limited as borrower and the bank or under any of the documents referred to therein to which williamson maknam limited is a party. The loan agreement oprovides for the advance by the bank to williamson maknam limited of the us dollar equivalent of £20,700,000 in two instalments. | |
Kurze Angaben Charge over a blocked account of the company with the bank (account no 85043) (a) the monies deposited in such blocked account shall not be repayable by the bank unless the amounts secured by the mortgage shall have been paid or discharged in full to the satisfion of the bank; and (b) following and event of default (as defined in the loan agreement) the bank ,ay, inter alia, set off or transfer any sum standing to the credit of the blocked account aforesaid in or towards the satisfaction of any of the amounts secured by the mortgage as the bank thinks fit. (See doc 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter addressed by the company to the manager national and grindlays bank limited, calcutta | Erstellt am 28. Juli 1972 Geliefert am 15. Sept. 1972 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The charge was created for the purpose of increasing up to an aggregate limit of R. 75,00,000 (rupees seventy five lakhs) the amount secured by a letter of hypothecation dated 30TH jan 1953 and letter supplemental thereto, whether such indebtedness is incurred by way of overdraft and/or packing credit loan being an increase of rupees 45,00,000. was registered pursuant to sec 95 company act 1948. | |
Kurze Angaben Tea hypothcated to national and grindlays bank limited by the said letter of hypothecation dated 30/01/53 and supplemental letters of hypothecation all as referred to in the second letter of hypothecation dated 28/06/72. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of hypothecation | Erstellt am 26. Okt. 1967 Geliefert am 20. Nov. 1967 | Ausstehend | Gesicherter Betrag Executed in calcutta supplemental to letter of hypothecation no SF2 dated 30/01/53 supplemental letters of hypothecation dated 06/01/59, 16/01/61 and 20/03/62 for increasing the limit of amount secured by letter of hypothecation no.SF2 dated 30/01/53 and supplemental letters of hypothecation dated 06/01/59,16/01/61 and 20/03/62 from rs 20,00,000 (rupees twenty lacs) bto rs 30,00,000 (rupees thirty lacs) (sterling equivalent £142,857.2.10.0) | |
Kurze Angaben Tea hypothecated to the bank by prior letters of hypothecation dated 30/001/53, 06/01/59, 16/01/61 and 20/03/62. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of hypothecation | Erstellt am 20. März 1962 Geliefert am 04. Apr. 1962 | Ausstehend | Gesicherter Betrag For increasing the limited of the amount secured by three charges dated 30/01/53 06/01/59 and 16/01/61 from rupees 15 lacs to rupees 20 lacs | |
Kurze Angaben Stocks of tea hypothecated to the bank by prior letter of hypothecation dated 30/01/53, 06/01/59 and 16/01/61. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental letter of hypothecation being a charge created outside the united kingdom and comprising property situated outside the united kingdom | Erstellt am 16. Jan. 1961 Geliefert am 31. Jan. 1961 | Ausstehend | Gesicherter Betrag For increasing the limit of the amount secured by two charges respectively dated 30/01/53 and 06/01/59 from rs 10,00,000 to a new limit of rs 15,00,000 the equivalent of £112,500 at exchange 1@6D per rupee. | |
Kurze Angaben All tea manufactured ior in process of manufature (including the green leaf tea after plucking) from time to time at or from the tea gardens of the company, together with all export quota rights to which the company may be entitled under indian tea control law, together with the sale proceeds of the said tea and the said quota rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental letter of hypothecation | Erstellt am 06. Jan. 1959 Geliefert am 23. Jan. 1959 | Ausstehend | Gesicherter Betrag For increasing the limit of the amount secured by a charge dated 30/01/53 from rupees 5 lacs to rupees 10 lacs | |
Kurze Angaben All tea manufactured in companys tea gardens (see doc 109 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of hypothecation being a charge created outside the U.K. and comprising property situate outside tye united kingdom | Erstellt am 30. Jan. 1953 Geliefert am 14. Feb. 1953 | Ausstehend | Gesicherter Betrag Sums not exceeding rs 5,00,000 equivalent of £37,500 at exchange 1/6 d per rupee | |
Kurze Angaben All tea manufactured or in prrocess of manufacture (including on green tea leaf after plucking) from time to time at or from namdang tea estate and the bogapani tea estate, being the two tea gardens of the company, together with all export quota rights to which the company may be entitled under the indian tea control act viii of 1938 or any statutory modification or re-anactment thereof in respect of the said tea gardens, together with the sale proceeds of the said tea and the said quota rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE) Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0