NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)

NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00142816
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 Seiten4.71

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2012 ohne Mitgliederliste

    15 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Dez. 2012

    Kapitalaufstellung am 20. Dez. 2012

    • Kapital: GBP 490,000.5
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Jessop House Jessop Avenue Cheltenham Glos GL50 3WG am 13. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 03. Dez. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    4 Seiten4.70

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2012

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 95 the Promenade Cheltenham Gloucestershire GL50 1WG am 18. Juli 2012

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2011

    15 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2011

    8 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2010

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Kevin Victor Mercury am 13. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Efg Secretaries Limited am 13. Dez. 2010

    2 SeitenCH04

    Beendigung der Bestellung von Sean Coughlan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von George Dunbar Kean als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Sean Andrew Coughlan als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Julie Collins als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Ernennung von David John Campbell als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Bruce Ferguson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE)?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EFG SECRETARIES LIMITED
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No 1
    Jersey
    Channel Islands
    Sekretär
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No 1
    Jersey
    Channel Islands
    RechtsformEFG SECRETARIES LIMITED
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageJERSEY
    Registrierungsnummer56356
    39346320003
    CAMPBELL, David John
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No.1
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No.1
    Jersey
    Channel Islands
    Jersey C IBritishDirector146880920001
    KEAN, George Dunbar
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No 1
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No 1
    Jersey
    Channel Islands
    Jersey Channel IslandsBritishManaging Director155930220001
    MERCURY, Kevin Victor
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No 1
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    No 1
    Jersey
    Channel Islands
    Jersey, Channel IslandsBritishTrust Company Director126471330001
    PELICAN SECRETARIES LIMITED
    PO BOX 641
    1 Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    Jersey
    Sekretär
    PO BOX 641
    1 Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    Jersey
    8067620001
    COLLINS, Julie
    1 Featherstone Close
    Beaufort Square
    JE2 6PS St Clement
    Channel Islands
    C.I
    Geschäftsführer
    1 Featherstone Close
    Beaufort Square
    JE2 6PS St Clement
    Channel Islands
    C.I
    BritishDirector92003140004
    COUGHLAN, Sean Andrew
    Seaton Place
    St Helier
    JE4 8YJ Jersey
    No 1
    Channel Isles
    Geschäftsführer
    Seaton Place
    St Helier
    JE4 8YJ Jersey
    No 1
    Channel Isles
    Jersey Channel IslandsBritishDirector148633860001
    FERGUSON, Bruce James
    Beauchamp 2 Clos De La Mer
    La Grande Route Des Sablons
    JE3 8AL Grouville Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Beauchamp 2 Clos De La Mer
    La Grande Route Des Sablons
    JE3 8AL Grouville Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritishDirector157460720001
    HARDMAN, Sally Ann
    Sentosa La Vieux Jardin
    Six Roads St Lawrence
    JE3 1GL Jersey
    Geschäftsführer
    Sentosa La Vieux Jardin
    Six Roads St Lawrence
    JE3 1GL Jersey
    BritishDirector102582390005
    HAWSON, Nathan Daniel
    La Petite Route Des Mielles
    St Brelade
    JE3 8RB Jersey Ci
    No 3 Clos De Bosdet
    Channel Isles
    Geschäftsführer
    La Petite Route Des Mielles
    St Brelade
    JE3 8RB Jersey Ci
    No 3 Clos De Bosdet
    Channel Isles
    BritishTrust Company Director130079030001
    KREKE, Jorn, Dr
    Kabeler Strasse 4
    FOREIGN 58 Hagen
    W Germany
    Geschäftsführer
    Kabeler Strasse 4
    FOREIGN 58 Hagen
    W Germany
    GermanCompany Director24084440001
    LAMBERT, Ian
    PO BOX 641
    1 Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    Jersey
    Geschäftsführer
    PO BOX 641
    1 Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    Jersey
    BritishChartered Accountant70315270002
    LE CHEVALIER, Jennifer
    1 Homelea
    La Route De La Trinite
    JE2 4JN St Helier
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    1 Homelea
    La Route De La Trinite
    JE2 4JN St Helier
    Channel Islands
    JerseyIrishDirector150426570001
    LE COCQ, Jean Paul
    Vimy Cottage
    La Rue Rouge Cul
    JE3 1GF St Lawrence
    Jersey Je3 1gf
    Ci
    Geschäftsführer
    Vimy Cottage
    La Rue Rouge Cul
    JE3 1GF St Lawrence
    Jersey Je3 1gf
    Ci
    BritishDirector92003650001
    LORAINE, George Sharon
    La Bise
    La Rue Des Platons
    JE3 5AA Trinity
    Jersey
    Geschäftsführer
    La Bise
    La Rue Des Platons
    JE3 5AA Trinity
    Jersey
    Channel IslandsBritishExecutive Director87869320001
    MAGOR, Philip
    North Standen House
    RG17 0QZ Hungerford
    Berkshire
    Geschäftsführer
    North Standen House
    RG17 0QZ Hungerford
    Berkshire
    BritishCompany Director2909540007
    MOCK, Arno Hubert
    Haus Rodehorst
    4236 Hamminkeln 5
    Wetherbruch
    W Germany
    Geschäftsführer
    Haus Rodehorst
    4236 Hamminkeln 5
    Wetherbruch
    W Germany
    GermanCompany Director24084430001
    NEWBALD, Peter Edward Francis
    PO BOX 641
    No 1 Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    PO BOX 641
    No 1 Seaton Place
    JE4 8YJ St Helier
    Jersey
    Channel Islands
    BritishAccountant69223300001
    PROSSER, Richard John Stobart
    641 PO BOX
    No 1 Seaton Place
    JE4 8YJ Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    641 PO BOX
    No 1 Seaton Place
    JE4 8YJ Jersey
    Channel Islands
    BritishChartered Accountant66462900001
    VAN DE GIESSEN, Maarten Willem
    Heemraadissingel 261
    3023 C E Rotterdam
    Holland
    Geschäftsführer
    Heemraadissingel 261
    3023 C E Rotterdam
    Holland
    DutchCompany Director17856290002
    WEIR, Paul
    Le Pont Close Rue De St Clement
    St Clement
    JE2 6JL Jersey
    Rivendell
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Le Pont Close Rue De St Clement
    St Clement
    JE2 6JL Jersey
    Rivendell
    Channel Islands
    Jersey Channel IslandsBritishDirector140355000001
    WINEARLS, Dudley Nicholas Good
    Highland
    La Rue Du Sud St Ouen
    JE3 2BF Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Highland
    La Rue Du Sud St Ouen
    JE3 2BF Jersey
    Channel Islands
    BritishDirector109802000001

    Hat NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE) Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Share mortgage and assignment
    Erstellt am 11. Juni 1997
    Geliefert am 23. Juni 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each finance document and any hedging arrangement (as therein defined)
    Kurze Angaben
    First fixed charge all right title and interest in all dividends paid or payable on all or any of the charged shares being: 1,243,450 shares in williamson financial services LTD the company being the registered holder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 23. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Letter of confirmation
    Erstellt am 23. Apr. 1990
    Geliefert am 10. Mai 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the namdang tea company limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 16/11/87 as amended 17/11/89 and 29/1/90 or any documents referred to therein and this deed
    Kurze Angaben
    Charge over a blocked account no 81043 (see doc M607C for full details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    Letter of confirmation
    Erstellt am 23. Apr. 1990
    Geliefert am 10. Mai 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to beome due from the namdang tea company limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 16/11/87 as amended 17/11/89 and 29/1/90 or any documents referred to therein and this deed
    Kurze Angaben
    All right title and interest in dividends in respect of shares, being 956,500 shares of 10 rupees each in namdang tea co (india) limited (see doc M608C for full details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    Security assignment
    Erstellt am 19. Nov. 1987
    Geliefert am 01. Dez. 1987
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All amounts which are or may become payable 9IN respect of principal interst or otherwise howsoever) by williamson maknam limited under a loan agreement (the "loan agreement") dated 16/11/1987 made between williamson maknam limited as borrower and the bank or under any of the documents referred to therein to which williamson maknam limited is a party. The loan agreement provides for the advance by the bank to williamson maknam limited of the us dollar equivalent of £20,700,000 in two instalmemnts.
    Kurze Angaben
    All the company's right title & interest in and to all and dividends (please see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    Security assignment
    Erstellt am 19. Nov. 1987
    Geliefert am 01. Dez. 1987
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All amounts which are or may become payable (inrespect of principal, interest or otherwise howsoever) by williamson maknam limited under a loan agreement (the "loan agreement") dated 16 november 1987 made between williamson maknam limited as borrower and the bank or under any of the documents referred to therein to which williamson maknam limited is a party. The loan agreement oprovides for the advance by the bank to williamson maknam limited of the us dollar equivalent of £20,700,000 in two instalments.
    Kurze Angaben
    Charge over a blocked account of the company with the bank (account no 85043) (a) the monies deposited in such blocked account shall not be repayable by the bank unless the amounts secured by the mortgage shall have been paid or discharged in full to the satisfion of the bank; and (b) following and event of default (as defined in the loan agreement) the bank ,ay, inter alia, set off or transfer any sum standing to the credit of the blocked account aforesaid in or towards the satisfaction of any of the amounts secured by the mortgage as the bank thinks fit. (See doc 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • American Express Bank LTD
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    Letter addressed by the company to the manager national and grindlays bank limited, calcutta
    Erstellt am 28. Juli 1972
    Geliefert am 15. Sept. 1972
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The charge was created for the purpose of increasing up to an aggregate limit of R. 75,00,000 (rupees seventy five lakhs) the amount secured by a letter of hypothecation dated 30TH jan 1953 and letter supplemental thereto, whether such indebtedness is incurred by way of overdraft and/or packing credit loan being an increase of rupees 45,00,000. was registered pursuant to sec 95 company act 1948.
    Kurze Angaben
    Tea hypothcated to national and grindlays bank limited by the said letter of hypothecation dated 30/01/53 and supplemental letters of hypothecation all as referred to in the second letter of hypothecation dated 28/06/72.
    Berechtigte Personen
    • National and Grindlays Bank (Calcutta, India)
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1972Registrierung einer Belastung
    Letter of hypothecation
    Erstellt am 26. Okt. 1967
    Geliefert am 20. Nov. 1967
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Executed in calcutta supplemental to letter of hypothecation no SF2 dated 30/01/53 supplemental letters of hypothecation dated 06/01/59, 16/01/61 and 20/03/62 for increasing the limit of amount secured by letter of hypothecation no.SF2 dated 30/01/53 and supplemental letters of hypothecation dated 06/01/59,16/01/61 and 20/03/62 from rs 20,00,000 (rupees twenty lacs) bto rs 30,00,000 (rupees thirty lacs) (sterling equivalent £142,857.2.10.0)
    Kurze Angaben
    Tea hypothecated to the bank by prior letters of hypothecation dated 30/001/53, 06/01/59, 16/01/61 and 20/03/62.
    Berechtigte Personen
    • National and Grindlays Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1967Registrierung einer Belastung
    Letter of hypothecation
    Erstellt am 20. März 1962
    Geliefert am 04. Apr. 1962
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    For increasing the limited of the amount secured by three charges dated 30/01/53 06/01/59 and 16/01/61 from rupees 15 lacs to rupees 20 lacs
    Kurze Angaben
    Stocks of tea hypothecated to the bank by prior letter of hypothecation dated 30/01/53, 06/01/59 and 16/01/61.
    Berechtigte Personen
    • National and Grindlays Bank Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1962Registrierung einer Belastung
    Supplemental letter of hypothecation being a charge created outside the united kingdom and comprising property situated outside the united kingdom
    Erstellt am 16. Jan. 1961
    Geliefert am 31. Jan. 1961
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    For increasing the limit of the amount secured by two charges respectively dated 30/01/53 and 06/01/59 from rs 10,00,000 to a new limit of rs 15,00,000 the equivalent of £112,500 at exchange 1@6D per rupee.
    Kurze Angaben
    All tea manufactured ior in process of manufature (including the green leaf tea after plucking) from time to time at or from the tea gardens of the company, together with all export quota rights to which the company may be entitled under indian tea control law, together with the sale proceeds of the said tea and the said quota rights.
    Berechtigte Personen
    • National Grindlays Bank Limited
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1961Registrierung einer Belastung
    Supplemental letter of hypothecation
    Erstellt am 06. Jan. 1959
    Geliefert am 23. Jan. 1959
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    For increasing the limit of the amount secured by a charge dated 30/01/53 from rupees 5 lacs to rupees 10 lacs
    Kurze Angaben
    All tea manufactured in companys tea gardens (see doc 109 for details).
    Berechtigte Personen
    • National and Grindlays Bank Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1959Registrierung einer Belastung
    Letter of hypothecation being a charge created outside the U.K. and comprising property situate outside tye united kingdom
    Erstellt am 30. Jan. 1953
    Geliefert am 14. Feb. 1953
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Sums not exceeding rs 5,00,000 equivalent of £37,500 at exchange 1/6 d per rupee
    Kurze Angaben
    All tea manufactured or in prrocess of manufacture (including on green tea leaf after plucking) from time to time at or from namdang tea estate and the bogapani tea estate, being the two tea gardens of the company, together with all export quota rights to which the company may be entitled under the indian tea control act viii of 1938 or any statutory modification or re-anactment thereof in respect of the said tea gardens, together with the sale proceeds of the said tea and the said quota rights.
    Berechtigte Personen
    • The National Bank of India Limited
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1953Registrierung einer Belastung

    Hat NAMDANG TEA COMPANY,LIMITED(THE) Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Apr. 2014Aufgelöst am
    03. Dez. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0