TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
Unternehmensnummer | 00153088 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TELECITYREDBUS LIMITED | 16. Jan. 2007 | 16. Jan. 2007 |
REDBUS INTERHOUSE LIMITED | 12. Mai 2006 | 12. Mai 2006 |
REDBUS INTERHOUSE PLC | 05. Apr. 2000 | 05. Apr. 2000 |
HORACE SMALL APPAREL PLC | 07. Mai 1993 | 07. Mai 1993 |
UNITED UNIFORM SERVICES PLC | 23. Mai 1990 | 23. Mai 1990 |
AMERCOEUR ENERGY PLC | 12. Juni 1987 | 12. Juni 1987 |
DACIA PETROLEUM PLC | 28. Mai 1982 | 28. Mai 1982 |
DACIA ROMANO PETROLEUM SYNDICATELIMITED(THE) | 11. Feb. 1919 | 11. Feb. 1919 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2018 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2019 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Confirmation and transfer of assets and liabilities | 1 Seiten | MISC | ||||||||||||||
Verschiedenes Notification from overseas registry of completion of cross border merger | 1 Seiten | MISC | ||||||||||||||
Verschiedenes CB01 - notice of a cross border merger | 169 Seiten | MISC | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 28 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 37 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 001530880016 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Phillip Leo Konieczny am 01. März 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Phillip Leo Konieczny als Direktor am 30. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Crowther als Geschäftsführer am 30. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 001530880015 | 1 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 09. Sept. 2016
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 31 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Sept. 2016
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 31 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 001530880015 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 01. Juli 2016
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUNTER, Anthony George | Sekretär | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | 66859190003 | ||||||
KONIECZNY, Phillip Leo | Geschäftsführer | Amstelplein 1 1096 Ha Rambrandt Tower 7th Floor Amsterdam Netherlands | Netherlands | American | Vice President Finance, Emea | 204302590002 | ||||
SCHWARTZ, Eric Charles | Geschäftsführer | Amstelplein 1 1096 Ha Rambrandt Tower 7th Floor Amsterdam Netherlands | Netherlands | American | Company Director | 204409940001 | ||||
DUMOND, Paul George | Sekretär | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | 266200001 | ||||||
BALME, Anthony David Nettleon | Geschäftsführer | 9 Broad Street SO24 9AR Alresford Hampshire | United Kingdom | British | Wool Broker | 155915350002 | ||||
BENDTSEN, Bo Ladegaard | Geschäftsführer | The Belchers Tower 2 25/F Apartment H 89 Pokfulam Road Hong Kong | Danish | Internet | 69680320007 | |||||
BLIGH, Alexander Marc | Geschäftsführer | 74a Saltram Crescent Maida Vale W9 3HS London | British | Company Director | 48718950001 | |||||
COUPLAND, Robert Andrew | Geschäftsführer | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 138313750002 | ||||
CROWTHER, David | Geschäftsführer | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 184391050001 | ||||
DUMOND, Paul George | Geschäftsführer | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 266200001 | ||||
EBERLE, William Denman | Geschäftsführer | 94 Elm Street Concord Massachusettes 01742 Usa | Usa | Business Executive | 29220020002 | |||||
FRY, Carl Duncan | Geschäftsführer | 19 Ennerdale Road TW9 3PG Richmond Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 71701130002 | ||||
GATES, Robert Wayne | Geschäftsführer | 4016 Lynnwood Court Franklin Tennessee Usa | American | Corporate Executive | 65482370001 | |||||
GRACE, Oliver Russell | Geschäftsführer | 32 Wellington Road Locust Valley New York Usa | American | Investor | 47662600001 | |||||
HAGEMAN, Wilhelmus Theresia Jozef | Geschäftsführer | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | Netherlands | Dutch | Chief Financial Officer | 190923150001 | ||||
KEITH, John Colin | Geschäftsführer | 1 Farwell Lane Greenwich 06831 Connecticut Usa | British | Private Investor | 34467660001 | |||||
MCARTHUR-MUSCROFT, Brian David | Geschäftsführer | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | England | British | Chief Financial Officer | 120812990001 | ||||
MILLS, Christopher Harwood Bernard | Geschäftsführer | Cliveden Place SW1W 8LA London 10 | United Kingdom | British | Investment Banker | 35557050001 | ||||
MORTON, Rupert James Philip | Geschäftsführer | 42 Eaton Terrace SW1W 8TY London | United Kingdom | British | Banker | 43925440002 | ||||
NEAL, Kevin Terence | Geschäftsführer | 17 Cripsey Avenue CM5 0AT Ongar Essex | British | Company Director | 61304890001 | |||||
PATERSON, David Francis Joseph | Geschäftsführer | 5a Greenview Gardens 125 Robinson Road Hong Kong Hong Kong | Kong Kong | British | Company Director | 34687880002 | ||||
PORTER, John Robert | Geschäftsführer | 34 Rue Concorde 1050 Brussels Belgium | British | Company Director | 91642510001 | |||||
RIABTSOV, Sergei | Geschäftsführer | 60/2-118, Volokolamskoye 125424 Moscow 123367 Russia | Russian | Chief Investment Officer | 95137570001 | |||||
SIMKIN, Anthony Nicholas | Geschäftsführer | 10 Riverview Grove Chiswick W4 3QJ London | England | British | Company Director | 50706460004 | ||||
SMALL, Douglas Alan | Geschäftsführer | 404 West Hillwood Drive FOREIGN Nashville Tennessee 37205 Usa | Usa | Corporate Executive | 27907090001 | |||||
SMALL, Irvin Leon | Geschäftsführer | 333 Vaughn Road Nashville Tennessee 37221 Usa | Usa | Corporate Executive | 27907100001 | |||||
STANFORD, Clifford Martin | Geschäftsführer | Ave De La Floride 47 1180 Bruxelles Belgium | British | Company Director | 62121110004 | |||||
TOBIN, Michael | Geschäftsführer | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | England | British | Chief Executive | 82337350003 | ||||
VACEK JNR, Richard Bernard | Geschäftsführer | 925 Ashford Court Brentwood 37027 Tennessee Usa | American | Corporate Executive | 65482440001 | |||||
VAUGHAN-LEE, Mark Andrew | Geschäftsführer | Ashcombe Farm Cottage Tollard Royal SP5 5QG Salisbury Wiltshire | British | Company Director | 65097930002 | |||||
WADCOCK, Trevor Anthony | Geschäftsführer | 89 Victoria Road OX2 7QG Oxford | British | Company Director | 79133200002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telecitygroup Investments Limited | 06. Apr. 2016 | 107 Hammersmith Road W14 0QH London Masters House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 23. März 2016 Geliefert am 04. Apr. 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung N/A. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 23. März 2016 Geliefert am 04. Apr. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 23. März 2016 Geliefert am 04. Apr. 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Leasehold properties: decks 10-11 (inclusive) lawn house close car park, lawn house close, east india dock, london E14 9YQ. (LON3) sovereign house, 227 marsh wall, dollar bay, docklands, london, E14 (LON3) lower ground floor of car park, marsh wall, sites 4C and 4E, dollar bay, west india dock, tower hamlets, london, E14 (LON3) 4TH floor exchange tower, 2 harbour exchange square, london, E14 (HO1) 215 marsh wall, london, E14 9FJ (meridian gate)(LON4). Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 30. Jan. 2015 Geliefert am 04. Feb. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The intellectual property registered under tm number 007603269 jurisdiction/apparent status: eu; classes: 35, 37, 38 and 42; marktext: telecitygroup 'where connectivity meets...'. Please see image for details of furhter intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 06. Sept. 2013 Geliefert am 14. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Group debenture | Erstellt am 02. Nov. 2012 Geliefert am 08. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge to a debenture dated 9 february 2010 and | Erstellt am 09. Aug. 2010 Geliefert am 12. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge to a debenture dated 9 february 2010 and | Erstellt am 26. Mai 2010 Geliefert am 29. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge the intellectual property, see image for full details fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Group debenture | Erstellt am 09. Feb. 2010 Geliefert am 18. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Group debenture | Erstellt am 30. Okt. 2007 Geliefert am 10. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Group debenture | Erstellt am 18. Sept. 2006 Geliefert am 30. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A share pledge | Erstellt am 07. Aug. 2006 Geliefert am 25. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to (a) all present and future, issued and outstanding shares of capital stock or other equity or investment securities of or partnership membership or joint venture interests in each subsidiary (collectively the pledged shares) (b) all present and future increases profits combinations reclassifications and substitutes and replacements for all or part of the foregoing collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A share pledge | Erstellt am 13. Juni 2006 Geliefert am 26. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Over the shares and any rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security accession deed | Erstellt am 13. Juni 2006 Geliefert am 26. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its interest in the material land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 07. Feb. 2006 Geliefert am 22. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re redbus interhouse PLC euro business premium account, account number 83811444. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit | Erstellt am 21. Dez. 2000 Geliefert am 22. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the cash deposit being all sums from time to time standing to the credit of the deposit account being interest bearing deposit account with the bank (sort code 20-65-63) designated as "barclays bank PLC re;-redbus interhouse PLC" account number 50135054 or such other account as the bank in it's discretion require. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chargee over cash deposit | Erstellt am 12. Dez. 2000 Geliefert am 13. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the counter-indemnity of 26 september 2000 (as defined) | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all the company's rights title and benefit in the cash deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0