STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00163668 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 399 Strand London WC2R 0LX |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Beendigung der Bestellung von Kevin Fitzpatrick als Geschäftsführer am 02. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Tom Pickford als Geschäftsführer am 02. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Ernennung von Mr Kevin Fitzpatrick als Direktor am 01. Aug. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Tom Pickford als Direktor am 01. Aug. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Tom Pickford als Geschäftsführer am 01. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Kevin Fitzpatrick als Geschäftsführer am 01. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Kevin Fitzpatrick als Sekretär am 01. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Tom Pickford am 01. Jan. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Beendigung der Bestellung von Graham Elliott Shircore als Geschäftsführer am 01. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Tom Pickford als Direktor am 01. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Kevin Fitzpatrick als Sekretär am 15. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr Kevin Fitzpatrick als Direktor am 15. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony Michael Gee als Geschäftsführer am 15. Nov. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony Michael Gee als Sekretär am 15. Nov. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Kenneth Purkis als Geschäftsführer am 02. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Graham Elliott Shircore als Direktor am 02. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Anthony Michael Gee als Sekretär am 02. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITZPATRICK, Kevin | Sekretär | 399 Strand London WC2R 0LX | 289605610001 | |||||||
| GEE, Anthony Michael | Sekretär | 399 Strand London WC2R 0LX | 276052100001 | |||||||
| PANDIT, Arvind Jivanlal | Sekretär | 33 Oak Vale West End SO30 3SE Southampton Hampshire | British | 4791360001 | ||||||
| PURKIS, Richard Kenneth | Sekretär | Chiswell House Shernden Lane Marsh Green TN8 5PR Edenbridge Kent | British | 50467140001 | ||||||
| CROCKER, David John | Geschäftsführer | 2 Clover Way Paddock Wood TN12 6BQ Tonbridge Kent | British | 23422730002 | ||||||
| DUNNINGHAM, Timothy | Geschäftsführer | Avranches Farm La Ruette D`Avranches St Lawrence JE3 1GJ Jersey Channel Islands | Jersey | British | 58978030001 | |||||
| ELLIOTT SHIRCORE, Graham | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | 276026200001 | |||||
| FITZPATRICK, Kevin | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | Irish | 117212260001 | |||||
| FITZPATRICK, Kevin | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | Irish | 117212260001 | |||||
| FRASER, Paul Ian | Geschäftsführer | 222 Cheltenham Road BS6 5QU Bristol Avon | British | 5342100001 | ||||||
| GEE, Anthony Michael | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | United Kingdom | British | 181780820001 | |||||
| GRODECKI, Antony Richard Jan | Geschäftsführer | The Maltings Hopgarden Lane TN13 1PX Sevenoaks Kent | British | 42800860002 | ||||||
| HALL, Michael Robert Montague | Geschäftsführer | Doyle Court Doyle Road St Peter Port GY1 1RD Guernsey Channel Islands | British | 74643910002 | ||||||
| HEDDLE, Keith Andrew Millar | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | 164474410001 | |||||
| HENLEY, Mark David | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | 52315890005 | |||||
| MCQUILLAN, Anthony Michael | Geschäftsführer | Church Lodge Station Road Wrington BS40 5LG Bristol Avon | Irish | 22631310001 | ||||||
| PANDIT, Arvind Jivanlal | Geschäftsführer | 33 Oak Vale West End SO30 3SE Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 4791360001 | |||||
| PICKFORD, Tom | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | 303763600001 | |||||
| PICKFORD, Tom | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | 303764130002 | |||||
| PURKIS, Richard Kenneth | Geschäftsführer | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | 50467140001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Gibbons Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Strand WC2R 0LX London 399 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 15. Okt. 1993 Geliefert am 27. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Sept. 1989 Geliefert am 22. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies name therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture deed | Erstellt am 11. Juni 1986 Geliefert am 17. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or the "companies" (as defined) to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 29. Okt. 1984 Geliefert am 16. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee debenture | Erstellt am 25. Juni 1982 Geliefert am 09. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies names therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Juni 1982 Geliefert am 12. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 1750000 and all other monies due or to become due from stanley gibbons international limited to the chargee under one terms of a share sale agreement dtd 25.6.1982 | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwills, debts uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery (see doc M113 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0